LIVING SPACE (UK) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LIVING SPACE (UK) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02627932 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LIVING SPACE (UK) LIMITED?
- Herstellung von Metallkonstruktionen und Teilen von Konstruktionen (25110) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich LIVING SPACE (UK) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Recovery House 15-17 Roebuck Road Hainault Business Park IG6 3TU Ilford |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LIVING SPACE (UK) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SOLARGRO PRODUCTS LIMITED | 02. Dez. 1994 | 02. Dez. 1994 |
STEREON FABRICATIONS LIMITED | 13. Feb. 1992 | 13. Feb. 1992 |
SOLAR DIRECT LIMITED | 18. Juli 1991 | 18. Juli 1991 |
ECHODREAM LIMITED | 10. Juli 1991 | 10. Juli 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LIVING SPACE (UK) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LIVING SPACE (UK) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 14 Seiten | LIQ14 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 13 Earlstrees Court Earlstrees Industrial Estate Corby NN17 4AX England zum Recovery House 15-17 Roebuck Road Hainault Business Park Ilford IG6 3TU am 22. Juni 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 8 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 026279320008 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 026279320007 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Unit 5 Edison Courtyard, Brunel Road Earlstrees Industrial Estate Corby NN17 4LS England zum Unit 13 Earlstrees Court Earlstrees Industrial Estate Corby NN17 4AX am 28. Sept. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 12a Earlstrees Road Earlstrees Industrial Estate Corby Northamptonshire NN17 4AZ zum Unit 5 Edison Courtyard, Brunel Road Earlstrees Industrial Estate Corby NN17 4LS am 10. Apr. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Juli 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2013 bis 30. Juni 2014 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Frederick William Henry Lucas am 21. Jan. 2013 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Frederick William Henry Lucas am 21. Jan. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LIVING SPACE (UK) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCAS, Frederick William Henry | Sekretär | Digswell Lane AL6 0SN Welwyn Millside Digswell Lane Hertfordshire England | British | Co Director | 72637180001 | |||||
LUCAS, Andrew, Mr. | Geschäftsführer | Leicester Road LE7 9AQ Billesdon 36 | England | British | Director | 61728490004 | ||||
LUCAS, Frederick William Henry | Geschäftsführer | Digswell Lane AL6 0SN Welwyn Millside Digswell Lane Hertfordshire England | England | British | Entrepreneur | 72637180001 | ||||
DAVE, Kishor | Sekretär | 5 Rosewood Avenue UB6 7QP Greenford Middlesex | British | 24401600001 | ||||||
GARNER, Peter | Sekretär | 5 Saint Wilfrids Close Kibworth LE8 0PY Leicester Leicestershire | British | 67440820001 | ||||||
LUCAS, Andrew | Sekretär | 57 Stoneygate Road LE2 2BP Leicester | British | Marketing | 61728490001 | |||||
CCS SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 120 East Road N1 6AA London | 900001720001 | |||||||
CORCORAN, Michael Hugh | Geschäftsführer | 45 Beech Way Wheathampstead AL4 8LY St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 11521980001 | ||||
CORCORAN, Michael Hugh | Geschäftsführer | 45 Beech Way Wheathampstead AL4 8LY St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Marketing Executive | 11521980001 | ||||
LUCAS, Anne | Geschäftsführer | Leicester Road Billesdon LE7 9AQ Leicester 36 Leicestershire | United Kingdom | British | Commercial | 138063040001 | ||||
LUCAS, Frederick William Henry | Geschäftsführer | Millside Digswell Lane AL7 1SN Welwyn Garden City Hertfordshire | England | British | Enterpreneur | 72637180001 | ||||
PAGE, David | Geschäftsführer | 18 Raynham Drive LE11 4TW Loughborough Leicestershire | British | Production | 65760850001 | |||||
SPELMAN, Nigel Andrew Charles | Geschäftsführer | 33 The Ridings Waltham Chase SO32 2TR Southampton Hampshire | British | Marketing | 1740320001 | |||||
STEPHEN, James Mitchell | Geschäftsführer | 9 Townsend Leys Higham Ferrers NN10 8LW Rushden Northamptonshire | United Kingdom | British | Marketing Executive | 51261930002 | ||||
CCS DIRECTORS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 120 East Road N1 6AA London | 900001710001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LIVING SPACE (UK) LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr Andrew Lucas | 01. Juni 2016 | 15-17 Roebuck Road Hainault Business Park IG6 3TU Ilford Recovery House | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: United Kingdom | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat LIVING SPACE (UK) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 24. Mai 2013 Geliefert am 11. Juni 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung 12A earlstrees road earlstrees road earlstrees industrial estate corby. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 21. Mai 2013 Geliefert am 29. Mai 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. März 2008 Geliefert am 31. März 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 12A earlstrees road, earlstrees industrial estate corby northants by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 10. Apr. 2002 Geliefert am 11. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 12A earlstrees road earlstrees industrial estate corby northamptonshire t/no: NN134289. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 05. Apr. 2002 Geliefert am 12. Apr. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 12. Juli 1999 Geliefert am 14. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A floating charge over all the assets and undertaking of the company except book debts and other debts owing to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
All assets debenture | Erstellt am 18. Jan. 1999 Geliefert am 22. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 21. Dez. 1998 Geliefert am 30. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture or any other security | |
Kurze Angaben A floating charge over all the assets and undertaking of the company except book debts and other debts owing to the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat LIVING SPACE (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0