GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED

GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02630007
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?

    • Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    61 Fairfax Road
    NW6 4EE London
    England
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LEEMANOR LIMITED17. Juli 199117. Juli 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?

    ÜberfälligNein
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Aug. 2024
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Mai 2025
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2023

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?

    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis30. Juni 2025
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung14. Juli 2025
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis30. Juni 2024
    ÜberfälligNein

    Welche sind die letzten Einreichungen für GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Beendigung der Bestellung von Rowan Jon Meehan als Geschäftsführer am 16. Jan. 2025

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Rowan Jon Meehan als Sekretär am 16. Jan. 2025

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Idm Property Management Llp als Sekretär am 10. Juli 2024

    2 SeitenAP04

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2024 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2023

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2023 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2022

    3 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 026300070022, erstellt am 25. Mai 2023

    33 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 026300070023, erstellt am 25. Mai 2023

    8 SeitenMR01

    Ernennung von Mr Keith Meehan als Direktor am 24. Jan. 2023

    2 SeitenAP01

    Eintragung der Belastung 026300070021, erstellt am 20. Jan. 2023

    4 SeitenMR01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2022 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2021

    3 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 026300070020 vollständig

    4 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2020

    3 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Mr Rowen Jon Meehan am 23. Sept. 2020

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Rowen Jon Meehan am 23. Sept. 2020

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2019

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Eintragung der Belastung 026300070020, erstellt am 11. Okt. 2019

    34 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 026300070019, erstellt am 11. Okt. 2019

    7 SeitenMR01

    Erfüllung der Belastung 026300070017 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 026300070016 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 026300070018 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    IDM PROPERTY MANAGEMENT LLP
    Poole Street
    N1 5EA London
    1
    England
    Sekretär
    Poole Street
    N1 5EA London
    1
    England
    RechtsformLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Art des AusweisesAndere Körperschaft oder Firma
    RechtsgrundlageLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    RegistrierungsnummerOC314011
    325159550001
    MEEHAN, Keith
    Fairfax Road
    NW6 4EE London
    61
    England
    Geschäftsführer
    Fairfax Road
    NW6 4EE London
    61
    England
    United KingdomBritishCompany Director209813510001
    MEEHAN, Keith
    Woodberry Grove
    Finchley
    N12 0DR London
    1st Floor 2
    Sekretär
    Woodberry Grove
    Finchley
    N12 0DR London
    1st Floor 2
    British157063950001
    MEEHAN, Rowan Jon
    Fairfax Road
    NW6 4EE London
    61
    England
    Sekretär
    Fairfax Road
    NW6 4EE London
    61
    England
    British159265870002
    MEEHAN, Rowen
    De Beauvoir Square
    N1 4LG London
    1
    Uk
    United Kingdom
    Sekretär
    De Beauvoir Square
    N1 4LG London
    1
    Uk
    United Kingdom
    154227440001
    BAGSHOT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
    1 Poole Street
    N1 5EA London
    66 West Gainsborough Studios
    Sekretär
    1 Poole Street
    N1 5EA London
    66 West Gainsborough Studios
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer01627655
    14323570003
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    CURTIS, Andrew Craige
    66 West Gainsborough Studios
    1 Poole Street
    N1 5EA London
    Geschäftsführer
    66 West Gainsborough Studios
    1 Poole Street
    N1 5EA London
    United KingdomBritishBusiness Consultant3162320004
    GUY, Derry Cameron Waterford
    70 Narbonne Avenue
    SW4 9JT London
    Geschäftsführer
    70 Narbonne Avenue
    SW4 9JT London
    BritishCompany Director9782100001
    MEEHAN, Graham
    Lower Lodge
    Branch Hill Hampstead
    NW3 7LY London
    Geschäftsführer
    Lower Lodge
    Branch Hill Hampstead
    NW3 7LY London
    United KingdomBritishProperty Developer87820100001
    MEEHAN, Keith
    Woodberry Grove
    Finchley
    N12 0DR London
    1st Floor 2
    Geschäftsführer
    Woodberry Grove
    Finchley
    N12 0DR London
    1st Floor 2
    United KingdomBritishCompany Director172285810001
    MEEHAN, Keith
    1 Fitzroy Close
    N6 6JT London
    Geschäftsführer
    1 Fitzroy Close
    N6 6JT London
    BritishProperty Developer39801630004
    MEEHAN, Rowan Jon
    Fairfax Road
    NW6 4EE London
    61
    England
    Geschäftsführer
    Fairfax Road
    NW6 4EE London
    61
    England
    EnglandBritishCompany Director69605210015
    MEEHAN, Rowen Jon
    De Beauvoir Square
    N1 4LG London
    1
    Uk
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    De Beauvoir Square
    N1 4LG London
    1
    Uk
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director69605210007
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Oakton Investments Limited
    Fairfax Road
    NW6 4EE London
    61
    England
    30. Juni 2016
    Fairfax Road
    NW6 4EE London
    61
    England
    Nein
    RechtsformLimted Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer08168788
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 25. Mai 2023
    Geliefert am 26. Mai 2023
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All that freehold land being land and buildings in poole street and imber street, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL382742 with title absolute; and. All that freehold land on the east side of and land lying to the east side of new north road, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL373238 with title absolute.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • John Robert Henry Wood and Catharine Dien Wood Trading as Ladymead Consultants
    Transaktionen
    • 26. Mai 2023Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 25. Mai 2023
    Geliefert am 26. Mai 2023
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All that freehold land being land and buildings in poole street and imber street, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL382742 with title absolute; and. All that freehold land on the east side of and land lying to the east side of new north road, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL373238 with title absolute.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • John Robert Henry Wood and Catharine Dien Wood Trading as Ladymead Consultants
    Transaktionen
    • 26. Mai 2023Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 20. Jan. 2023
    Geliefert am 30. Jan. 2023
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Land on east side of and lying to the east of new north road, shoreditch, london and land and buildings in poole street and imber street, shoreditch, london.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Hamilton Meehan
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2023Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Okt. 2019
    Geliefert am 16. Okt. 2019
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All that freehold land being land and buildings in poole street and imber street, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL382742 with title absolute; and all that freehold land on the east side of and land lying to the east side of new north road, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL373238 with title absolute.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • John Robert Henry Wood and Catherine Dien Wood Trading as Ladymead Consultants
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 23. Sept. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 11. Okt. 2019
    Geliefert am 15. Okt. 2019
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    None.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • John Robert Henry Wood and Catharine Dien Wood Trading as Ladymead Consultants
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2019Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Feb. 2014
    Geliefert am 26. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/no. EGL382742 and land on the east side of and land lying to the east of new north road shoreditch london t/no. EGL373238. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bridgeco Limited
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 14. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Feb. 2014
    Geliefert am 26. Feb. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/no. EGL382742 and land on the east side of and land lying to the east of new north road shoreditch london t/no. EGL373238. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Bridgeco Limited
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 14. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 19. Nov. 2013
    Geliefert am 21. Nov. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Land and buildiings in poole street and imber street, shoreditch london and registered at h m land registry under title number EGL382742 and land on the east side of , and land lying to the east of, new north road, shoreditch, london and registered at h m land registry under title number EGL373238. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • United Trust Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 14. Okt. 2019Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. Aug. 2013
    Geliefert am 29. Aug. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    N/A.
    Berechtigte Personen
    • Catharine Dien Wood
    • John Robert Henry Wood
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 03. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 28. Aug. 2013
    Geliefert am 29. Aug. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All that f/h land being land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/no EGL382742. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Catharine Dien Wood
    • John Robert Henry Wood
    Transaktionen
    • 29. Aug. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 03. Dez. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Sept. 2012
    Geliefert am 20. Sept. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/no EGL382742 and land on the east side of, and land lying to the east of new north road shoreditch london t/no EGL373238 fixed charge any goodwill by way of assignment all rights title and interest in any lease licence or occupational right and claims made under any insurance policy relating to the scheduled property see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • United Trust Bank Limited
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Nov. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Third party legal charge
    Erstellt am 22. Mai 2008
    Geliefert am 28. Mai 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from lincoln trust investments limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land on the east side of and land lying to the east of new north road shoreditch london and f/h land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/nos EGL373238 and EGL382742 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Dez. 2001
    Geliefert am 28. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property at 213-215 new north road london N1 t/no EGL402655.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of pre-sale contracts
    Erstellt am 30. Mai 2001
    Geliefert am 07. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment to the bank all that the pre-sale contracts and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder or consequent thereupon as a continuing security for the payment and discharge of the liabilities.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of development agreement
    Erstellt am 30. Mai 2001
    Geliefert am 07. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment to the bank all that the deelopment agreement and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder or consequent thereupon as a continuing security for the payment and discharge of the liabilities.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Assignment of building contract
    Erstellt am 30. Mai 2001
    Geliefert am 07. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment to the bank all that the building contract and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder or consequent therupon as a continuing security for the payment and discharge of the liabilities.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Mai 2001
    Geliefert am 07. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and every interest in or over the property known as 17 poole street london title number EGL373238 EGL382742 and EGL382744. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Mai 2001
    Geliefert am 07. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 05. Feb. 1999
    Geliefert am 12. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabiltities due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture
    Kurze Angaben
    By way of a first floating charge all the undertakings and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 05. Feb. 1999
    Geliefert am 12. Feb. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge
    Kurze Angaben
    F/H land known as poole street and imber street shoreditch t/n-EGL382742. F/h land on the east side of new north road shoreditch t/n-EGL373238. L/h land lying to the west of imber street shoreditch t/n-EGL382744. L/h land lying to the north west of poole street and adjoining the grand union canal shoreditch t/n-EGL382745 including all fixtures fittings plant and machinery thereon (other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1978).
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment of rents
    Erstellt am 07. Okt. 1994
    Geliefert am 19. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of assignment of rents
    Kurze Angaben
    All rents and other sums payable under the leases of the property under t/n-NGL689060 and k/a flats 1 to 12 at 127-133 (odd) high road finchley.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporaton PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Okt. 1994
    Geliefert am 19. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    L/H-t/n-NGL689060 and k/a flats 1 to 12 at 127 to 133 (odd) high road finchley. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0