GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02630007 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?
- Kauf und Verkauf eigener Immobilien (68100) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 61 Fairfax Road NW6 4EE London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
LEEMANOR LIMITED | 17. Juli 1991 | 17. Juli 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Aug. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 31. Mai 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 30. Juni 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 14. Juli 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 30. Juni 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
---|---|---|---|---|
Beendigung der Bestellung von Rowan Jon Meehan als Geschäftsführer am 16. Jan. 2025 | 1 Seiten | TM01 | ||
Beendigung der Bestellung von Rowan Jon Meehan als Sekretär am 16. Jan. 2025 | 1 Seiten | TM02 | ||
Ernennung von Idm Property Management Llp als Sekretär am 10. Juli 2024 | 2 Seiten | AP04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2023 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Eintragung der Belastung 026300070022, erstellt am 25. Mai 2023 | 33 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 026300070023, erstellt am 25. Mai 2023 | 8 Seiten | MR01 | ||
Ernennung von Mr Keith Meehan als Direktor am 24. Jan. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||
Eintragung der Belastung 026300070021, erstellt am 20. Jan. 2023 | 4 Seiten | MR01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 026300070020 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Mr Rowen Jon Meehan am 23. Sept. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Änderung der Details des Sekretärs für Rowen Jon Meehan am 23. Sept. 2020 | 1 Seiten | CH03 | ||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Aug. 2019 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juni 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Eintragung der Belastung 026300070020, erstellt am 11. Okt. 2019 | 34 Seiten | MR01 | ||
Eintragung der Belastung 026300070019, erstellt am 11. Okt. 2019 | 7 Seiten | MR01 | ||
Erfüllung der Belastung 026300070017 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 026300070016 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 026300070018 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDM PROPERTY MANAGEMENT LLP | Sekretär | Poole Street N1 5EA London 1 England |
| 325159550001 | ||||||||||||||
MEEHAN, Keith | Geschäftsführer | Fairfax Road NW6 4EE London 61 England | United Kingdom | British | Company Director | 209813510001 | ||||||||||||
MEEHAN, Keith | Sekretär | Woodberry Grove Finchley N12 0DR London 1st Floor 2 | British | 157063950001 | ||||||||||||||
MEEHAN, Rowan Jon | Sekretär | Fairfax Road NW6 4EE London 61 England | British | 159265870002 | ||||||||||||||
MEEHAN, Rowen | Sekretär | De Beauvoir Square N1 4LG London 1 Uk United Kingdom | 154227440001 | |||||||||||||||
BAGSHOT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED | Sekretär | 1 Poole Street N1 5EA London 66 West Gainsborough Studios |
| 14323570003 | ||||||||||||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||||||||||
CURTIS, Andrew Craige | Geschäftsführer | 66 West Gainsborough Studios 1 Poole Street N1 5EA London | United Kingdom | British | Business Consultant | 3162320004 | ||||||||||||
GUY, Derry Cameron Waterford | Geschäftsführer | 70 Narbonne Avenue SW4 9JT London | British | Company Director | 9782100001 | |||||||||||||
MEEHAN, Graham | Geschäftsführer | Lower Lodge Branch Hill Hampstead NW3 7LY London | United Kingdom | British | Property Developer | 87820100001 | ||||||||||||
MEEHAN, Keith | Geschäftsführer | Woodberry Grove Finchley N12 0DR London 1st Floor 2 | United Kingdom | British | Company Director | 172285810001 | ||||||||||||
MEEHAN, Keith | Geschäftsführer | 1 Fitzroy Close N6 6JT London | British | Property Developer | 39801630004 | |||||||||||||
MEEHAN, Rowan Jon | Geschäftsführer | Fairfax Road NW6 4EE London 61 England | England | British | Company Director | 69605210015 | ||||||||||||
MEEHAN, Rowen Jon | Geschäftsführer | De Beauvoir Square N1 4LG London 1 Uk United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 69605210007 | ||||||||||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakton Investments Limited | 30. Juni 2016 | Fairfax Road NW6 4EE London 61 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat GAINSBOROUGH STUDIOS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 25. Mai 2023 Geliefert am 26. Mai 2023 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All that freehold land being land and buildings in poole street and imber street, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL382742 with title absolute; and. All that freehold land on the east side of and land lying to the east side of new north road, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL373238 with title absolute. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 25. Mai 2023 Geliefert am 26. Mai 2023 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All that freehold land being land and buildings in poole street and imber street, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL382742 with title absolute; and. All that freehold land on the east side of and land lying to the east side of new north road, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL373238 with title absolute. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 20. Jan. 2023 Geliefert am 30. Jan. 2023 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Land on east side of and lying to the east of new north road, shoreditch, london and land and buildings in poole street and imber street, shoreditch, london. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 11. Okt. 2019 Geliefert am 16. Okt. 2019 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All that freehold land being land and buildings in poole street and imber street, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL382742 with title absolute; and all that freehold land on the east side of and land lying to the east side of new north road, shoreditch, london as the same is registered at the land registry under title number EGL373238 with title absolute. Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 11. Okt. 2019 Geliefert am 15. Okt. 2019 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung None. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 19. Feb. 2014 Geliefert am 26. Feb. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/no. EGL382742 and land on the east side of and land lying to the east of new north road shoreditch london t/no. EGL373238. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 19. Feb. 2014 Geliefert am 26. Feb. 2014 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/no. EGL382742 and land on the east side of and land lying to the east of new north road shoreditch london t/no. EGL373238. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 19. Nov. 2013 Geliefert am 21. Nov. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Land and buildiings in poole street and imber street, shoreditch london and registered at h m land registry under title number EGL382742 and land on the east side of , and land lying to the east of, new north road, shoreditch, london and registered at h m land registry under title number EGL373238. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 28. Aug. 2013 Geliefert am 29. Aug. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung N/A. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 28. Aug. 2013 Geliefert am 29. Aug. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung All that f/h land being land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/no EGL382742. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 19. Sept. 2012 Geliefert am 20. Sept. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/no EGL382742 and land on the east side of, and land lying to the east of new north road shoreditch london t/no EGL373238 fixed charge any goodwill by way of assignment all rights title and interest in any lease licence or occupational right and claims made under any insurance policy relating to the scheduled property see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Third party legal charge | Erstellt am 22. Mai 2008 Geliefert am 28. Mai 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from lincoln trust investments limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on the east side of and land lying to the east of new north road shoreditch london and f/h land and buildings in poole street and imber street shoreditch london t/nos EGL373238 and EGL382742 by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Dez. 2001 Geliefert am 28. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property at 213-215 new north road london N1 t/no EGL402655.. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of pre-sale contracts | Erstellt am 30. Mai 2001 Geliefert am 07. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of assignment to the bank all that the pre-sale contracts and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder or consequent thereupon as a continuing security for the payment and discharge of the liabilities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of development agreement | Erstellt am 30. Mai 2001 Geliefert am 07. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of assignment to the bank all that the deelopment agreement and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder or consequent thereupon as a continuing security for the payment and discharge of the liabilities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Assignment of building contract | Erstellt am 30. Mai 2001 Geliefert am 07. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of assignment to the bank all that the building contract and the full benefit thereof and the benefit of any claims or compensation whatsoever arising thereunder or consequent therupon as a continuing security for the payment and discharge of the liabilities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 30. Mai 2001 Geliefert am 07. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and every interest in or over the property known as 17 poole street london title number EGL373238 EGL382742 and EGL382744. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 30. Mai 2001 Geliefert am 07. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 05. Feb. 1999 Geliefert am 12. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabiltities due or to become due from the company to the chargee under the terms of this debenture | |
Kurze Angaben By way of a first floating charge all the undertakings and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 05. Feb. 1999 Geliefert am 12. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this legal charge | |
Kurze Angaben F/H land known as poole street and imber street shoreditch t/n-EGL382742. F/h land on the east side of new north road shoreditch t/n-EGL373238. L/h land lying to the west of imber street shoreditch t/n-EGL382744. L/h land lying to the north west of poole street and adjoining the grand union canal shoreditch t/n-EGL382745 including all fixtures fittings plant and machinery thereon (other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1978). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment of rents | Erstellt am 07. Okt. 1994 Geliefert am 19. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed of assignment of rents | |
Kurze Angaben All rents and other sums payable under the leases of the property under t/n-NGL689060 and k/a flats 1 to 12 at 127-133 (odd) high road finchley. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Okt. 1994 Geliefert am 19. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/H-t/n-NGL689060 and k/a flats 1 to 12 at 127 to 133 (odd) high road finchley. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0