GML CONSTRUCTION LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGML CONSTRUCTION LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02640560
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GML CONSTRUCTION LIMITED?

    • Bau von Versorgungsprojekten für Flüssigkeiten (42210) / Bauwesen
    • Bau von sonstigen Bauingenieurprojekten n.a. (42990) / Bauwesen

    Wo befindet sich GML CONSTRUCTION LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O BDO LLP
    5 Temple Square Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GML CONSTRUCTION LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GLOBALMOBILE LIMITED23. Aug. 199123. Aug. 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GML CONSTRUCTION LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für GML CONSTRUCTION LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    25 SeitenLIQ14

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU zum 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH am 01. Dez. 2021

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Jan. 2021

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Jan. 2020

    18 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Suite 17 Building 6 Croxley Park Hatters Lane Watford WD18 8YH zum Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU am 20. Feb. 2020

    2 SeitenAD01

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:re sec of state release of liq
    4 SeitenLIQ MISC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Jan. 2019

    15 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    27 SeitenLIQ10

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:Notice of Release of liquidator david ronald elliott
    3 SeitenLIQ MISC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Jan. 2018

    18 SeitenLIQ03

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    21 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Moore Stephens Llp Victory House Quayside Chatham Maritime Kent ME4 4QU zum Suite 17 Building 6 Croxley Park Hatters Lane Watford WD18 8YH am 23. Nov. 2017

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Jan. 2017

    15 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Jan. 2016

    13 Seiten4.68

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:s/s cert, release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    11 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 06. Jan. 2015

    13 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    2 Seiten600

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 07. Jan. 2014

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Wer sind die Geschäftsführer von GML CONSTRUCTION LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PROTO, Alan James
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    Sekretär
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    British41906780002
    BENNER, John Edward
    Westerhill Road
    Coxheath
    ME17 4DH Maidstone
    Orchard House
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Westerhill Road
    Coxheath
    ME17 4DH Maidstone
    Orchard House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish161519200001
    PROTO, Alan James
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    Geschäftsführer
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    United KingdomBritish41906780002
    CHAPLIN, Jason Lloyd
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    9
    Kent
    United Kingdom
    Sekretär
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    9
    Kent
    United Kingdom
    British124986330002
    CRYSELL, Martin Ernest
    8 Meadow Lane
    Fetcham
    KT22 9UW Leatherhead
    Surrey
    Sekretär
    8 Meadow Lane
    Fetcham
    KT22 9UW Leatherhead
    Surrey
    British14572350001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BARNES, Trevor Harold Aston
    Westerhill Road
    Coxheath
    ME17 4DH Maidstone
    Orchard House
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Westerhill Road
    Coxheath
    ME17 4DH Maidstone
    Orchard House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish103765850002
    BARRY, Gavin
    Westerhill Road
    ME17 4DH Coxheath
    Orchard House
    Kent
    England
    Geschäftsführer
    Westerhill Road
    ME17 4DH Coxheath
    Orchard House
    Kent
    England
    United KingdomBritish174056360001
    CHAPLIN, Jason Lloyd
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    9
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    9
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish124986330002
    CRYSELL, Elizabeth Mary
    8 Meadow Lane
    Fetcham
    KT22 9UW Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    8 Meadow Lane
    Fetcham
    KT22 9UW Leatherhead
    Surrey
    British18569180001
    CRYSELL, Martin Ernest
    8 Meadow Lane
    Fetcham
    KT22 9UW Leatherhead
    Surrey
    Geschäftsführer
    8 Meadow Lane
    Fetcham
    KT22 9UW Leatherhead
    Surrey
    British14572350001
    DORE, Richard Kem
    Westerhill Road
    Coxheath
    ME17 4DH Maidstone
    Orchard House
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Westerhill Road
    Coxheath
    ME17 4DH Maidstone
    Orchard House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish9317470006
    EDSER, Kevin Ronald
    Westerhill Road
    Coxheath
    ME17 4DH Maidstone
    Orchard House
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Westerhill Road
    Coxheath
    ME17 4DH Maidstone
    Orchard House
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish118176070001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat GML CONSTRUCTION LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 09. Jan. 2008
    Geliefert am 10. Jan. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property known as orchard house westerhill road coxheath maidstone kent t/n K492343,. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Jan. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage
    Erstellt am 18. Okt. 2007
    Geliefert am 19. Okt. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a day nursery in the grounds of henry hinde school bilton rugby warwickshire. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juni 2007
    Geliefert am 12. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land and premises comprised in an agreement dated 12 february 2007 and an agreement dated 15 may 2006. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 26. Juni 2003
    Geliefert am 04. Juli 2003
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Account maintained with lloyds tsb off shore treasury limited - guersney under client number 50632.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture deed
    Erstellt am 10. Juli 2000
    Geliefert am 22. Juli 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 15. Juli 1997
    Geliefert am 19. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 15. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Dez. 1994
    Geliefert am 24. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £75,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Michael Mathew Proto
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GML CONSTRUCTION LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Jan. 2013Beginn der Verwaltung
    07. Jan. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon Geoffrey Paterson
    Victory House Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Praktiker
    Victory House Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    David Ronald Elliott
    Moore Stephens Llp
    Victory House Admiralty Place
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Praktiker
    Moore Stephens Llp
    Victory House Admiralty Place
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    2
    DatumTyp
    07. Jan. 2014Beginn der Liquidation
    15. Juni 2022Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christine Francis
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Michael Finch
    Suite 17, Building 6 Croxley Green Business Park
    Hatters Lane
    WD18 8YH Watford
    Praktiker
    Suite 17, Building 6 Croxley Green Business Park
    Hatters Lane
    WD18 8YH Watford
    Simon Geoffrey Paterson
    Victory House Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Praktiker
    Victory House Quayside
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    David Ronald Elliott
    Moore Stephens Llp
    Victory House Admiralty Place
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Praktiker
    Moore Stephens Llp
    Victory House Admiralty Place
    ME4 4QU Chatham Maritime
    Kent
    Diane Elizabeth Hill
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praktiker
    Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Praktiker
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0