LA PIERRE CARE HOMES LIMITED

LA PIERRE CARE HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameLA PIERRE CARE HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02647567
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Craegmoor House
    Perdiswell Park
    WR3 7NW Worcestershire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von David Manson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David James Hall als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Philip Henry Scott als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Jason David Lock als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Matthew Franzidis als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Scott Morrison als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Albert Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christine Cameron als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Julian Ball als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Okt. 2010

    Kapitalaufstellung am 18. Okt. 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    8 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten353a

    legacy

    1 Seiten190a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    4 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HALL, David James
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    159670690001
    FRANZIDIS, Matthew
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandUk129251300001
    LOCK, Jason David
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish144822040001
    SCOTT, Philip Henry
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish174231320001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    SIDERAS, Louis
    138 Chase Road
    Southgate
    N14 4LG London
    Sekretär
    138 Chase Road
    Southgate
    N14 4LG London
    British2735030001
    SIDERAS, Renos
    6 Ringwood Way
    Winchmore Hill
    N21 2QY London
    Sekretär
    6 Ringwood Way
    Winchmore Hill
    N21 2QY London
    British42405830001
    BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    Sekretär
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    39680630001
    RWL REGISTRARS LIMITED
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    Bevollmächtigter Sekretär
    Regis House
    134 Percival Road
    EN1 1QU Enfield
    Middlesex
    900007870001
    ARTIS, Carol Mary
    Hall Bank
    Clifford Hall
    L6A 3LW Burton In Lonsdale
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Hall Bank
    Clifford Hall
    L6A 3LW Burton In Lonsdale
    North Yorkshire
    British54150740002
    BALL, Julian Charles
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    EnglandBritish138044110001
    BLACKOE, George Henry
    4 Ridgeway
    Nettleham
    LN2 2TL Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    4 Ridgeway
    Nettleham
    LN2 2TL Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish3431630001
    BYRNE, Michael
    71a-71c High Street
    TN21 8HU Heathfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    71a-71c High Street
    TN21 8HU Heathfield
    East Sussex
    Canadian100296200001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish113187140001
    CAMERON, Christine Isabel
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    Geschäftsführer
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    EnglandBritish163745150001
    CHAPLIN, Leslie James
    Birkett House
    Front Street Barnby In The Willows
    NG24 2SA Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Birkett House
    Front Street Barnby In The Willows
    NG24 2SA Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritish90005480001
    FOTHERGILL, David
    Woodfordes
    Stoke St Mary
    TA3 5BY Taunton
    Somerset
    Geschäftsführer
    Woodfordes
    Stoke St Mary
    TA3 5BY Taunton
    Somerset
    British35902810001
    KEATING, Denise Elizabeth
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish111513540001
    MACDONALD, Dorothy Bridget
    174 Northumberland Park
    Tottenham
    N17 0SW London
    Geschäftsführer
    174 Northumberland Park
    Tottenham
    N17 0SW London
    British18000260001
    MANSON, David Lindsay
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish126071210001
    PRESTON, Mary
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    Geschäftsführer
    1 Pall Mall Cottage
    Rivington Lane
    BL6 7RY Bolton
    United KingdomBritish124068010001
    SIDERAS, George
    24 Lambourne Gardens
    Chingford
    E4 7SG London
    Geschäftsführer
    24 Lambourne Gardens
    Chingford
    E4 7SG London
    British12587320001
    SIDERAS, Louis
    138 Chase Road
    Southgate
    N14 4LG London
    Geschäftsführer
    138 Chase Road
    Southgate
    N14 4LG London
    British2735030001
    SIDERAS, Louis
    138 Chase Road
    Southgate
    N14 4LG London
    Geschäftsführer
    138 Chase Road
    Southgate
    N14 4LG London
    British2735030001
    SIDERAS, Renos
    6 Ringwood Way
    Winchmore Hill
    N21 2QY London
    Geschäftsführer
    6 Ringwood Way
    Winchmore Hill
    N21 2QY London
    British42405830001
    SMITH, Albert Edward
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish77631340001
    SPURLING, Julian Neville Guy
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    EnglandBritish110225070001
    STRATFORD, Michael Anthony
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    United KingdomBritish38853720002
    THOMAS, Alan Keith
    21 Manor Rise
    Reepham
    LN3 4GA Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    21 Manor Rise
    Reepham
    LN3 4GA Lincoln
    Lincolnshire
    British89071280001

    Hat LA PIERRE CARE HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession and charge acceeding to the debenture dated 18 july 2008 and
    Erstellt am 02. Okt. 2008
    Geliefert am 08. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The acquisition agreement claims all rights in respect of the insurance policies, the hedging agreements, any structural intra group loans fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Borrower deed of charge
    Erstellt am 13. Aug. 2003
    Geliefert am 01. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the initial borrowers to the chargee for the borrower secured creditors or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Jan. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture between craegmoor group limited and the company and the other cgl subsidiaries and barclays bank PLC (security agent)
    Erstellt am 07. Mai 2003
    Geliefert am 21. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Lenders
    Transaktionen
    • 21. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Jan. 2003
    Geliefert am 23. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 14. Jan. 2003
    Geliefert am 23. Jan. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations and liabilities due or to become due from parkcare homes (no.2) LTD (the "borrower") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Jan. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security accession deed between inter alia,the company,the new charging companies (as defined),craegmoor limited (the "parent") and rbs mezzanine limited (the "security agent"),and supplemental to a debenture dated 27 july 2001
    Erstellt am 31. Okt. 2001
    Geliefert am 14. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money or liabilities due,owing or incurred to any secured party (as defined) by any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) under any note finance document (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Mezzanine Limited
    Transaktionen
    • 14. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of debenture
    Erstellt am 09. März 2001
    Geliefert am 27. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future liabilities of craegmoor group limited or parkcare homes (NO2) limited (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity) to the chargee under the facility agreement dated 18 september 2000 any other document (all as defined) together with all expenses
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent (As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transaktionen
    • 27. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Mai 2000
    Geliefert am 10. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee and/or ucb healthcare finance no.1 Limited on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Suisse First Boston
    Transaktionen
    • 10. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 17. Dez. 1996
    Geliefert am 23. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. März 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0