LA PIERRE CARE HOMES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LA PIERRE CARE HOMES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02647567 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Craegmoor House Perdiswell Park WR3 7NW Worcestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Manson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David James Hall als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Henry Scott als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jason David Lock als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Franzidis als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Morrison als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Albert Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christine Cameron als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Ball als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LA PIERRE CARE HOMES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL, David James | Sekretär | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | 159670690001 | |||||||
| FRANZIDIS, Matthew | Geschäftsführer | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | England | Uk | 129251300001 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | England | British | 144822040001 | |||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | England | British | 174231320001 | |||||
| MORRISON, Scott | Sekretär | 24 Gaveston Road CV32 6EU Leamington Spa Warwickshire | British | 99297890001 | ||||||
| SIDERAS, Louis | Sekretär | 138 Chase Road Southgate N14 4LG London | British | 2735030001 | ||||||
| SIDERAS, Renos | Sekretär | 6 Ringwood Way Winchmore Hill N21 2QY London | British | 42405830001 | ||||||
| BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED | Sekretär | 7th Floor Beaufort House 15 St Botolph Street EC3A 7NJ London | 39680630001 | |||||||
| RWL REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Regis House 134 Percival Road EN1 1QU Enfield Middlesex | 900007870001 | |||||||
| ARTIS, Carol Mary | Geschäftsführer | Hall Bank Clifford Hall L6A 3LW Burton In Lonsdale North Yorkshire | British | 54150740002 | ||||||
| BALL, Julian Charles | Geschäftsführer | Mill Fleam Hilton DE65 5HE Derby 14 Derbyshire | England | British | 138044110001 | |||||
| BLACKOE, George Henry | Geschäftsführer | 4 Ridgeway Nettleham LN2 2TL Lincoln Lincolnshire | United Kingdom | British | 3431630001 | |||||
| BYRNE, Michael | Geschäftsführer | 71a-71c High Street TN21 8HU Heathfield East Sussex | Canadian | 100296200001 | ||||||
| CAMERON, Charles Donald Ewen | Geschäftsführer | Orchard Manor Church Lane Martin Hussingtree WR3 8TQ Worcester Worcestershire | England | British | 113187140001 | |||||
| CAMERON, Christine Isabel | Geschäftsführer | 10 Mount Crescent HR1 NQ1 Hereford | England | British | 163745150001 | |||||
| CHAPLIN, Leslie James | Geschäftsführer | Birkett House Front Street Barnby In The Willows NG24 2SA Newark Nottinghamshire | England | British | 90005480001 | |||||
| FOTHERGILL, David | Geschäftsführer | Woodfordes Stoke St Mary TA3 5BY Taunton Somerset | British | 35902810001 | ||||||
| KEATING, Denise Elizabeth | Geschäftsführer | 62 Church Street Cogenhoe NN7 1LS Northampton Northamptonshire | England | British | 111513540001 | |||||
| MACDONALD, Dorothy Bridget | Geschäftsführer | 174 Northumberland Park Tottenham N17 0SW London | British | 18000260001 | ||||||
| MANSON, David Lindsay | Geschäftsführer | 111 Lodge Road Knowle B93 0HG Solihull West Midlands | England | British | 126071210001 | |||||
| PRESTON, Mary | Geschäftsführer | 1 Pall Mall Cottage Rivington Lane BL6 7RY Bolton | United Kingdom | British | 124068010001 | |||||
| SIDERAS, George | Geschäftsführer | 24 Lambourne Gardens Chingford E4 7SG London | British | 12587320001 | ||||||
| SIDERAS, Louis | Geschäftsführer | 138 Chase Road Southgate N14 4LG London | British | 2735030001 | ||||||
| SIDERAS, Louis | Geschäftsführer | 138 Chase Road Southgate N14 4LG London | British | 2735030001 | ||||||
| SIDERAS, Renos | Geschäftsführer | 6 Ringwood Way Winchmore Hill N21 2QY London | British | 42405830001 | ||||||
| SMITH, Albert Edward | Geschäftsführer | Flint House Froxfield SN8 3JY Marlborough Wiltshire | England | British | 77631340001 | |||||
| SPURLING, Julian Neville Guy | Geschäftsführer | Foundry House GU35 9LY Kingsley Hampshire | England | British | 110225070001 | |||||
| STRATFORD, Michael Anthony | Geschäftsführer | 10 Anne Hathaway Drive GL3 2PX Churchdown Gloucestershire | United Kingdom | British | 38853720002 | |||||
| THOMAS, Alan Keith | Geschäftsführer | 21 Manor Rise Reepham LN3 4GA Lincoln Lincolnshire | British | 89071280001 |
Hat LA PIERRE CARE HOMES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge acceeding to the debenture dated 18 july 2008 and | Erstellt am 02. Okt. 2008 Geliefert am 08. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The acquisition agreement claims all rights in respect of the insurance policies, the hedging agreements, any structural intra group loans fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 2007 Geliefert am 26. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Borrower deed of charge | Erstellt am 13. Aug. 2003 Geliefert am 01. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the initial borrowers to the chargee for the borrower secured creditors or any of the other borrower secured creditors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture between craegmoor group limited and the company and the other cgl subsidiaries and barclays bank PLC (security agent) | Erstellt am 07. Mai 2003 Geliefert am 21. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Jan. 2003 Geliefert am 23. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Jan. 2003 Geliefert am 23. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from parkcare homes (no.2) LTD (the "borrower") to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security accession deed between inter alia,the company,the new charging companies (as defined),craegmoor limited (the "parent") and rbs mezzanine limited (the "security agent"),and supplemental to a debenture dated 27 july 2001 | Erstellt am 31. Okt. 2001 Geliefert am 14. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities due,owing or incurred to any secured party (as defined) by any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) under any note finance document (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of debenture | Erstellt am 09. März 2001 Geliefert am 27. März 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future liabilities of craegmoor group limited or parkcare homes (NO2) limited (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity) to the chargee under the facility agreement dated 18 september 2000 any other document (all as defined) together with all expenses | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Mai 2000 Geliefert am 10. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee and/or ucb healthcare finance no.1 Limited on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 17. Dez. 1996 Geliefert am 23. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0