ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02647616 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Warwick House PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ALVIS AEROSPACE & TRANSMISSIONS LIMITED | 10. Jan. 1992 | 10. Jan. 1992 |
| SPECKTOR LIMITED | 20. Sept. 1991 | 20. Sept. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 31 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für David Stanley Parkes am 06. Nov. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für David Stanley Parkes am 06. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ann Louise Holding am 29. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||||||||||
legacy | 4 Seiten | 288a | ||||||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKES, David Stanley | Sekretär | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | British | 25179240002 | ||||||
| HOLDING, Ann-Louise | Geschäftsführer | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | England | British | 73464490003 | |||||
| PARKES, David Stanley | Geschäftsführer | Warwick House, PO BOX 87 Farnborough Aerospace Centre GU14 6YU Farnborough C/O Bae Systems - Company Secretariat Hants. United Kingdom | England | British | 25179240002 | |||||
| DICKINSON, George Kenneth | Sekretär | 95 Windy Arbour CV8 2BJ Kenilworth Warwickshire | British | 17280390001 | ||||||
| EARDLEY, Barry Eric | Sekretär | The Cedars Tamworth Road CV7 8JJ Keresley Coventry | British | 36645710001 | ||||||
| GOULDING, Jacqueline Elizabeth | Sekretär | 3 Sidmouth Close CV11 6FA Nuneaton Warwickshire | British | 49027500001 | ||||||
| JARMAN, Patrick Edmund | Sekretär | 68 Replingham Road SW18 5LW London | British | 66608960002 | ||||||
| LANGLEY, Paul Michael | Sekretär | 47 Redbourn Road WS3 3XT Bloxwich West Midlands | British | 47929580002 | ||||||
| DICKINSON, George Kenneth | Geschäftsführer | 95 Windy Arbour CV8 2BJ Kenilworth Warwickshire | British | 17280390001 | ||||||
| EARDLEY, Barry Eric | Geschäftsführer | The Cedars Tamworth Road CV7 8JJ Keresley Coventry | British | 36645710001 | ||||||
| EARDLEY, Barry Eric | Geschäftsführer | The Cedars Tamworth Road CV7 8JJ Keresley Coventry | British | 36645710001 | ||||||
| GREENSLADE, Martin Frederick | Geschäftsführer | 2 The Glade TN13 3HD Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | 17633990002 | |||||
| HOYLE, David John | Geschäftsführer | 10 Berwick Close Woodloes Park CV34 5UF Warwick Warwickshire | British | 17280400001 | ||||||
| JARMAN, Patrick Edmund | Geschäftsführer | 68 Replingham Road SW18 5LW London | British | 66608960002 | ||||||
| JARMAN, Patrick Edmund | Geschäftsführer | 68 Replingham Road SW18 5LW London | British | 66608960002 | ||||||
| PEARSON, Anthony Ralph | Geschäftsführer | 15 Oakfields Road SG3 6NS Knebworth Hertfordshire | British | 8659000001 | ||||||
| PREST, Nicholas Martin | Geschäftsführer | 85 Elgin Crescent W11 2JF London | Great Britain | British | 36518090001 | |||||
| ROWE, Christopher Gordon | Geschäftsführer | Bluebell Grange Allscott TF6 5EB Telford Salop | British | 113894430001 | ||||||
| THOMPSON, Andrew | Geschäftsführer | 22 Hawkshead Drive Knowle B93 9QE Solihull West Midlands | British | 16120720001 | ||||||
| WEBSTER, Donald James | Geschäftsführer | 58 Longrood Road Bilton CV22 7RE Rugby Warwickshire | British | 37379940001 | ||||||
| WIGLEY, Richard Simon | Geschäftsführer | The Old Forge Tainters Hill CV8 2GL Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | 17280410001 | |||||
| WILKINS, Stuart James | Geschäftsführer | Two Hedges House Two Hedges Road GL52 9PT Bishops Cleeve Cheltenham | United Kingdom | British | 102395070002 | |||||
| WINCH, Brian Clappison | Geschäftsführer | The Old Rectory Knapton Green, Knapton NR28 0RU North Walsham Norfolk | England | British | 64371830001 |
Hat ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 22. Okt. 1997 Geliefert am 07. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities present future actual or contingent due or to become due from the company to lloyds bank PLC on any current account or in any manner whatsoever (but excluding any sums owing or liabilities incurred by the company under the syndicated finance documents) and all moneys and liabilities present and future actual or contingent due or to become due by any obligors (other than the company) or newco on any current account and in any manner whatsoever (but excluding (I) any sums owing or liabilities incurred by such obligors or newco under the syndicated finance documents and (ii) any monies or liabilities due owing or incurred by such other obligors or newco as guarantor for the company). | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 22. Okt. 1997 Geliefert am 12. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
Kurze Angaben Floating charge over all the company's undertaking property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 22. Okt. 1997 Geliefert am 07. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any obligor other than the company or newco to the chargees under the terms of the finance documents (as defined in the debenture) except any moneys or liabilities due owing or incurred by such obligor(s) or by newco as guarantor for the company | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 22. Okt. 1997 Geliefert am 07. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
Kurze Angaben Floating charge all the company's undertaking property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 22. Okt. 1997 Geliefert am 07. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben By way of floating charge, all its undertaking, property, assets and revenues both present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and charge of registered designs and design right | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben All "charged rights" (as defined in the form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of charge of copyright and design right | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of trade marks trade names and goodwill | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben All the "charged rights" (as defined in the form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment and charge of patents | Erstellt am 15. Mai 1995 Geliefert am 25. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date | |
Kurze Angaben All inventions and patents specified in form 395 together with all patents and inventions belonging to the mortgagor present and future at the date of the charge patent no's 5031477. 0 420 446 (e) (X2). 2172 672. 2235663.P690 01 168.7 14889/1990.5 031 477. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined) | Erstellt am 12. Juli 1994 Geliefert am 22. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC | Erstellt am 12. Juli 1994 Geliefert am 22. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of accession and supplemental deed in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined) | Erstellt am 12. Juli 1994 Geliefert am 22. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0