ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameALVIS TRANSMISSIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02647616
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Warwick House PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ALVIS AEROSPACE & TRANSMISSIONS LIMITED10. Jan. 199210. Jan. 1992
    SPECKTOR LIMITED20. Sept. 199120. Sept. 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Sept. 2012

    Kapitalaufstellung am 20. Sept. 2012

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    4 SeitenAA

    Erklärung der Unternehmensgegenstände

    2 SeitenCC04

    Beschlüsse

    Resolutions
    31 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01
    capital

    Beschlüsse

    Delete mem 14/04/2011
    RES13

    Jahresrückblick erstellt bis 20. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    4 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für David Stanley Parkes am 06. Nov. 2009

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für David Stanley Parkes am 06. Nov. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Ann Louise Holding am 29. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    4 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    4 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    4 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    4 Seiten288a

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Wahlresolution

    ELRES

    Wer sind die Geschäftsführer von ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Sekretär
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    British25179240002
    HOLDING, Ann-Louise
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish73464490003
    PARKES, David Stanley
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Warwick House, PO BOX 87
    Farnborough Aerospace Centre
    GU14 6YU Farnborough
    C/O Bae Systems - Company Secretariat
    Hants.
    United Kingdom
    EnglandBritish25179240002
    DICKINSON, George Kenneth
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    Sekretär
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    British17280390001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Sekretär
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GOULDING, Jacqueline Elizabeth
    3 Sidmouth Close
    CV11 6FA Nuneaton
    Warwickshire
    Sekretär
    3 Sidmouth Close
    CV11 6FA Nuneaton
    Warwickshire
    British49027500001
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    Sekretär
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    LANGLEY, Paul Michael
    47 Redbourn Road
    WS3 3XT Bloxwich
    West Midlands
    Sekretär
    47 Redbourn Road
    WS3 3XT Bloxwich
    West Midlands
    British47929580002
    DICKINSON, George Kenneth
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    95 Windy Arbour
    CV8 2BJ Kenilworth
    Warwickshire
    British17280390001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Geschäftsführer
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    EARDLEY, Barry Eric
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    Geschäftsführer
    The Cedars
    Tamworth Road
    CV7 8JJ Keresley
    Coventry
    British36645710001
    GREENSLADE, Martin Frederick
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    Geschäftsführer
    2 The Glade
    TN13 3HD Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish17633990002
    HOYLE, David John
    10 Berwick Close
    Woodloes Park
    CV34 5UF Warwick
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    10 Berwick Close
    Woodloes Park
    CV34 5UF Warwick
    Warwickshire
    British17280400001
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    Geschäftsführer
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    JARMAN, Patrick Edmund
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    Geschäftsführer
    68 Replingham Road
    SW18 5LW London
    British66608960002
    PEARSON, Anthony Ralph
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    15 Oakfields Road
    SG3 6NS Knebworth
    Hertfordshire
    British8659000001
    PREST, Nicholas Martin
    85 Elgin Crescent
    W11 2JF London
    Geschäftsführer
    85 Elgin Crescent
    W11 2JF London
    Great BritainBritish36518090001
    ROWE, Christopher Gordon
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    Geschäftsführer
    Bluebell Grange
    Allscott
    TF6 5EB Telford
    Salop
    British113894430001
    THOMPSON, Andrew
    22 Hawkshead Drive
    Knowle
    B93 9QE Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    22 Hawkshead Drive
    Knowle
    B93 9QE Solihull
    West Midlands
    British16120720001
    WEBSTER, Donald James
    58 Longrood Road
    Bilton
    CV22 7RE Rugby
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    58 Longrood Road
    Bilton
    CV22 7RE Rugby
    Warwickshire
    British37379940001
    WIGLEY, Richard Simon
    The Old Forge Tainters Hill
    CV8 2GL Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Old Forge Tainters Hill
    CV8 2GL Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritish17280410001
    WILKINS, Stuart James
    Two Hedges House
    Two Hedges Road
    GL52 9PT Bishops Cleeve
    Cheltenham
    Geschäftsführer
    Two Hedges House
    Two Hedges Road
    GL52 9PT Bishops Cleeve
    Cheltenham
    United KingdomBritish102395070002
    WINCH, Brian Clappison
    The Old Rectory
    Knapton Green, Knapton
    NR28 0RU North Walsham
    Norfolk
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Knapton Green, Knapton
    NR28 0RU North Walsham
    Norfolk
    EnglandBritish64371830001

    Hat ALVIS TRANSMISSIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 22. Okt. 1997
    Geliefert am 07. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities present future actual or contingent due or to become due from the company to lloyds bank PLC on any current account or in any manner whatsoever (but excluding any sums owing or liabilities incurred by the company under the syndicated finance documents) and all moneys and liabilities present and future actual or contingent due or to become due by any obligors (other than the company) or newco on any current account and in any manner whatsoever (but excluding (I) any sums owing or liabilities incurred by such obligors or newco under the syndicated finance documents and (ii) any monies or liabilities due owing or incurred by such other obligors or newco as guarantor for the company).
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 22. Okt. 1997
    Geliefert am 12. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    Floating charge over all the company's undertaking property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alvis PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 22. Okt. 1997
    Geliefert am 07. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any obligor other than the company or newco to the chargees under the terms of the finance documents (as defined in the debenture) except any moneys or liabilities due owing or incurred by such obligor(s) or by newco as guarantor for the company
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC(The "Trustee")
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 22. Okt. 1997
    Geliefert am 07. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    Floating charge all the company's undertaking property and assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alvis PLC
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 22. Okt. 1997
    Geliefert am 07. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of floating charge, all its undertaking, property, assets and revenues both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Alvis PLC("Alvis")
    Transaktionen
    • 07. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juni 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and charge of registered designs and design right
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    All "charged rights" (as defined in the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of charge of copyright and design right
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    The "charged rights" (as defined in form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of trade marks trade names and goodwill
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    All the "charged rights" (as defined in the form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment and charge of patents
    Erstellt am 15. Mai 1995
    Geliefert am 25. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the charge and master facility agreement of even date
    Kurze Angaben
    All inventions and patents specified in form 395 together with all patents and inventions belonging to the mortgagor present and future at the date of the charge patent no's 5031477. 0 420 446 (e) (X2). 2172 672. 2235663.P690 01 168.7 14889/1990.5 031 477. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined)
    Erstellt am 12. Juli 1994
    Geliefert am 22. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Each of the Banks
    Transaktionen
    • 22. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and supplemental charge in favour of lloyds bank PLC
    Erstellt am 12. Juli 1994
    Geliefert am 22. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Each of the Banks
    Transaktionen
    • 22. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of accession and supplemental deed in favour of lloyds bank PLC as agent and trustee for the banks (as defined)
    Erstellt am 12. Juli 1994
    Geliefert am 22. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Each of the Banks
    Transaktionen
    • 22. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0