EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02649675 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o TEACHER STERN LLP 31-41 Bedford Row WC1R 4JH London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| KINGSHOLME LIMITED | 27. Sept. 1991 | 27. Sept. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Emlyn Peter Reid als Geschäftsführer am 30. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edmund Charles Mccann als Geschäftsführer am 28. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Edward Boyd als Geschäftsführer am 28. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Brian Snoddon als Geschäftsführer am 10. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Samuel James Harris als Geschäftsführer am 10. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2011 bis 30. Juni 2012 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 10 Orange Street Haymarket London WC2H 7DQ* am 17. Nov. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | MG01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREIGHTON, David Andrew | Sekretär | Malone Park House Malone Park BT9 6NL Belfast | British | 83528100001 | ||||||
| CREIGHTON, David Andrew | Geschäftsführer | Malone Park House Malone Park BT9 6NL Belfast | Northern Ireland | British | 83528100001 | |||||
| KENNY, Timothy, Mr. | Sekretär | 10 Carrickbrack Heath Sutton IRISH Dublin 13 Ireland | Irish | 113651250001 | ||||||
| PATTISON, Eric | Sekretär | 10 Oakfern BT36 5FN Newtownabbey County Antrim | British | 64178730001 | ||||||
| PINCUS, Barry Martin | Sekretär | 19 Willifield Way NW11 7XU London | British | 46444010002 | ||||||
| BOYD, Francis Edward | Geschäftsführer | Rademon Estate 60 Ballynahinch Road BT30 9HS Crossgar County Down | Northern Ireland | Northern Irish | 83528370002 | |||||
| BYRNE, Philip Patrick | Geschäftsführer | 29 Upper Merrion Street Dublin 2 Republic Of Ireland | Irish | 58604950001 | ||||||
| ELLIOTT, Acheson | Geschäftsführer | 57 Craigdarragh Road BT19 1UB Helen's Bay County Down N. Ireland | Northern Ireland | British | 144365710001 | |||||
| HARRIS, Samuel James | Geschäftsführer | 2 The Pines Culcavy Road BT26 6NT Hillsborough County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 158466790001 | |||||
| KENNY, Timothy, Mr. | Geschäftsführer | 10 Carrickbrack Heath Sutton IRISH Dublin 13 Ireland | Ireland | Irish | 113651250001 | |||||
| KLIMT, Peter Richard | Geschäftsführer | Redington Road NW3 7RS London 54 | United Kingdom | British | 23621230001 | |||||
| MCCANN, Edmund Charles | Geschäftsführer | 9 Deramore Drive BT9 5JQ Belfast Northern Ireland | Northern Ireland | Irish | 144512890001 | |||||
| NAGGAR, Guy Anthony | Geschäftsführer | Avenue Road NW8 6HR London 61 | United Kingdom | Italian | 1496660001 | |||||
| NOLAN, Geraldine | Geschäftsführer | 620 Clonard Road IRISH Crumlin Dublin 12 Ireland | Irish | 83257760001 | ||||||
| REID, Nicholas Emlyn Peter | Geschäftsführer | 32 Rushvale Road BT39 9NN Ballyclare County Antrim | Northern Ireland | British | 75236310001 | |||||
| SMYTH, Noel Martin | Geschäftsführer | Lisieux Hall Murphystown Road IRISH Sandyford Dublin 18 Ireland | Ireland | Irish | 91238420001 | |||||
| SNODDON, Brian | Geschäftsführer | Culcavy Road BT26 6JD Hillsborough 23 County Down United Kingdom | Northern Ireland | British | 143738840001 | |||||
| SNODDON, James Myrvan | Geschäftsführer | 43 Carnreagh BT26 6LJ Hillsborough County Down Northern Ireland | British | 143651570001 | ||||||
| STOUTZKER, Ian Isaac | Geschäftsführer | 33 Wilton Crescent SW1X 8RX London | England | British | 2658490001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunswick (No 1) Limited | 06. Apr. 2016 | Fountain Street BT1 5EB Belfast 51-55 Northern Ireland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over deposits | Erstellt am 08. Okt. 2010 Geliefert am 16. Okt. 2010 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit(s) being any sums deposited in the accounts and any other sum or sums which are from time to time deposited see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security interest agreement | Erstellt am 17. Nov. 2005 Geliefert am 30. Nov. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 27,250,000 units in the unit trust known as bridge end unit trust, and the related rights,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over deposits | Erstellt am 18. Okt. 2005 Geliefert am 27. Okt. 2005 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of a first fixed charge the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Juni 2004 Geliefert am 08. Juli 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. März 2004 Geliefert am 25. März 2004 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All that l/h land known as the western section of the island site, hammersmith broadway, hammersmith, london t/no BGL10281, all that f/h land situated at fleet road, fleet in the county of hampshire and known as the hart centre t/nos HP389489, HP315793 and HP320745, and all that f/h land situated at market street and 21 and 23 the market place in newbury in the county of west berkshire and k/a the kennet centre t/no BK235120,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Nov. 2000 Geliefert am 13. Nov. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from ewart property holdings limited (as borrower) to the chargee pursuant to a loan agreement in the amount of £23,000,000 dated 10TH february 1999 (as amended by a supplementary loan agreement dated 1ST november 1999) and/or any other finance documents (as defined in such loan agreement) | |
Kurze Angaben Inclusive of property k/a wakefield house 9-15 stamford street london SE1 t/no;-SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Apr. 2000 Geliefert am 27. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of (I) the borrower to the lender under the facility letter and the windsor dacility letter and (ii) of the company to the security trustee pursuant to the debenture | |
Kurze Angaben Freehold property k/a wakefield house 9-15 stamford street london t/n SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal charge | Erstellt am 17. Sept. 1992 Geliefert am 02. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £8,400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben The f/h property k/as 9 to 15 (odd) stamford street in the l/b of southwark.t/n sgl 326607.floating charge all the company's property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0