EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED

EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02649675
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o TEACHER STERN LLP
    31-41 Bedford Row
    WC1R 4JH London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    KINGSHOLME LIMITED27. Sept. 199127. Sept. 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Nicholas Emlyn Peter Reid als Geschäftsführer am 30. März 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Sept. 2016 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2015

    5 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Edmund Charles Mccann als Geschäftsführer am 28. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Francis Edward Boyd als Geschäftsführer am 28. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 29. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 600
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Brian Snoddon als Geschäftsführer am 10. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Samuel James Harris als Geschäftsführer am 10. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2014

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital29. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 29. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 600
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2013

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 10. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 600
    SH01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2012

    9 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2011 bis 30. Juni 2012

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 27. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 10 Orange Street Haymarket London WC2H 7DQ* am 17. Nov. 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    8 SeitenAA

    legacy

    7 SeitenMG01

    Wer sind die Geschäftsführer von EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Sekretär
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    British83528100001
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Geschäftsführer
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Northern IrelandBritish83528100001
    KENNY, Timothy, Mr.
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Sekretär
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Irish113651250001
    PATTISON, Eric
    10 Oakfern
    BT36 5FN Newtownabbey
    County Antrim
    Sekretär
    10 Oakfern
    BT36 5FN Newtownabbey
    County Antrim
    British64178730001
    PINCUS, Barry Martin
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    Sekretär
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    British46444010002
    BOYD, Francis Edward
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    County Down
    Geschäftsführer
    Rademon Estate
    60 Ballynahinch Road
    BT30 9HS Crossgar
    County Down
    Northern IrelandNorthern Irish83528370002
    BYRNE, Philip Patrick
    29 Upper Merrion Street
    Dublin 2
    Republic Of Ireland
    Geschäftsführer
    29 Upper Merrion Street
    Dublin 2
    Republic Of Ireland
    Irish58604950001
    ELLIOTT, Acheson
    57 Craigdarragh Road
    BT19 1UB Helen's Bay
    County Down
    N. Ireland
    Geschäftsführer
    57 Craigdarragh Road
    BT19 1UB Helen's Bay
    County Down
    N. Ireland
    Northern IrelandBritish144365710001
    HARRIS, Samuel James
    2 The Pines
    Culcavy Road
    BT26 6NT Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    2 The Pines
    Culcavy Road
    BT26 6NT Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish158466790001
    KENNY, Timothy, Mr.
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    Geschäftsführer
    10 Carrickbrack Heath
    Sutton
    IRISH Dublin 13
    Ireland
    IrelandIrish113651250001
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Geschäftsführer
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    MCCANN, Edmund Charles
    9 Deramore Drive
    BT9 5JQ Belfast
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    9 Deramore Drive
    BT9 5JQ Belfast
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrish144512890001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Geschäftsführer
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    NOLAN, Geraldine
    620 Clonard Road
    IRISH Crumlin
    Dublin 12
    Ireland
    Geschäftsführer
    620 Clonard Road
    IRISH Crumlin
    Dublin 12
    Ireland
    Irish83257760001
    REID, Nicholas Emlyn Peter
    32 Rushvale Road
    BT39 9NN Ballyclare
    County Antrim
    Geschäftsführer
    32 Rushvale Road
    BT39 9NN Ballyclare
    County Antrim
    Northern IrelandBritish75236310001
    SMYTH, Noel Martin
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    Geschäftsführer
    Lisieux Hall
    Murphystown Road
    IRISH Sandyford
    Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish91238420001
    SNODDON, Brian
    Culcavy Road
    BT26 6JD Hillsborough
    23
    County Down
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Culcavy Road
    BT26 6JD Hillsborough
    23
    County Down
    United Kingdom
    Northern IrelandBritish143738840001
    SNODDON, James Myrvan
    43 Carnreagh
    BT26 6LJ Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    Geschäftsführer
    43 Carnreagh
    BT26 6LJ Hillsborough
    County Down
    Northern Ireland
    British143651570001
    STOUTZKER, Ian Isaac
    33 Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    Geschäftsführer
    33 Wilton Crescent
    SW1X 8RX London
    EnglandBritish2658490001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Brunswick (No 1) Limited
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    06. Apr. 2016
    Fountain Street
    BT1 5EB Belfast
    51-55
    Northern Ireland
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandNorthern Ireland
    RechtsgrundlageCompanies Act Ni
    RegistrierungsortUk
    RegistrierungsnummerNi429823
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat EWART PROPERTY HOLDINGS (STAMFORD STREET) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over deposits
    Erstellt am 08. Okt. 2010
    Geliefert am 16. Okt. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the mortgagor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit(s) being any sums deposited in the accounts and any other sum or sums which are from time to time deposited see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC (the Bank)
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Security interest agreement
    Erstellt am 17. Nov. 2005
    Geliefert am 30. Nov. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    27,250,000 units in the unit trust known as bridge end unit trust, and the related rights,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transaktionen
    • 30. Nov. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over deposits
    Erstellt am 18. Okt. 2005
    Geliefert am 27. Okt. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of a first fixed charge the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group UK PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Juni 2004
    Geliefert am 08. Juli 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 08. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. März 2004
    Geliefert am 25. März 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All that l/h land known as the western section of the island site, hammersmith broadway, hammersmith, london t/no BGL10281, all that f/h land situated at fleet road, fleet in the county of hampshire and known as the hart centre t/nos HP389489, HP315793 and HP320745, and all that f/h land situated at market street and 21 and 23 the market place in newbury in the county of west berkshire and k/a the kennet centre t/no BK235120,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Ulster Bank Limited and Ulster Bank Ireland Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Nov. 2000
    Geliefert am 13. Nov. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from ewart property holdings limited (as borrower) to the chargee pursuant to a loan agreement in the amount of £23,000,000 dated 10TH february 1999 (as amended by a supplementary loan agreement dated 1ST november 1999) and/or any other finance documents (as defined in such loan agreement)
    Kurze Angaben
    Inclusive of property k/a wakefield house 9-15 stamford street london SE1 t/no;-SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunloe Ewart Finance B.V.
    Transaktionen
    • 13. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 14. Apr. 2000
    Geliefert am 27. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of (I) the borrower to the lender under the facility letter and the windsor dacility letter and (ii) of the company to the security trustee pursuant to the debenture
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a wakefield house 9-15 stamford street london t/n SGL326607. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Stanley Mortgage Servicing Limited (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 27. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 17. Sept. 1992
    Geliefert am 02. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £8,400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as 9 to 15 (odd) stamford street in the l/b of southwark.t/n sgl 326607.floating charge all the company's property assets and rights whatsoever and wheresoever present and/or future.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0