EBS NOMINEES LIMITED
Überblick
Unternehmensname | EBS NOMINEES LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02651363 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EBS NOMINEES LIMITED?
- (7487) /
Wo befindet sich EBS NOMINEES LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Broadgate London EC2M 7UR |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EBS NOMINEES LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TRUSHELFCO (NO.1746) LIMITED | 04. Okt. 1991 | 04. Okt. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EBS NOMINEES LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EBS NOMINEES LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Samantha Anne Wren als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Iain Torrens als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Okt. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Deborah Anne Abrehart am 13. Okt. 2009 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Iain William Torrens am 06. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Deborah Anne Abrehart am 06. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2008 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2007 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c |
Wer sind die Geschäftsführer von EBS NOMINEES LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABREHART, Deborah Anne | Sekretär | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | British | Chartered Secretary | 3219400009 | |||||
ABREHART, Deborah Anne | Geschäftsführer | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 3219400009 | ||||
WREN, Samantha Anne | Geschäftsführer | Broadgate EC2M 7UR London 2 England | England | British | Corporate Treasurer | 155853230001 | ||||
FORSTER, Jane | Sekretär | 56 Wavertree Road SW2 3SS London | British | 44284390003 | ||||||
FORSTER, Jane | Sekretär | 56 Wavertree Road SW2 3SS London | British | 44284390003 | ||||||
MANDRYKO, Erica Nadia | Sekretär | 75 Silverthorne Road Battersea SW8 3HH London | British | 108502750001 | ||||||
SCOULLAR, Kathryn Charlotte | Sekretär | 104 Acacia Road E17 8BW London | British | 97716910002 | ||||||
TRUSEC LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | 900007200001 | |||||||
BARTKO, Peter | Geschäftsführer | 26 Burgess Hill Cricklewood NW2 2DA London | American | Banker | 25724130001 | |||||
CAPLEN, Stephen Gerard | Geschäftsführer | 21 Saxon Road SO23 7DJ Winchester Hampshire | United Kingdom | British | Head Of Finance | 97716670001 | ||||
CASS, Trevor Norman | Geschäftsführer | Mount Avenue SS0 8PT Westcliff On Sea 38 Essex | United Kingdom | British | Bank Director | 24679090001 | ||||
CHANDLER, Christine Anne | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 31 Chesnut Grove New Malden Surrey | British | 900007180001 | ||||||
FROST-SMITH, Paul | Geschäftsführer | Flat B 58 Arundel Square N7 8AP London | British | Solicitor | 13601240001 | |||||
JEFFERY, Jonathan Joseph | Geschäftsführer | 10 The Quillot Burwood Park KT12 5BY Walton On Thames | England | British | Chief Executive Officer | 190841020001 | ||||
KIDD, Timothy Charles | Geschäftsführer | Wolmer Cottage Frieth Road SL7 2JQ Marlow Buckinghamshire | England | British | Director | 117842820001 | ||||
LEDSHAM, David Anthony | Geschäftsführer | 145 Bradbourne Park Road TN13 3LB Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 22759190001 | ||||
MANION, Kevin Patrick | Geschäftsführer | 26 Mayflower Parkway IRISH Westport Ct 06880. 6014 Usa | American | Chief Financial Officer | 71401310002 | |||||
MORAN, William Loyola | Geschäftsführer | 38 Braunview Way Orchard Park 14127 New York Usa | American | Chief Operating Officer | 68336410001 | |||||
REEVE, Robert Arthur | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 6 Wellesford Close SM7 2HL Banstead Surrey | British | 900007190001 | ||||||
SAUNDERS, Christopher John | Geschäftsführer | 35 Basinghall Street EC2V 5DB London | British | Solicitor | 21044340001 | |||||
SINGH, Jasbir | Geschäftsführer | 28 Fairholme Road West Kensington W14 9JX London | British | Banker | 50876200001 | |||||
TORRENS, Iain William | Geschäftsführer | Broadgate 2 Broadgate EC2M 7UR London 2 England | England | British | Chartered Accountant | 120015110001 | ||||
YOSHIDA, Rodney Neal | Geschäftsführer | 104 Arboresque Drive New Hope Pennsylvania 18938 Usa | American | Finance Director | 69659420002 |
Hat EBS NOMINEES LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Security agreement (governed by the laws of the state of new york) | Erstellt am 29. Juni 1996 Geliefert am 16. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the borrowers (as defined) to the chargee under the facilities agreement and all present and future obligations of the company to the chargee under the security agreement, the composite guarantee (as defined) and under each other agreement and instrument referred to in the facilities agreement to which the company is a party | |
Kurze Angaben The pledged stock, the stock collateral, accounts, instruments, inventory, equipment etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement (intellectual property; japan) | Erstellt am 29. Juni 1996 Geliefert am 16. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Any and all obligations from time to time of the company to the chargee under the composite guarantee (as defined) and the security agreement | |
Kurze Angaben All rights title and interest in the collateral. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture (singapore) (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined) | Erstellt am 29. Juni 1996 Geliefert am 16. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture (hong kong) (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined) | Erstellt am 29. Juni 1996 Geliefert am 16. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture (as amended by an amending deed dated 15TH july 1996 and made between the original companies as defined) | Erstellt am 29. Juni 1996 Geliefert am 16. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0