CONNAUGHT INTERIORS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CONNAUGHT INTERIORS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02651575 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Connaught House Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3QF Exeter Devon |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CONNAUGHT STRUCTURAL REPAIRS LIMITED | 21. Feb. 1995 | 21. Feb. 1995 |
| CONNAUGHT PROJECTS LIMITED | 18. Nov. 1991 | 18. Nov. 1991 |
| PENSEROSO LIMITED | 07. Okt. 1991 | 07. Okt. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Aug. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julia Cavanagh als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Wells als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Francis Wells am 02. Nov. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Tincknell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Julia Cavanagh als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Dr David Francis Wells am 15. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark William Tincknell am 15. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 395 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 9 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 10 Seiten | 395 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2007 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATESON, Anne Rosalind | Bevollmächtigter Sekretär | High Trees Great Holland CO13 0HZ Frinton On Sea Essex | British | 900007490001 | ||||||
| CAVANAGH, Julia | Sekretär | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3QF Exeter Connaught House Devon | British | 146842140001 | ||||||
| CRITCHLOW, Geoffrey David | Sekretär | 24 Windsor Square EX8 1JY Exmouth Devon | British | 47908530001 | ||||||
| MIDGLEY, Paul Frank | Sekretär | Newhaven Coldwell Lane EX14 4AJ Axmouth Devon | British | 68851460001 | ||||||
| PEAGAM, Garry John | Sekretär | The Four Winds 54 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GG Bath | British | 64426280002 | ||||||
| PHILLIPS, Jackey | Sekretär | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3QF Exeter Connaught House Devon | British | 104367080003 | ||||||
| PIKE, David Kenneth | Sekretär | Willow House 100 Sandford View TQ12 2TH Newton Abbot Devon | British | 99914770001 | ||||||
| TINCKNELL, Mark William | Sekretär | 4 Meadway EX10 9JA Sidmouth Devon | British | 4088810001 | ||||||
| COKER, Ross Adam | Geschäftsführer | 3 Ditton Green LU2 8RU Luton Bedfordshire | British | 29522470002 | ||||||
| CRITCHLOW, Geoffrey David | Geschäftsführer | 24 Windsor Square EX8 1JY Exmouth Devon | British | 47908530001 | ||||||
| DARKIN, Andrew | Geschäftsführer | Coombe Road Shaldon TQ14 0EX Teignmouth Broad Reach Devon | United Kingdom | British | 137575700001 | |||||
| LAI, Poh Lim | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 24 Redwood Drive LU7 0TA Wing Buckinghamshire | British | 900007480001 | ||||||
| MCNAUGHTON, Andrew Robert Paul | Geschäftsführer | Waddesdon Cottage 1 Grinstead Lane CM22 7QY Little Hallingbury Hertfordshire | British | 53282280004 | ||||||
| PIKE, David Kenneth | Geschäftsführer | Willow House 100 Sandford View TQ12 2TH Newton Abbot Devon | England | British | 99914770001 | |||||
| STANDING, Roger | Geschäftsführer | 63 Springwood Road TN21 8JX Heathfield East Sussex | British | 47913670001 | ||||||
| TINCKNELL, Mark William | Geschäftsführer | Hayne Barton Tipton St. John EX10 0AL Sidmouth Devon | England | British | 4088810003 | |||||
| WELLS, David Francis | Geschäftsführer | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3QF Exeter Connaught House Devon | United Kingdom | British | 104366980002 |
Hat CONNAUGHT INTERIORS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 06. Aug. 2009 Geliefert am 25. Aug. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 10. Juli 2009 Geliefert am 23. Juli 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A security agreement | Erstellt am 17. Aug. 2007 Geliefert am 31. Aug. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 13. Dez. 2006 Geliefert am 16. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Mai 2004 Geliefert am 20. Mai 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Nov. 2000 Geliefert am 10. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Juli 1999 Geliefert am 10. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0