CONNAUGHT INTERIORS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCONNAUGHT INTERIORS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02651575
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Connaught House Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Devon
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CONNAUGHT STRUCTURAL REPAIRS LIMITED21. Feb. 199521. Feb. 1995
    CONNAUGHT PROJECTS LIMITED18. Nov. 199118. Nov. 1991
    PENSEROSO LIMITED07. Okt. 199107. Okt. 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Aug. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Beendigung der Bestellung von Julia Cavanagh als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von David Wells als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David Francis Wells am 02. Nov. 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Aug. 2009

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Mark Tincknell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Julia Cavanagh als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Jahresrückblick erstellt bis 07. Okt. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital16. Okt. 2009

    Kapitalaufstellung am 16. Okt. 2009

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Dr David Francis Wells am 15. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mark William Tincknell am 15. Okt. 2009

    2 SeitenCH01

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten403a

    Beschlüsse

    Resolutions
    9 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    legacy

    10 Seiten395

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Satzung

    RES01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2008

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Aug. 2007

    16 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    Wer sind die Geschäftsführer von CONNAUGHT INTERIORS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BATESON, Anne Rosalind
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    Bevollmächtigter Sekretär
    High Trees
    Great Holland
    CO13 0HZ Frinton On Sea
    Essex
    British900007490001
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Sekretär
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British146842140001
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    Sekretär
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    British47908530001
    MIDGLEY, Paul Frank
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX14 4AJ Axmouth
    Devon
    Sekretär
    Newhaven
    Coldwell Lane
    EX14 4AJ Axmouth
    Devon
    British68851460001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Sekretär
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    British64426280002
    PHILLIPS, Jackey
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Sekretär
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British104367080003
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Sekretär
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    British99914770001
    TINCKNELL, Mark William
    4 Meadway
    EX10 9JA Sidmouth
    Devon
    Sekretär
    4 Meadway
    EX10 9JA Sidmouth
    Devon
    British4088810001
    COKER, Ross Adam
    3 Ditton Green
    LU2 8RU Luton
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    3 Ditton Green
    LU2 8RU Luton
    Bedfordshire
    British29522470002
    CRITCHLOW, Geoffrey David
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    Geschäftsführer
    24 Windsor Square
    EX8 1JY Exmouth
    Devon
    British47908530001
    DARKIN, Andrew
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    Geschäftsführer
    Coombe Road
    Shaldon
    TQ14 0EX Teignmouth
    Broad Reach
    Devon
    United KingdomBritish137575700001
    LAI, Poh Lim
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    24 Redwood Drive
    LU7 0TA Wing
    Buckinghamshire
    British900007480001
    MCNAUGHTON, Andrew Robert Paul
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Waddesdon Cottage
    1 Grinstead Lane
    CM22 7QY Little Hallingbury
    Hertfordshire
    British53282280004
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Geschäftsführer
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritish99914770001
    STANDING, Roger
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    Geschäftsführer
    63 Springwood Road
    TN21 8JX Heathfield
    East Sussex
    British47913670001
    TINCKNELL, Mark William
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    Geschäftsführer
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    EnglandBritish4088810003
    WELLS, David Francis
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Geschäftsführer
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    United KingdomBritish104366980002

    Hat CONNAUGHT INTERIORS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 06. Aug. 2009
    Geliefert am 25. Aug. 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 10. Juli 2009
    Geliefert am 23. Juli 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Juli 2009Registrierung einer Belastung (395)
    A security agreement
    Erstellt am 17. Aug. 2007
    Geliefert am 31. Aug. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Dez. 2006
    Geliefert am 16. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Mai 2004
    Geliefert am 20. Mai 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 20. Mai 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. Nov. 2000
    Geliefert am 10. Nov. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 10. Nov. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 30. Juli 1999
    Geliefert am 10. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0