FLEXIMEDIA LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameFLEXIMEDIA LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02654520
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von FLEXIMEDIA LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich FLEXIMEDIA LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von FLEXIMEDIA LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PRECIS (1128) LIMITED16. Okt. 199116. Okt. 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FLEXIMEDIA LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für FLEXIMEDIA LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für FLEXIMEDIA LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 0.10
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 05. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 3,430,447.1
    SH01

    legacy

    94 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 01. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 3,430,447.1
    SH01

    legacy

    92 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Beendigung der Bestellung von Caroline Withers als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mine Ozkan Hifzi als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Robert Dominic Dunn als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Gale als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 09. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 3,430,447.1
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    4 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Tillbrook als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von FLEXIMEDIA LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Sekretär
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    151020850001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish182167230001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Sekretär
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    British28242190001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Sekretär
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    TAYLOR, Richard George
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    Sekretär
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    British47989960001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Sekretär
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    2519400001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BRETT, Stephen Marc
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    Geschäftsführer
    2092 Hardscrabble Drive
    Boulder
    Colorado
    880303
    Usa
    American21673650001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-American52311710004
    BYNG, Timothy Howard St George, Viscount
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO17 2WL Winchester
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Great Hunts Place
    Owslebury
    SO17 2WL Winchester
    Hampshire
    British28242300001
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    British73000530008
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    HARMAN, Phillip Brent
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    Geschäftsführer
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    New Zealander51102310001
    KOPPEL, Montague
    20 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    Geschäftsführer
    20 Chapel Street
    SW1X 7BY London
    British63610140001
    LUARD, Roger David Eckford
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Rookwoods Water Lane
    Oakridge
    GL6 7PN Stroud
    Gloucestershire
    British28242190001
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Geschäftsführer
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    British37860010002
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish47785600002
    OPIE, Lisa Moreen
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish88563310001
    RAMPTON, Jack Leslie, Sir
    17 The Ridgeway
    TN10 4NQ Tonbridge
    Kent
    Geschäftsführer
    17 The Ridgeway
    TN10 4NQ Tonbridge
    Kent
    British13438080001
    SINGER, Adam Nicholas
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    8 Oxhey Road
    Oxhey
    WD1 4QE Watford
    Hertfordshire
    British35783020005
    SINGER, Adam Nicholas
    10747 East Crestline Circle
    Englewood Arapahoe Colorado 80111
    Usa
    Geschäftsführer
    10747 East Crestline Circle
    Englewood Arapahoe Colorado 80111
    Usa
    British35783020003
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    British79956240002
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TINDALE, Lawrence Victor Dolman
    3 Amyand Park Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    3 Amyand Park Gardens
    TW1 3HS Twickenham
    Middlesex
    British629850001
    WALL, Malcolm Robert
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    Geschäftsführer
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    EnglandBritish178772080002
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    YASSUKOVICH, Stanislas Michael
    37 Eaton Place
    SW1X 8DF London
    Geschäftsführer
    37 Eaton Place
    SW1X 8DF London
    American39995940002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    Hat FLEXIMEDIA LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 04. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 04. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Okt. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 10. Dez. 2009
    Geliefert am 17. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag
    Transaktionen
    • 17. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 25. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 23. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights title benefit and interest in and to a) all indebtedness from s from telewest UK limited, flextech investments (jersey) LTD or any member of the tcn's group b) any interest and other amounts due. A floating charge over all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC, in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 23. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of subordination
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 23. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The collateral instruments being the finance documents, any guarantees and any other documents or instruments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC, in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 23. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 02. März 2000
    Geliefert am 16. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All stocks shares and securities of any kind whatsoever whether marketable or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transaktionen
    • 16. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 27. Aug. 1997
    Geliefert am 12. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargees under the terms of the transaction documents (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    All the undertaking goodwill property assets and rights of such chargor as specified in the debenture (the "charged assets"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Toronto-Dominion Bank(In It's Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0