GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED

GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02656702
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Avant House 6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TEESRAN LIMITED25. Nov. 199125. Nov. 1991
    BIDEAWHILE ONE HUNDRED AND THREE LIMITED23. Okt. 199123. Okt. 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 30. Apr. 2016

    1 SeitenAA01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Edward Lewis am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Jonathan Ross Brodie am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Giles Henry Sharp am 22. Okt. 2015

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 22. Okt. 2015

    1 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG zum Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP am 23. Okt. 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Okt. 2015

    Kapitalaufstellung am 12. Okt. 2015

    • Kapital: GBP 31
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Geschäftsführer am 31. März 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Giles Sharp als Direktor am 23. Jan. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Neil Fitzsimmons als Geschäftsführer am 12. Dez. 2014

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 1 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 15. Dez. 2014

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital13. Okt. 2014

    Kapitalaufstellung am 13. Okt. 2014

    • Kapital: GBP 31
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    6 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Elizabeth Catchpole als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Jon William Mortimore als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital14. Okt. 2013

    Kapitalaufstellung am 14. Okt. 2013

    • Kapital: GBP 31
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    8 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Sekretär
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    147808030001
    BRODIE, Jonathan Ross
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    EnglandBritish62279790001
    LEWIS, Colin Edward
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    6 And 9 Tallys End
    Barlborough
    S43 4WP Chesterfield
    Avant House
    United Kingdom
    United KingdomBritish194659450001
    ASH, Christine Ann
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    18 Holbeck Avenue
    YO11 2XQ Scarborough
    North Yorkshire
    British67480001
    COOPER, Hilary Joan
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    73 Stepney Road
    YO12 5BT Scarborough
    North Yorkshire
    British51307940002
    FRASER, Leslie Murray Fraser
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    Sekretär
    20 Franklin Street
    YO12 7JU Scarborough
    North Yorkshire
    British53477320001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Sekretär
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Sekretär
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    British56953000002
    BWL SECRETARIES LIMITED
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    Bevollmächtigter Sekretär
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    900003770001
    BRODIE, Jonathan Ross
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    Geschäftsführer
    Barn Cottage Moon Lane
    Dormansland
    RH7 6PD Lingfield
    Surrey
    EnglandBritish62279790001
    BROWN, Carole Elizabeth
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    Geschäftsführer
    11 Yelvertoft Road
    Crick
    NN6 7TR Northampton
    Barn 1
    England
    England
    EnglandBritish98235420004
    BURNLEY, John Lewis
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    Geschäftsführer
    Lantern Cottage
    Weeton Lane, Weeton
    LS17 0AN Leeds
    EnglandBritish35543830001
    CAMERON, Alexander Douglas
    74 Old Barrack Road
    IP12 4ER Woodbridge
    Suffolk
    Geschäftsführer
    74 Old Barrack Road
    IP12 4ER Woodbridge
    Suffolk
    British5996730001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CLINTON, David
    213 Westburn Road
    AB2 4QF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Geschäftsführer
    213 Westburn Road
    AB2 4QF Aberdeen
    Aberdeenshire
    British30279690001
    COMER, Geoffrey Stephen
    Robin Cottage
    Mill Street
    CO6 5AD Polstead
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Robin Cottage
    Mill Street
    CO6 5AD Polstead
    Suffolk
    British56333770001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MORTIMORE, Jon William
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    Geschäftsführer
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United KingdomBritish207729000002
    WILSON, Peter George
    Acomb Mill
    The Ridings
    NE46 4PQ Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Acomb Mill
    The Ridings
    NE46 4PQ Hexham
    Northumberland
    British37238690003
    BWL SECRETARIES LIMITED
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    20-32 Museum Street
    IP1 1HZ Ipswich
    Suffolk
    900003770001

    Hat GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge
    Erstellt am 09. Jan. 2009
    Geliefert am 15. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £353,400.00 due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    The quadrangle lumely road horley t/no SY686086.
    Berechtigte Personen
    • Freehold Managers (Nominees) Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 30. Dez. 2008
    Geliefert am 09. Jan. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Okt. 2002
    Geliefert am 15. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property situate at warwick castle park, stratford road, warwick and the hunting lodge, leafield farm, stratford road, warwick t/nos. WK256708 and WK261596. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Okt. 2002
    Geliefert am 15. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a land and buildings lying on the south east side of the crescent, nottingham t/no. NT244678. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 2001
    Geliefert am 15. Dez. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings to the north east side of albert road horley t/no: SY686086. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 14. Juli 2000
    Geliefert am 27. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Jan. 1992
    Geliefert am 29. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that the property k/as or being 1.894 acres of land at ransomes europark,nacton road,ipswich,suffolk.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Jan. 1992
    Geliefert am 29. Jan. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Please see M127C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Jan. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Jan. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0