GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02656702 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
- Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
Wo befindet sich GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Avant House 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TEESRAN LIMITED | 25. Nov. 1991 | 25. Nov. 1991 |
| BIDEAWHILE ONE HUNDRED AND THREE LIMITED | 23. Okt. 1991 | 23. Okt. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2015 bis 30. Apr. 2016 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Colin Edward Lewis am 22. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jonathan Ross Brodie am 22. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Giles Henry Sharp am 22. Okt. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 22. Okt. 2015 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 30 High Street Westerham Kent TN16 1RG zum Avant House 6 and 9 Tallys End Barlborough Chesterfield S43 4WP am 23. Okt. 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jon William Mortimore als Geschäftsführer am 31. März 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Giles Sharp als Direktor am 23. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Fitzsimmons als Geschäftsführer am 12. Dez. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Joanne Elizabeth Massey am 15. Dez. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elizabeth Catchpole als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Jon William Mortimore als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 12. Okt. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Sekretär | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | 147808030001 | |||||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | England | British | 62279790001 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| SHARP, Giles Henry | Geschäftsführer | 6 And 9 Tallys End Barlborough S43 4WP Chesterfield Avant House United Kingdom | United Kingdom | British | 194659450001 | |||||
| ASH, Christine Ann | Sekretär | 18 Holbeck Avenue YO11 2XQ Scarborough North Yorkshire | British | 67480001 | ||||||
| COOPER, Hilary Joan | Sekretär | 73 Stepney Road YO12 5BT Scarborough North Yorkshire | British | 51307940002 | ||||||
| FRASER, Leslie Murray Fraser | Sekretär | 20 Franklin Street YO12 7JU Scarborough North Yorkshire | British | 53477320001 | ||||||
| GANDHI, Devendra | Sekretär | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MCBRIDE, Stephen Paul | Sekretär | Gryffe Main Street Upper Poppleton YO26 6EL York North Yorkshire | British | 56953000002 | ||||||
| BWL SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 20-32 Museum Street IP1 1HZ Ipswich Suffolk | 900003770001 | |||||||
| BRODIE, Jonathan Ross | Geschäftsführer | Barn Cottage Moon Lane Dormansland RH7 6PD Lingfield Surrey | England | British | 62279790001 | |||||
| BROWN, Carole Elizabeth | Geschäftsführer | 11 Yelvertoft Road Crick NN6 7TR Northampton Barn 1 England England | England | British | 98235420004 | |||||
| BURNLEY, John Lewis | Geschäftsführer | Lantern Cottage Weeton Lane, Weeton LS17 0AN Leeds | England | British | 35543830001 | |||||
| CAMERON, Alexander Douglas | Geschäftsführer | 74 Old Barrack Road IP12 4ER Woodbridge Suffolk | British | 5996730001 | ||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Geschäftsführer | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| CLINTON, David | Geschäftsführer | 213 Westburn Road AB2 4QF Aberdeen Aberdeenshire | British | 30279690001 | ||||||
| COMER, Geoffrey Stephen | Geschäftsführer | Robin Cottage Mill Street CO6 5AD Polstead Suffolk | British | 56333770001 | ||||||
| DIPRE, John Vivian | Geschäftsführer | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Geschäftsführer | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| GAFFNEY, David | Geschäftsführer | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Geschäftsführer | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Geschäftsführer | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| MCCABE, Kevin Charles | Geschäftsführer | The White House 13 Deepdale Avenue YO11 2UQ Scarborough North Yorkshire | British | 109250000001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Geschäftsführer | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent | United Kingdom | British | 207729000002 | |||||
| WILSON, Peter George | Geschäftsführer | Acomb Mill The Ridings NE46 4PQ Hexham Northumberland | British | 37238690003 | ||||||
| BWL SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 20-32 Museum Street IP1 1HZ Ipswich Suffolk | 900003770001 |
Hat GLADEDALE HOMES (SCARBOROUGH) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge | Erstellt am 09. Jan. 2009 Geliefert am 15. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £353,400.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben The quadrangle lumely road horley t/no SY686086. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Dez. 2008 Geliefert am 09. Jan. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 15. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property situate at warwick castle park, stratford road, warwick and the hunting lodge, leafield farm, stratford road, warwick t/nos. WK256708 and WK261596. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Okt. 2002 Geliefert am 15. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a land and buildings lying on the south east side of the crescent, nottingham t/no. NT244678. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 13. Dez. 2001 Geliefert am 15. Dez. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings to the north east side of albert road horley t/no: SY686086. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juli 2000 Geliefert am 27. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. Jan. 1992 Geliefert am 29. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that the property k/as or being 1.894 acres of land at ransomes europark,nacton road,ipswich,suffolk. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Jan. 1992 Geliefert am 29. Jan. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Please see M127C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0