REAL INNS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameREAL INNS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02662338
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von REAL INNS LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich REAL INNS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von REAL INNS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INHOCO 151 LIMITED12. Nov. 199112. Nov. 1991

    Welche sind die letzten Einreichungen für REAL INNS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 02. Jan. 2011

    6 SeitenAA

    Ernennung von Mr Stephen Rushworth Smith als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von William Rollason als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Juni 2011

    Kapitalaufstellung am 24. Juni 2011

    • Kapital: GBP 3,397,925
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Matthew Emerson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr William Rollason als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Simon George Rowe als Direktor

    2 SeitenAP01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 29. Juni 2010 bis 29. Dez. 2010

    1 SeitenAA01

    Ernennung von Matthew Charles Emerson als Direktor

    3 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Peter Hill als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Juni 2009

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 12. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 22. Juni 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss erstellt bis zum 24. Juni 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Wer sind die Geschäftsführer von REAL INNS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROWE, Simon George
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Geschäftsführer
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    EnglandBritish68119020002
    SMITH, Stephen Rushworth
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    Geschäftsführer
    Hatton Garden
    EC1N 8LE London
    63-66
    United KingdomBritish6894950002
    DANGERFIELD, John
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    Sekretär
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    British117743550001
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Sekretär
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    British148079910001
    JACKSON, Graham Michael, Dr
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    Sekretär
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    British20761790001
    JONES, Leonard Edward
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    British76599820001
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Sekretär
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    PINCUS, Barry Martin
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    Sekretär
    19 Willifield Way
    NW11 7XU London
    British46444010002
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    BASING, Nicholas Andrew
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    Geschäftsführer
    John Watkin Close
    KT19 7LW Epsom
    4
    Surrey
    EnglandBritish140766360001
    DANGERFIELD, John
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Pulford Place
    Wrexham Road
    CH4 9DG Pulford
    Cheshire
    British117743550001
    DARWIN, Richard James
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    Geschäftsführer
    25 Meadow Road
    KT10 0RZ Claygate
    Surrey
    United KingdomBritish148079910001
    DAVIES, Paul
    Greenacres
    Tamarix Close,Gedling
    NG4 4AJ Nottingham
    Geschäftsführer
    Greenacres
    Tamarix Close,Gedling
    NG4 4AJ Nottingham
    British5020990002
    ECKMIRE, John
    White Spinney
    10 Broomfield Ride
    KT22 0LW Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    White Spinney
    10 Broomfield Ride
    KT22 0LW Oxshott
    Surrey
    Canadian34831670001
    ECKMIRE, John
    White Spinney
    10 Broomfield Ride
    KT22 0LW Oxshott
    Surrey
    Geschäftsführer
    White Spinney
    10 Broomfield Ride
    KT22 0LW Oxshott
    Surrey
    Canadian34831670001
    ELMAN, Ralph
    1 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 6BP London
    Geschäftsführer
    1 Bickenhall Mansions
    Bickenhall Street
    W1U 6BP London
    British80068050001
    EMERSON, Matthew Charles
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    Geschäftsführer
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0DH London
    8-10
    EnglandBritish61777750002
    EVANS, Richard Henry
    28 Bassingham Road
    Wandsworth
    SW18 3AG London
    Geschäftsführer
    28 Bassingham Road
    Wandsworth
    SW18 3AG London
    EnglandBritish60529310001
    GEORGE, David Colbron
    4 Prescott Close
    NN3 5HZ Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    4 Prescott Close
    NN3 5HZ Northampton
    Northamptonshire
    British69592110001
    HILL, Peter Martin
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    Geschäftsführer
    Silver Crescent
    W4 5SE London
    8a
    EnglandBritish130983750001
    IZZA, Michael Donald Mccartney
    Sanza 2 Claremont Avenue
    KT10 9JD Esher
    Surrey
    Geschäftsführer
    Sanza 2 Claremont Avenue
    KT10 9JD Esher
    Surrey
    British27447890001
    JACKSON, Graham Michael, Dr
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Maesmor Hall
    Maerdy
    LL21 0NS Corwen
    Clwyd
    United KingdomBritish20761790001
    JONES, Leonard Edward
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    82 Royal Arch Apartments
    The Mailbox
    B1 1RB Birmingham
    West Midlands
    British76599820001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Geschäftsführer
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    PRICE, Robert Dennis
    Otters Bank Farm
    Fishpool Lane Delamere
    CW8 2HP Tarporley
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Otters Bank Farm
    Fishpool Lane Delamere
    CW8 2HP Tarporley
    Cheshire
    British22672440001
    ROE, Neil Clifford
    Wind Hill Church Road
    Thornton In Craven
    BD23 3TN Skipton
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Wind Hill Church Road
    Thornton In Craven
    BD23 3TN Skipton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish100873710001
    ROLLASON, William
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    Geschäftsführer
    8-10 Grosvenor Gardens
    London
    SW1W 0DH
    United KingdomBritish140347580001
    STANDING, Peter Heaton
    16 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NQ Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    16 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NQ Warrington
    Cheshire
    British23728590001
    TUPPEN, Graham Edward
    Kingswood House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    Kingswood House
    Pittville Circus Road
    GL52 2PZ Cheltenham
    Gloucestershire
    British9549960002
    WILLIAMS, Sean
    191 Southwood Road
    Rusthall
    TN4 8UX Tunbridge Wells
    Kent
    Geschäftsführer
    191 Southwood Road
    Rusthall
    TN4 8UX Tunbridge Wells
    Kent
    British40164940001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001

    Hat REAL INNS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 30. Aug. 2005
    Geliefert am 02. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the junior finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Starlight Investments Limited (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 02. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2005
    Geliefert am 27. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Nov. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Aug. 1998
    Geliefert am 28. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The talbot inn st georges telford t/no.SL41216. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 05. Mai 1995
    Geliefert am 23. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a the high bank ogden lane openshaw manchester originally forming part of t/n GM679102 the present and future goodwill of any business of a licensed publican and the benefit of all justices excise or other licences. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Apr. 1995
    Geliefert am 20. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land forming the site of 25 snowhill shelton in the city of stoke on trent. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Apr. 1995
    Geliefert am 13. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H licensed premises k/a the badger inn eccleshall staffordshire with the goodwill of the business & A. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 24. Feb. 1995
    Geliefert am 25. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H licensed premises k/a the halfway house silverdale road knutton newcastle under lyme staffordshire abd the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 1995
    Geliefert am 28. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the shoulder of mutton, fulford in the county of staffordshire. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 1995
    Geliefert am 28. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the wicket inn, formerly k/a the gate or the hanging gate inn, lea heath, admaston in the county of staffordshire. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property being the windsor castle, windsor street, liverpool, merseyside and adjoining land comprised in t/nos: MS7720, MS311012 and MS116388. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and property the westbourne hotel, 128 middleton road, oldham, greater manchester. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge over licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and property vittoria vaults, 55 vittoria street, birkenhead, wirral, merseyside. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge over licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property the union hotel, 145 hall street, st helens, merseyside t/no: LA371662. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a "the shakespeare" 8-10 horsedge street and also no: 12 horsedge street, oldham, greater manchester. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property "shady oak" comprised in an assignment dated 5TH november 1877 and f/h land comprised in a conveyance dated 10TH may 1924. fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge over licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and property k/a the salisbury hotel, marsh lane, liverpool, merseyside containing 551 square yards or thereabouts. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge over licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and property k/a the pointsman inn, whitelands road, stalybridge, tameside, greater manchester; and an adjoining plot of land. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and property "the plough inn" dinting vale, glossop, high peak, derbyshire. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property being the pingwood knowsley, merseyside; and the car park adjoining the property first described t/no: MS114993. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property "the nags head", hyde road, west gorton, manchester, greater manchester. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and property k/a "the merton arms" irlam road, bootle. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises "the egerton arms" egerton street, oldham, greater manchester. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property 158, 160 and 160A earle road, liverpool, merseyside t/no: MS7724. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and property the clarksfield hotel, 38 ronald street, oldham, greater manchester. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge of licensed premises
    Erstellt am 19. Dez. 1994
    Geliefert am 22. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a "the cheshire cheese public house, 101 and 103 lewin street, middlewich, congleton, cheshire t/no: CH328994. Fixed charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 22. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0