FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02664824 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Okt. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 21 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2018 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Notification of Edf Energy Renewables Limited as a person with significant control on 16. März 2018 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation of Edf Energy Renewables Holdings Limited as a person with significant control on 16. März 2018 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Hassaan Majid als Direktor am 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Owen John Henry Forster als Geschäftsführer am 01. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Geraldine Marie Roseline Anceau als Geschäftsführer am 01. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Change of details for Edf Energy Renewables Holdings Limited as a person with significant control on 23. Nov. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park, Houghton Le Spring Sunderland England DH4 5RA England zum Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park Houghton Le Spring, Sunderland England DH4 5RA am 24. Nov. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 40 Grosvenor Place London SW1X 7EN zum Alexander House 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park, Houghton Le Spring Sunderland England DH4 5RA am 24. Nov. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 17 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 15. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIND, Susan Elizabeth | Sekretär | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England | 195217100001 | |||||||
| HUE, Matthieu Thomas | Geschäftsführer | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England | England | French | 183883770001 | |||||
| MAJID, Hassaan | Geschäftsführer | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England | England | British | 227170770002 | |||||
| COLLINGWOOD, Martin Bernard | Sekretär | 727 Beverley High Road HU6 7ER Hull North Humberside | British | 70996440001 | ||||||
| HARDIE III, George William | Sekretär | 6858 Carolyn Crest Dallas Texas 75214 Usa | American | 75914880001 | ||||||
| HENDERSON, Robert Raymond | Sekretär | Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 United Kingdom | British | 65382610001 | ||||||
| JOHNSON, Andrew Robert | Sekretär | 5 Plough Farm Close HA4 7GH Ruislip Middlesex | British | 9845710001 | ||||||
| LARSEN, Bruno Kold | Sekretär | Egernsundvej 1 Silkeborg 8600 Denmark | Danish | 133554920001 | ||||||
| RAMSAY, Andrew Stephen James | Sekretär | The Manse Langford GL7 3LW Lechlade Gloucestershire | British | 76376410001 | ||||||
| SAMPSON, Jeremy Andrew | Sekretär | 10 Rowan Place HP6 6UR Amersham Buckinghamshire | British | 37740260002 | ||||||
| SHEPHERD, Clare Marie Ann | Sekretär | 18 Claremont Road Highgate N6 5BY London | British | 36244350001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ANCEAU, Geraldine Marie Roseline | Geschäftsführer | Grosvenor Place Victoria SW1X 7EN London 40 England England | France | French | 220722130001 | |||||
| ANDRE, Yvon Jean Marie | Geschäftsführer | 9 Rue Des Dardanelles Paris 75017 France | French | 109739740001 | ||||||
| BAKER, David Simon George | Geschäftsführer | Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 | United Kingdom | British | 197462530001 | |||||
| CHESTER, Peter Francis, Dr | Geschäftsführer | Tanglewood Pyle Hill Mayford GU22 0SR Woking Surrey | British | 21707600003 | ||||||
| CLINGENSMITH, Robert Lamont | Geschäftsführer | 5 Morningside Plumbland, Aspatria CA7 2EY Wigton Cumbria | American | 54465360002 | ||||||
| CROUZAT, Philippe | Geschäftsführer | Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 United Kingdom | France | French | 127904930002 | |||||
| EGAL, Christian Dominique Yves Marie | Geschäftsführer | Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 | France | French | 199687190001 | |||||
| EVANS, Thomas John | Geschäftsführer | Iona Strathallan Close Darley Dale DE4 2HJ Matlock Derbyshire | England | British | 38384630001 | |||||
| FORSTER, Owen John Henry | Geschäftsführer | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | England | British | 208859480001 | |||||
| GACA, John Alexander | Geschäftsführer | 19 Walden Lodge Close SN10 5BU Devires Wiltshire | British | 34143350001 | ||||||
| GUYLER, Robert | Geschäftsführer | Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 | Scotland | British | 183996210001 | |||||
| HARDIE III, George William | Geschäftsführer | 6858 Carolyn Crest Dallas Texas 75214 Usa | American | 75914880001 | ||||||
| HARRIS, Vincent Richard | Geschäftsführer | Ashlea Whiteway View Stratton GL7 2HY Cirencester Gloucestershire | England | British | 22138120001 | |||||
| JACKSON, Roderick James | Geschäftsführer | 2 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 58381220001 | ||||||
| JOHNSON, Andrew Robert | Geschäftsführer | 5 Plough Farm Close HA4 7GH Ruislip Middlesex | United Kingdom | British | 9845710001 | |||||
| JUIN, Laurence | Geschäftsführer | Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 United Kingdom | France | French | 153653210001 | |||||
| KNIGHT, Gordon Malcolm | Geschäftsführer | Treetops 38 Hale Road HP22 6NF Wendover Buckinghamshire | British | 35969440001 | ||||||
| LARSEN, Bruno Kold | Geschäftsführer | Grosvenor Place SW1X 7EN London 40 United Kingdom | Denmark | Danish | 133554920016 | |||||
| LINDLEY, David | Geschäftsführer | Woodfield House Farm Lane, Jordans HP9 2UP Beaconsfield Buckinghamshire | British | 84553070001 | ||||||
| LOPEZ-CACICEDO, Carlos, Dr | Geschäftsführer | Chaucers Ogbourne Maizey SN8 1XB Marlborough Wiltshire | Spanish | 14105600003 | ||||||
| LORD, Richard | Geschäftsführer | 31 Sweetcroft Lane UB10 9LE Hillingdon Middlesex | British | 32964470001 | ||||||
| MOURATOGLOU, Paris Paraskevas | Geschäftsführer | 64 Boulevard D' Inkermann Neuilly Sur Seine 92200 France | France | French | 88093180001 | |||||
| OGLE, Roger Anthony | Geschäftsführer | Fewster Barn Fewster Road GL6 0DH Nailsworth Gloucestershire | United Kingdom | British | 78166840001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edf Energy Renewables Limited | 16. März 2018 | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Edf Energy Renewables Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 1 Mandarin Road Rainton Bridge Business Park DH4 5RA Houghton Le Spring, Sunderland Alexander House England England | Ja | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FIRST WINDFARM HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 31. März 2003 Geliefert am 02. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 21. Aug. 2002 Geliefert am 05. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture between westbury windfarms limited, cemmaes windfarm limited, cold northcott windfarm limited, llangwyryfon windfarm limited, tregulland windfarm limited, great orton windfarm ii limited, first windfarm holdings limited, (together the "group members") and fortis bank S.A./N.V. | Erstellt am 31. Okt. 2001 Geliefert am 08. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future moneys, obligations and liabilities from time to time due, (whether owed jointly or severally or in any capacity whatsoever of each group member to the chargee), owing or incurred by the company under or pursuant to: (a) the secured documents (b) the guarantees and indemnities given by the company under the debenture, which secure all the obligations under the secured documents and each of the company and the group members; and (c) all other provisions of the debenture (all terms as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 23. Jan. 2001 Geliefert am 24. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabbilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to a facility agreement dated 3RD december 1998 a composite guarantee and debenture dated 3RD december 1998 , as amended by the debenture | |
Kurze Angaben The l/h property being llangwyrfron windfarm cemmaes windfarm and great orton windfarm. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 03. Dez. 1998 Geliefert am 17. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities from time to time due, owing or incurred by the company to the chargee under or pursuant to: (a) a facility agreement dated 3RD december 1998 and made between westbury windfarms limited (the "borrower") and the lender, as that agreement may from time to time be amended, varied, novated, supplemented or replaced (the "facility agreement"); or (b) the debenture | |
Kurze Angaben First fixed charges over all of the present and future assets of the company of the following types: land, interests in land and fixtures, plant, machinery and equipment, goodwill and uncalled capital; it also creates a first floating charge over all other present and future assets of the company.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Feb. 1992 Geliefert am 13. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company to any bank secured creditors (as defined in the deed) on any account whatsoever under the terms of any of the finance documents (as defined in the deed) | |
Kurze Angaben (For full details see form 395 tc ref: M44). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0