AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02666866 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o CLB COPPERS Century House 11 St. Peters Square M2 3DN Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NOVASIDE LIMITED | 24. Sept. 1999 | 24. Sept. 1999 |
| AVONSIDE GROUP LIMITED | 05. Feb. 1992 | 05. Feb. 1992 |
| CSI BUILDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | 28. Nov. 1991 | 28. Nov. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2008 |
Welche sind die letzten Einreichungen für AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 3 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Churchill House Regent Road Stoke on Trent Staffordshire ST1 3RQ am 13. Jan. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Denise Walker als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Nov. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Denise Margaret Walker am 02. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2004 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2003 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 6 Seiten | 363s | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLO, John Lambie | Sekretär | 41 Gleneagles Drive Penwortham PR1 0JT Preston | British | 634410003 | ||||||
| WALKER, Jonathan James | Geschäftsführer | Haberfield Old Moor Road Wennington LA2 8PD Lancaster Lancashire | England | British | 39444010001 | |||||
| O'BRIEN, Neil Christopher | Sekretär | Alexandra House 11 St Catherine Drive Hartford CW8 2FE Northwich Cheshire | British | 58219210001 | ||||||
| RIMMER, David Norman | Sekretär | Ridgefield 23 Newport Road ST21 6BE Eccleshall Staffordshire | British | 71617270002 | ||||||
| SLATER, Richard Craig Alan | Sekretär | Timbers The Spinney Springfield Lane LL12 8TG Marford Clwyd | British | 37111560003 | ||||||
| STEWART, Alan James | Sekretär | Hazliebrae 38 Dalziel Drive G41 4HY Glasgow Scotland | British | 49964620002 | ||||||
| WILD, Pamela Jayne | Sekretär | 4 Pendine Close Callands WA5 5RQ Warrington Cheshire | British | 64167100001 | ||||||
| BALL, John Alexander | Geschäftsführer | 8 Weaver Place East Kilbride G75 8SH Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 1011280002 | |||||
| BURKE, Anthony | Geschäftsführer | 5 Stanney Close Milnrow OL16 4BF Rochdale Lancashire | British | 58500120001 | ||||||
| CARRUTH, Gordon William | Geschäftsführer | 90 Southwold Road Ralston PA1 3AL Paisley Renfrewshire | British | 403770001 | ||||||
| DICKINSON, Ronald William | Geschäftsführer | 57 Redland Drive HU10 7UX Kirkella North Humberside | British | 25252540005 | ||||||
| GLYNN, Christopher | Geschäftsführer | Cliffordine House Selsley GL5 5LB Stroud Gloucestershire | British | 18296920001 | ||||||
| GRAY, Colin Francis | Geschäftsführer | 29 Holmdene Avenue SE24 9LB London | British | 17566780001 | ||||||
| HUMPHREY, David Trevor | Geschäftsführer | 29 Cedar Grove LA9 5BL Kendal Cumbria | British | 48367960002 | ||||||
| LEE, David | Geschäftsführer | 1 Orchard Court Heath Lane WA3 7DH Croft Cheshire | British | 77825310004 | ||||||
| MACK, Christopher Charles Robert | Geschäftsführer | 18 Oakley Park BL1 5XL Bolton Lancashire | British | 158640001 | ||||||
| MURRAY, Stephen | Geschäftsführer | Went View Great North Road WF8 3JP Wentbridge West Yorkshire | United Kingdom | British | 90170480001 | |||||
| O'BRIEN, Neil Christopher | Geschäftsführer | Alexandra House 11 St Catherine Drive Hartford CW8 2FE Northwich Cheshire | British | 58219210001 | ||||||
| PALIN, Robert Hornby | Geschäftsführer | Parkholm Springfield Park Overton On Dee LL13 0EX Wrexham Clwyd Wales | British | 46962730001 | ||||||
| PHILLIPS, Ronald Luther Desmond | Geschäftsführer | Pembroke House 71 B The Common WN8 7EA Parbold Lancashire | British | 10631600003 | ||||||
| SAYERS, Steven | Geschäftsführer | 5 Courcelles Court KY13 8FT Kinross Fife | United Kingdom | British | 91113050001 | |||||
| SCOWCROFT, Brian | Geschäftsführer | 1 Northwold Drive BL1 5BH Bolton Lancashire | British | 16196010001 | ||||||
| SLATER, Richard Craig Alan | Geschäftsführer | Timbers The Spinney Springfield Lane LL12 8TG Marford Clwyd | British | 37111560003 | ||||||
| STEWART, Alan James | Geschäftsführer | Hazliebrae 38 Dalziel Drive G41 4HY Glasgow Scotland | Scotland | British | 49964620002 | |||||
| TALBOT RICE, Nicholas Charles | Geschäftsführer | Pigeon House Coln Rogers BL54 3LB Cheltenham Gloucestershire | England | British | 2830650001 | |||||
| WALKER, Denise Margaret | Geschäftsführer | Haberfield Old Moor Road Wennington LA2 8PD Lancaster Lancashire | England | British | 99687220001 | |||||
| WALKER, Malcolm Charles | Geschäftsführer | 2 Woodside Greenacres Greenstiles Lane Swanland HU14 3NH North Ferriby North Humberside | British | 25252520004 |
Hat AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture (in respect of units 1-5 holden road industrial estate,leigh,cheshire;title numbers GM565948 and GM831938) | Erstellt am 07. Apr. 2003 Geliefert am 15. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Including units 1-5 holden road industrial estate,leigh,cheshire; t/nos GM565948 and GM831983. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to a mortgage deed dated 4 august 1999 | Erstellt am 22. Nov. 2002 Geliefert am 03. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land on the south east side of platt fold street leigh wigan greater manchester t/no: GM138559. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1999 Geliefert am 11. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1999 Geliefert am 11. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 04. Aug. 1999 Geliefert am 11. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat AVONSIDE GROUP HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0