NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02667954 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?
- Vorschule (85100) / Erziehung
Wo befindet sich NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 2 Crown Way NN10 6BS Rushden Northamptonshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 18. Nov. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mary Ann Tocio als Geschäftsführer am 01. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 10. Apr. 2014 bis 31. Dez. 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 10. Apr. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 14 vollständig | 5 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Erfüllung der Belastung 13 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Dreier als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr David Lissy als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mary Ann Tocio als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Elizabeth Boland als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Stephen Kramer als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jeremy Clark als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Darren Powell als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER, Stephen | Sekretär | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | 177507130001 | |||||||
| BOLAND, Elizabeth | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | United States | American | 70853820001 | |||||
| DREIER, Stephen | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | United States | American | 170443250001 | |||||
| LISSY, Dave | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | United States | American | 218331690001 | |||||
| ARNOLD, Shane | Sekretär | 34 Highclove Lane M28 1GZ Worsley Lancashire | British | 106525210001 | ||||||
| CARR, Neil Gordon | Sekretär | Orrells Well Farm Foden Lane SK9 7TH Alderley Edge Cheshire | British | 98929500001 | ||||||
| CHADWICK, Claire Marie | Sekretär | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | 168034760001 | |||||||
| CHALMERS MORRIS, Stephen Geoffrey | Sekretär | 55 Barcheston Road SK8 1LJ Cheadle Cheshire | British | 58641010002 | ||||||
| MARSHALL, Rosamund Margaret | Sekretär | Kidsunlimited Summerfields Village Centre SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow Cheshire | British | 157022340001 | ||||||
| PEARSON, James Lee | Sekretär | Rookery Cottages Chester Road Hartford CW8 1LL Northwich 4 Cheshire United Kingdom | British | 185162450001 | ||||||
| PICKERING, Stewart | Sekretär | 126 Gravel Lane SK9 6EG Wilmslow Cheshire | British | 11857260003 | ||||||
| THOMPSON, Paul Simon | Sekretär | Kidsunlimited Summerfields Village Centre SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow Cheshire | British | 149567910001 | ||||||
| TRAVIS, Mark | Sekretär | 18 Gibsons Road Heaton Moor SK4 4JX Stockport Cheshire | British | 58227670002 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| BACH, Karen | Geschäftsführer | Kent Street RH13 8BE Cowfold Potts Cottage W Sussex Uk | United Kingdom | British | 160940730001 | |||||
| CARR, Neil Gordon | Geschäftsführer | Orrells Well Farm Foden Lane SK9 7TH Alderley Edge Cheshire | United Kingdom | British | 98929500001 | |||||
| CHALMERS MORRIS, Stephen Geoffrey | Geschäftsführer | 55 Barcheston Road SK8 1LJ Cheadle Cheshire | British | 58641010002 | ||||||
| CLARK, Jeremy | Geschäftsführer | Willington Road Willington CW6 0ND Tarporley 3 Oak Bank Cheshire England | England | British | 153453360001 | |||||
| HOLLOWAY, Adam Stuart | Geschäftsführer | Flat 1 231-5 Liverpool Road Islington N1 1LX London | United Kingdom | British | 80088960001 | |||||
| HOUGHTON, Catherine Laura Jane | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | England | British | 140056480001 | |||||
| MARSHALL, Rosamund Margaret | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | United Kingdom | British | 149527430001 | |||||
| PACE, Martin | Geschäftsführer | Christmas Farm Picketts Lane RH1 5RG Salfords Surrey | England | British | 74305820001 | |||||
| PEARSON, James Lee | Geschäftsführer | Rookery Cottages Chester Road Hartford CW8 1LL Northwich 4 Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 185162450001 | |||||
| PICKERING, Jean | Geschäftsführer | 62 Moss Road SK9 7JB Alderley Edge Cheshire | British | 11857270004 | ||||||
| PICKERING, Stewart Ward | Geschäftsführer | 62 Moss Road SK9 7JB Alderley Edge Cheshire | England | British | 11857260004 | |||||
| POWELL, Darren Roy | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | England | British | 169093510001 | |||||
| SHAW, Robert Marshall | Geschäftsführer | The Whins Macclesfield Road SK9 7BL Alderley Edge Cheshire | British | 20786010001 | ||||||
| SMITH, Graham | Geschäftsführer | Moor Lane LS297AF Burley In Wharfedale Briarfield West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 142125320001 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Geschäftsführer | Crown Way NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire England | Usa | Usa | 177507090001 | |||||
| WINSTANLEY, Christopher Robert | Geschäftsführer | Clayton Greaves House Hope Lane Adlington SK10 4NX Stockport Cheshire | British | 82735530001 | ||||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Hat NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment by way of security | Erstellt am 28. Okt. 2008 Geliefert am 31. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right,title and interest in and to the jct design and build contract dated 20 september 2007 see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Group debenture | Erstellt am 04. Apr. 2008 Geliefert am 12. Apr. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Nov. 2007 Geliefert am 21. Nov. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Feb. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that l/h property k/a regents placenursery unit 1 (ground floor premises) triton square mall regents place longford. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Feb. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Feb. 2003 Geliefert am 12. Feb. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h property k/a st marys nursery st marys courtyard st marys street hume manchester M15 5WB t/n GM715743. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 11. Juli 2002 Geliefert am 30. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from or by any charging company to the designated noteholders or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Juni 2001 Geliefert am 05. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan note instrument constituting fixed rate guaranteed secured loan notes due 2008 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Apr. 1999 Geliefert am 11. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a land and buildings on the south west side of st mary's street moss side hulme manchester (formerly st mary's church hall) t/n GM715743. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Apr. 1999 Geliefert am 11. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a land at summerfields village centre dean row road wilmslow macclesfield cheshire t/n CH423712. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 30. Apr. 1999 Geliefert am 11. Mai 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 08. März 1999 Geliefert am 22. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at oxford business park garsington rd,oxford; part t/no ox 156347. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage deed | Erstellt am 27. Feb. 1998 Geliefert am 05. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The leasehold property known as or being plot of land fronting dean row road wilmslow cheshire. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Okt. 1993 Geliefert am 11. Okt. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0