NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED

NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02667954
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?

    • Vorschule (85100) / Erziehung

    Wo befindet sich NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2 Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 27. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital17. Dez. 2015

    Kapitalaufstellung am 17. Dez. 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 18. Nov. 2015

    • Kapital: GBP 100
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06
    capital

    Beschlüsse

    Share premium account be cancelled 03/11/2015
    RES13

    Beendigung der Bestellung von Mary Ann Tocio als Geschäftsführer am 01. Juni 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 23,730
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    12 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 10. Apr. 2014 bis 31. Dez. 2013

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 10. Apr. 2013

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Dez. 2013

    Kapitalaufstellung am 19. Dez. 2013

    • Kapital: GBP 23,729
    SH01

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    5 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    4 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Stephen Dreier als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr David Lissy als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mary Ann Tocio als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Elizabeth Boland als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Stephen Kramer als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Jeremy Clark als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Darren Powell als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    KRAMER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Sekretär
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    177507130001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United StatesAmerican170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United StatesAmerican218331690001
    ARNOLD, Shane
    34 Highclove Lane
    M28 1GZ Worsley
    Lancashire
    Sekretär
    34 Highclove Lane
    M28 1GZ Worsley
    Lancashire
    British106525210001
    CARR, Neil Gordon
    Orrells Well Farm
    Foden Lane
    SK9 7TH Alderley Edge
    Cheshire
    Sekretär
    Orrells Well Farm
    Foden Lane
    SK9 7TH Alderley Edge
    Cheshire
    British98929500001
    CHADWICK, Claire Marie
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Sekretär
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    168034760001
    CHALMERS MORRIS, Stephen Geoffrey
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    Sekretär
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    British58641010002
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    British157022340001
    PEARSON, James Lee
    Rookery Cottages Chester Road
    Hartford
    CW8 1LL Northwich
    4
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Rookery Cottages Chester Road
    Hartford
    CW8 1LL Northwich
    4
    Cheshire
    United Kingdom
    British185162450001
    PICKERING, Stewart
    126 Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    126 Gravel Lane
    SK9 6EG Wilmslow
    Cheshire
    British11857260003
    THOMPSON, Paul Simon
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    Sekretär
    Kidsunlimited
    Summerfields Village Centre
    SK9 2TA Dean Row Road, Wilmslow
    Cheshire
    British149567910001
    TRAVIS, Mark
    18 Gibsons Road
    Heaton Moor
    SK4 4JX Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    18 Gibsons Road
    Heaton Moor
    SK4 4JX Stockport
    Cheshire
    British58227670002
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BACH, Karen
    Kent Street
    RH13 8BE Cowfold
    Potts Cottage
    W Sussex
    Uk
    Geschäftsführer
    Kent Street
    RH13 8BE Cowfold
    Potts Cottage
    W Sussex
    Uk
    United KingdomBritish160940730001
    CARR, Neil Gordon
    Orrells Well Farm
    Foden Lane
    SK9 7TH Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Orrells Well Farm
    Foden Lane
    SK9 7TH Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritish98929500001
    CHALMERS MORRIS, Stephen Geoffrey
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    Geschäftsführer
    55 Barcheston Road
    SK8 1LJ Cheadle
    Cheshire
    British58641010002
    CLARK, Jeremy
    Willington Road
    Willington
    CW6 0ND Tarporley
    3 Oak Bank
    Cheshire
    England
    Geschäftsführer
    Willington Road
    Willington
    CW6 0ND Tarporley
    3 Oak Bank
    Cheshire
    England
    EnglandBritish153453360001
    HOLLOWAY, Adam Stuart
    Flat 1 231-5 Liverpool Road
    Islington
    N1 1LX London
    Geschäftsführer
    Flat 1 231-5 Liverpool Road
    Islington
    N1 1LX London
    United KingdomBritish80088960001
    HOUGHTON, Catherine Laura Jane
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish140056480001
    MARSHALL, Rosamund Margaret
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    United KingdomBritish149527430001
    PACE, Martin
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    Geschäftsführer
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    EnglandBritish74305820001
    PEARSON, James Lee
    Rookery Cottages Chester Road
    Hartford
    CW8 1LL Northwich
    4
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Rookery Cottages Chester Road
    Hartford
    CW8 1LL Northwich
    4
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish185162450001
    PICKERING, Jean
    62 Moss Road
    SK9 7JB Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    62 Moss Road
    SK9 7JB Alderley Edge
    Cheshire
    British11857270004
    PICKERING, Stewart Ward
    62 Moss Road
    SK9 7JB Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    62 Moss Road
    SK9 7JB Alderley Edge
    Cheshire
    EnglandBritish11857260004
    POWELL, Darren Roy
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    EnglandBritish169093510001
    SHAW, Robert Marshall
    The Whins Macclesfield Road
    SK9 7BL Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Whins Macclesfield Road
    SK9 7BL Alderley Edge
    Cheshire
    British20786010001
    SMITH, Graham
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Moor Lane
    LS297AF Burley In Wharfedale
    Briarfield
    West Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish142125320001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    Geschäftsführer
    Crown Way
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    England
    UsaUsa177507090001
    WINSTANLEY, Christopher Robert
    Clayton Greaves House
    Hope Lane Adlington
    SK10 4NX Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Clayton Greaves House
    Hope Lane Adlington
    SK10 4NX Stockport
    Cheshire
    British82735530001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    Hat NURSERY EDUCATION FOR EMPLOYMENT DEVELOPMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignment by way of security
    Erstellt am 28. Okt. 2008
    Geliefert am 31. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right,title and interest in and to the jct design and build contract dated 20 september 2007 see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 31. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Group debenture
    Erstellt am 04. Apr. 2008
    Geliefert am 12. Apr. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Agent (Security Agent)
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Apr. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 15. Nov. 2007
    Geliefert am 21. Nov. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transaktionen
    • 21. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h property k/a regents placenursery unit 1 (ground floor premises) triton square mall regents place longford. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Feb. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Feb. 2003
    Geliefert am 12. Feb. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h property k/a st marys nursery st marys courtyard st marys street hume manchester M15 5WB t/n GM715743. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 12. Feb. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 11. Juli 2002
    Geliefert am 30. Juli 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from or by any charging company to the designated noteholders or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Isis Capital PLC
    Transaktionen
    • 30. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 2001
    Geliefert am 05. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the loan note instrument constituting fixed rate guaranteed secured loan notes due 2008
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Friends Ivory & Sime Private Equity PLC,as Agent for Itself and the Holdersfrom Time to Time of the Notes
    Transaktionen
    • 05. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1999
    Geliefert am 11. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a land and buildings on the south west side of st mary's street moss side hulme manchester (formerly st mary's church hall) t/n GM715743. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1999
    Geliefert am 11. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a land at summerfields village centre dean row road wilmslow macclesfield cheshire t/n CH423712. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 30. Apr. 1999
    Geliefert am 11. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 08. März 1999
    Geliefert am 22. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at oxford business park garsington rd,oxford; part t/no ox 156347. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 27. Feb. 1998
    Geliefert am 05. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The leasehold property known as or being plot of land fronting dean row road wilmslow cheshire. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Okt. 1993
    Geliefert am 11. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0