CROMWELL PUBLISHING LTD
Überblick
| Unternehmensname | CROMWELL PUBLISHING LTD |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02669673 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CROMWELL PUBLISHING LTD?
- Filmproduktionsaktivitäten (59111) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich CROMWELL PUBLISHING LTD?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 364-366 Kensington High Street W14 8NS London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CROMWELL PUBLISHING LTD?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CROMWELL PRODUCTIONS LIMITED | 10. Dez. 1991 | 10. Dez. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROMWELL PUBLISHING LTD?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CROMWELL PUBLISHING LTD?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CROMWELL PUBLISHING LTD?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Charles Maximilian Hole als Geschäftsführer am 07. Okt. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 10 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Marriott Harrison Staple Court 11 Staple Inn Buildings London WC1V 7QH zum Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Abolanle Abioye als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Constant als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 7 Seiten | MEM/ARTS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 3 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Boyd Johnston Muir als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christopher Charles Maximilian Hole als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Brown als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Michael Constant als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Richard Michael Constant als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CROMWELL PUBLISHING LTD?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIOYE, Abolanle | Sekretär | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 England | 189305530001 | |||||||
| BROWN, Andrew | Geschäftsführer | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 England | England | British | 163199590001 | |||||
| CONSTANT, Richard Michael | Geschäftsführer | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 England | United Kingdom | British | 43836310003 | |||||
| HOSKEN, Simon William Harvey | Geschäftsführer | 57 Park Road Chiswick W4 3EY London | England | British | 55992140002 | |||||
| KEMPIN, Geoffrey Manton | Geschäftsführer | 91 Madrid Road Barnes SW13 9PQ London | United Kingdom | British | 76904050001 | |||||
| MUIR, Boyd Johnston | Geschäftsführer | Colorado Avenue CA90404 Santa Monica 2220 Usa | United States | British | 172824510001 | |||||
| SHAND, Terence Richard | Geschäftsführer | Green Place The Street GU5 0PF Wonersh Surrey | United Kingdom | British | 4641400004 | |||||
| BLANCHARD, Jonathan Neil | Sekretär | 1 Little Gaddesden House Little Gaddesden HP4 1PL Berkhamsted Hertfordshire | British | 67243220003 | ||||||
| CARRUTHERS, Michelle Ayson | Sekretär | 6 New Street Tiddington CV37 7DA Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 29275540001 | ||||||
| CONSTANT, Richard Michael | Sekretär | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 England | 186780880001 | |||||||
| GAMBOLD, Clare Anne | Sekretär | Walnut Cottage 1 Manor Court Harbury CV33 9ND Leamington Spa Warwickshire | British | 89977300001 | ||||||
| HOSKEN, Simon William Harvey | Sekretär | 57 Park Road Chiswick W4 3EY London | British | 55992140002 | ||||||
| PAUL, Julian Braithwaite | Sekretär | The Mount House Brasted TN16 1JB Westerham Kent | British | 47213190001 | ||||||
| BLANCHARD, Jonathan Neil | Geschäftsführer | 1 Little Gaddesden House Little Gaddesden HP4 1PL Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 67243220003 | |||||
| CARRUTHERS, Robert Kirk | Geschäftsführer | The Old House The Green Luddington CV37 6SJ Stratford Upon Avon Warwickshire | British | 20921970002 | ||||||
| HOLE, Christopher Charles Maximilian | Geschäftsführer | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 England | England | British | 4384150008 | |||||
| PAUL, Julian Braithwaite | Geschäftsführer | The Mount House Brasted TN16 1JB Westerham Kent | United Kingdom | British | 47213190001 | |||||
| RUSSELL, Gary John | Geschäftsführer | Queens Anne Grove Bedford Park, Chiswick W4 1QP London 6 | United Kingdom | British | 63636970005 |
Hat CROMWELL PUBLISHING LTD Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage debenture | Erstellt am 23. Jan. 2012 Geliefert am 01. Feb. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the noteholders and security trustee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 01. Feb. 2010 Geliefert am 05. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge over intellectual property rights | Erstellt am 01. Feb. 2010 Geliefert am 05. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First fixed charge in favour of the bank all the charged property, meaning the intellectual property rights and any goodwill in relation to those rights see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 01. Feb. 2010 Geliefert am 04. Feb. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the noteholders or the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Apr. 2007 Geliefert am 02. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 30. Juli 2004 Geliefert am 14. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben (Including without limitation eagle house, 22 armoury way, london t/no. TGL40217). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge over intellectual property rights | Erstellt am 21. Dez. 2001 Geliefert am 08. Jan. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all the charged property being the intellectual property rights any goodwill of the chargors business. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 11. Apr. 2001 Geliefert am 13. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 10. März 1995 Geliefert am 15. März 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0