CROMWELL PUBLISHING LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCROMWELL PUBLISHING LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02669673
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CROMWELL PUBLISHING LTD?

    • Filmproduktionsaktivitäten (59111) / Information und Kommunikation

    Wo befindet sich CROMWELL PUBLISHING LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    364-366 Kensington High Street
    W14 8NS London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CROMWELL PUBLISHING LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROMWELL PRODUCTIONS LIMITED10. Dez. 199110. Dez. 1991

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROMWELL PUBLISHING LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CROMWELL PUBLISHING LTD?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CROMWELL PUBLISHING LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Charles Maximilian Hole als Geschäftsführer am 07. Okt. 2015

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    9 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    9 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    10 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital01. Dez. 2014

    Kapitalaufstellung am 01. Dez. 2014

    • Kapital: GBP 101
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Marriott Harrison Staple Court 11 Staple Inn Buildings London WC1V 7QH zum Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS geändert

    1 SeitenAD02

    Ernennung von Mrs Abolanle Abioye als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Richard Constant als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    7 SeitenMEM/ARTS

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Erfüllung der Belastung 7 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 5 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 6 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    4 SeitenMR04

    Ernennung von Mr Boyd Johnston Muir als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Christopher Charles Maximilian Hole als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Andrew Brown als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Richard Michael Constant als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Richard Michael Constant als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CROMWELL PUBLISHING LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ABIOYE, Abolanle
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    Sekretär
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    189305530001
    BROWN, Andrew
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    Geschäftsführer
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    EnglandBritish163199590001
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    Geschäftsführer
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    United KingdomBritish43836310003
    HOSKEN, Simon William Harvey
    57 Park Road
    Chiswick
    W4 3EY London
    Geschäftsführer
    57 Park Road
    Chiswick
    W4 3EY London
    EnglandBritish55992140002
    KEMPIN, Geoffrey Manton
    91 Madrid Road
    Barnes
    SW13 9PQ London
    Geschäftsführer
    91 Madrid Road
    Barnes
    SW13 9PQ London
    United KingdomBritish76904050001
    MUIR, Boyd Johnston
    Colorado Avenue
    CA90404 Santa Monica
    2220
    Usa
    Geschäftsführer
    Colorado Avenue
    CA90404 Santa Monica
    2220
    Usa
    United StatesBritish172824510001
    SHAND, Terence Richard
    Green Place
    The Street
    GU5 0PF Wonersh
    Surrey
    Geschäftsführer
    Green Place
    The Street
    GU5 0PF Wonersh
    Surrey
    United KingdomBritish4641400004
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    1 Little Gaddesden House
    Little Gaddesden
    HP4 1PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    Sekretär
    1 Little Gaddesden House
    Little Gaddesden
    HP4 1PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    British67243220003
    CARRUTHERS, Michelle Ayson
    6 New Street
    Tiddington
    CV37 7DA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Sekretär
    6 New Street
    Tiddington
    CV37 7DA Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British29275540001
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    Sekretär
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    186780880001
    GAMBOLD, Clare Anne
    Walnut Cottage 1 Manor Court
    Harbury
    CV33 9ND Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    Walnut Cottage 1 Manor Court
    Harbury
    CV33 9ND Leamington Spa
    Warwickshire
    British89977300001
    HOSKEN, Simon William Harvey
    57 Park Road
    Chiswick
    W4 3EY London
    Sekretär
    57 Park Road
    Chiswick
    W4 3EY London
    British55992140002
    PAUL, Julian Braithwaite
    The Mount House
    Brasted
    TN16 1JB Westerham
    Kent
    Sekretär
    The Mount House
    Brasted
    TN16 1JB Westerham
    Kent
    British47213190001
    BLANCHARD, Jonathan Neil
    1 Little Gaddesden House
    Little Gaddesden
    HP4 1PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Little Gaddesden House
    Little Gaddesden
    HP4 1PL Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish67243220003
    CARRUTHERS, Robert Kirk
    The Old House The Green
    Luddington
    CV37 6SJ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Old House The Green
    Luddington
    CV37 6SJ Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British20921970002
    HOLE, Christopher Charles Maximilian
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    Geschäftsführer
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    England
    EnglandBritish4384150008
    PAUL, Julian Braithwaite
    The Mount House
    Brasted
    TN16 1JB Westerham
    Kent
    Geschäftsführer
    The Mount House
    Brasted
    TN16 1JB Westerham
    Kent
    United KingdomBritish47213190001
    RUSSELL, Gary John
    Queens Anne Grove
    Bedford Park, Chiswick
    W4 1QP London
    6
    Geschäftsführer
    Queens Anne Grove
    Bedford Park, Chiswick
    W4 1QP London
    6
    United KingdomBritish63636970005

    Hat CROMWELL PUBLISHING LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage debenture
    Erstellt am 23. Jan. 2012
    Geliefert am 01. Feb. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the noteholders and security trustee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Beringea LLP (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2010
    Geliefert am 05. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Fixed charge over intellectual property rights
    Erstellt am 01. Feb. 2010
    Geliefert am 05. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    First fixed charge in favour of the bank all the charged property, meaning the intellectual property rights and any goodwill in relation to those rights see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Feb. 2010
    Geliefert am 04. Feb. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the noteholders or the chargee or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Beringea LLP (As Security Trustee)
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2007
    Geliefert am 02. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 02. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 30. Juli 2004
    Geliefert am 14. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    (Including without limitation eagle house, 22 armoury way, london t/no. TGL40217). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hg Investment Managers Limited (As Security Trustee for the Secured Beneficiaries in Suchcapacity the "Trustee")
    Transaktionen
    • 14. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge over intellectual property rights
    Erstellt am 21. Dez. 2001
    Geliefert am 08. Jan. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge all the charged property being the intellectual property rights any goodwill of the chargors business.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Apr. 2001
    Geliefert am 13. Apr. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 13. Apr. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Single debenture
    Erstellt am 10. März 1995
    Geliefert am 15. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0