FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY
Überblick
| Unternehmensname | FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 02671605 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 5th Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FARNBOROUGH PROPERTIES | 10. Dez. 1991 | 10. Dez. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Mai 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Mai 2020 | 6 Seiten | AA | ||
Änderung der Details des Direktors für Ms Nicole Ann Martin am 23. Apr. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Änderung der Details des Direktors für Ms Nicole Ann Martin am 19. Sept. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||
Ernennung von Ms Nicole Ann Martin als Direktor am 07. Feb. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||
Beendigung der Bestellung von Klosters Limited als Geschäftsführer am 07. Feb. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Mai 2019 | 10 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Dez. 2019 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Mai 2018 | 10 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von Timothy John Smalley als Geschäftsführer am 03. Dez. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Robert Tchenguiz als Direktor am 03. Dez. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Mai 2017 | 14 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Dez. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Mai 2016 | 17 Seiten | AA | ||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 10. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Mai 2015 | 17 Seiten | AA | ||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Erfüllung der Belastung 5 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTIN, Nicole Ann | Geschäftsführer | Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London 5th | United Kingdom | British | 244758010003 | |||||||||||||
| TCHENGUIZ, Robert | Geschäftsführer | Floor Leconfield House Curzon Street W1J 5JA London 5th | England | British | 74322720004 | |||||||||||||
| DUNCAN, Rosemary | Sekretär | 3066 119th Street Toledo 43611 United States Of America | American | 65379670001 | ||||||||||||||
| INGHAM, Michael Harry Peter | Sekretär | 3 Lauriston Road Wimbledon SW19 4TJ London | British | 2739650001 | ||||||||||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||||||||||
| BARNARD, Neal Brian | Geschäftsführer | 26703 Nawash Drive Perrysburg 43551 Ohio United States Of America | American | 67684380001 | ||||||||||||||
| BEHAM, Joseph Alan | Geschäftsführer | 6029 Wild Ivy Court Sylvania Ohio 43560 Usa | American | 56706690001 | ||||||||||||||
| BISHOP, Paul J | Geschäftsführer | 1801 Richards Road Toledo Ohio 43697 Usa | American | 51363820003 | ||||||||||||||
| BISHOP, Paul J | Geschäftsführer | 724 E Boundary Road 43551 Perrysburg Ohio Usa | American | 51363820001 | ||||||||||||||
| DEY, Jayanta | Geschäftsführer | 13759 Heron Circle FOREIGN Clearwater Florida 34622 Usa | American | 21435320001 | ||||||||||||||
| GRUNNELL, Mark | Geschäftsführer | Montolieu Gardens SW15 6PB London 3 | United Kingdom | British | 94144450002 | |||||||||||||
| HOLY, Julian Robert | Geschäftsführer | 33 Spencer Road W4 3SS Chiswick Greater London | United Kingdom | British | 91517950001 | |||||||||||||
| MOYER, Kevin P | Geschäftsführer | 26788 Mohawk Drive 43551 Perrysburg Ohio Usa | American | 51343000001 | ||||||||||||||
| POLLOCK, Robert Evans | Geschäftsführer | 3640 Brookside FOREIGN Toledo Ohio 43606 Usa | American | 21435340001 | ||||||||||||||
| SHULTZ, Edward | Geschäftsführer | 7164 Forest Brook Drive 43560 Sylvania Ohio Usa | American | 45098000001 | ||||||||||||||
| SMALLEY, Timothy John | Geschäftsführer | Chivers Road CM15 0LG Stondon Massey Stondon Place Essex | United Kingdom | British | 102593650002 | |||||||||||||
| TCHENGUIZ, Robert | Geschäftsführer | Royal College Of Organists 26 Kensington Gore SW7 2ET London | England | British | 74322720004 | |||||||||||||
| TCHENGUIZ, Robert | Geschäftsführer | 6 Chesterfield Hill Mayfair W1J 5BL London | Iranian | 74322720002 | ||||||||||||||
| KLOSTERS LIMITED | Geschäftsführer | Les Banques St Sampsons GY1 3HS Guernsey La Tonnelle House Channel Islands |
| 188564510001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatevalley Limited | 06. Apr. 2016 | Curzon Street W1J 5JA London 5th Floor, Leconfield House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat FARNBOROUGH PROPERTIES COMPANY Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Okt. 2005 Geliefert am 20. Okt. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the lender parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property k/a building N2 t/no HP443505 and S1 t/no HP443504 at farnborough aerospace centre, farnborough, hampshire with the benefit of the occupational lease and all other (if any) agreements, leases. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. März 2004 Geliefert am 17. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the lender parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The l/h property k/a building N2 t/n HP443505 and S1 t/n HP443504AT farnborough aerospace centre farnborough hampshire, all of its rights title and interest and benefit in and to the rent account and the rent account deposit, in and to the free cash account and the free cash account deposit. By way of second floating charge its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 21. Aug. 1992 Geliefert am 28. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as indenture trustee for itself and/or to the secured noteholders under the ter,ms of the trust indenture dated 12/3/92 the secured notes or the participation agreement dated 12/3/92 or any of the other transaction documents (including the mortgage) | |
Kurze Angaben First fixed equitable charge of the benefit of an agreement dated 17/3/92 and made between newcopmbe properties limited, british aerospace public limited company, the company and the indenture trustee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 17. März 1992 Geliefert am 24. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as indenture trustee and/or to the secured noteholders under the trust indenture dated 12TH march 1992, the secured notes or the participation agreement dated 12TH march 1992 or any of the other transaction documents (including this mortgage) | |
Kurze Angaben L/H property k/a buildings N2 and S1 farnborough aerospace centre, farnborough, hampshire (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Memorandum of charge over rent account | Erstellt am 17. März 1992 Geliefert am 24. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as indenture trustee and/or to the secured noteholders under the trust indenture dated 12TH march 1992, the secured notes or the participation agreement dated 12TH march 1992 or any of the other transaction documents (including the memorandum of charge over rent account) | |
Kurze Angaben Assignment of all the company's right, title interest and benefit in and to all basic rent, supplemental rent payable under the occupational lease; dated 17/3/92 and first fixed charge of all the company's right, title, interest and benefit in and to all amounts now or at any time standing to the credit of the us dollar account in the name of the company no. 30433401 held with citibank, N.A. (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0