INTERCARE HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | INTERCARE HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02672502 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von INTERCARE HOLDINGS LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich INTERCARE HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o EVERSHEDS LLP Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von INTERCARE HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NOTIONFINISH LIMITED | 02. Jan. 1992 | 02. Jan. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INTERCARE HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für INTERCARE HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Eversheds Llp Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom am 10. Jan. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bampton Road Harold Hill Romford Essex RM3 8UG am 10. Jan. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Oades als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martin Sillitto als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Knight als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Jorge Mario Gomez Agudelo als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | 363s | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von INTERCARE HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGUDELO, Jorge Mario Gomez | Geschäftsführer | 7000 Cardinal Place Dublin Cardinal Health Ohio 43017 United States | Usa | Colombian | 119495610001 | |||||
| EARNSHAW, Jeremy Waring | Sekretär | 5 Thorntons Dale Newlaithes Road Horsforth LS18 4UW Leeds West Yorkshire | British | 47388900001 | ||||||
| KNIGHT, Anthony | Sekretär | 122 Ongar Road Writtle CM1 3NX Chelmsford Essex | British | 126965310001 | ||||||
| LOFTHOUSE, Stephen David | Sekretär | Windsor House Cornwall Road HG1 2PW Harrogate North Yorkshire | British | 111617880001 | ||||||
| UTTLEY, Robert David | Sekretär | Shaw Cottage Langfield OL14 6HP Todmorden Lancashire | British | 37892760001 | ||||||
| VICARY, Gary Kevin | Sekretär | Desborough Manorial Road Parkgate CH64 6QN Neston Wirral | British | 18943850005 | ||||||
| WEST, David William | Sekretär | 10 Brindles RM11 2RU Hornchurch Essex | English | 18533210002 | ||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Sekretär | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| COWAN, Peter Lawrence | Geschäftsführer | Flat 1 Hazelfields Delamere WA14 2NG Altrincham Cheshire | British | 42077520001 | ||||||
| EARNSHAW, Jeremy Waring | Geschäftsführer | 5 Thorntons Dale Newlaithes Road Horsforth LS18 4UW Leeds West Yorkshire | British | 47388900001 | ||||||
| GARSTON, Clive Richard | Geschäftsführer | Sandy Ridge Bollinway Hale WA15 0NZ Altrincham Cheshire | England | British | 12179600001 | |||||
| KAY, Andrew George | Geschäftsführer | 9 Back Lane Whixley Gate YO26 8BG Whixley Yorkshire | British | 41347920003 | ||||||
| LOFTHOUSE, Stephen David | Geschäftsführer | Windsor House Cornwall Road HG1 2PW Harrogate North Yorkshire | British | 111617880001 | ||||||
| OADES, Andrew Giovanni | Geschäftsführer | Bampton Road Harold Hill RM3 8UG Romford Cardinal Health Essex | United Kingdom | British | 108839700002 | |||||
| PARKER, John Francis | Geschäftsführer | Beck House 10 Fulwith Mill Lane HG2 8HJ Harrogate North Yorkshire | British | 47002780001 | ||||||
| SHEPHERD, Robert Priestley | Geschäftsführer | Woodcliffe Horncliffe BB4 6JS Rossendale Lancashire | British | 8802110001 | ||||||
| SILLITTO, Martin | Geschäftsführer | Bampton Road Harold Hill RM3 8UG Romford Cardinal Health Essex | United Kingdom | British | 126965260002 | |||||
| TAYLOR, Malcolm Archibald, Dr | Geschäftsführer | Windsor House Cornwall Road NG1 2PW Harrowgate North Yorkshire | British | 111617640001 | ||||||
| UTTLEY, Robert David | Geschäftsführer | Shaw Cottage Langfield OL14 6HP Todmorden Lancashire | England | British | 37892760001 | |||||
| VICARY, Gary Kevin | Geschäftsführer | 481 Didsbury Road Heaton Mersey SK3 3AY Stockport Cheshire | British | 18943850001 | ||||||
| WEST, David William | Geschäftsführer | 10 Brindles RM11 2RU Hornchurch Essex | England | English | 18533210002 | |||||
| WITHERS, Rees | Geschäftsführer | The Shenfield Chelford Road WA16 8LU Knutsford Cheshire | British | 59651580001 |
Hat INTERCARE HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 09. Okt. 2002 Geliefert am 24. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Share pledge agreement | Erstellt am 08. Okt. 2002 Geliefert am 25. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the pledgors to the chargee in its capacity as agent, rbscs, and the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The 3.321 shares inclusive that they currently hold in pharmapar sa/nv any cash return on the shares (whether in the form of dividends declared out of retained earnings or reserves repayment of capital scripts or otherwise) the shares resulting from the exercise of any subscription right to be treated as coming within the definition of the shares (together the pledged assets). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Okt. 1999 Geliefert am 27. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All and any obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the company to any of the secured parties (as defined) under or in connection with any of the financing documents (as defined) on the date therefor in the manner provided in the relevant financing documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of pledge of shares | Erstellt am 12. Okt. 1999 Geliefert am 27. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys,obligations and liabilities due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee under or pursuant to any of the documents (as defined) | |
Kurze Angaben The original shares and voting rights and dividends thereto. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 12. Okt. 1999 Geliefert am 27. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the discounting documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 10. Nov. 1998 Geliefert am 17. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Postponement and assignment of claim | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 22. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All debts/liabilities ................and all dividends/other sums payable; all rights/claims.....etc.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat INTERCARE HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0