INTERCARE HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameINTERCARE HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02672502
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o EVERSHEDS LLP
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    NOTIONFINISH LIMITED02. Jan. 199202. Jan. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 03. März 2011

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Eversheds Llp Eversheds House 70 Great Bridgewater Street Manchester M1 5ES United Kingdom am 10. Jan. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Jan. 2011

    Kapitalaufstellung am 10. Jan. 2011

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Bampton Road Harold Hill Romford Essex RM3 8UG am 10. Jan. 2011

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 02. Jan. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Oades als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Martin Sillitto als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Anthony Knight als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Ernennung von Jorge Mario Gomez Agudelo als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    11 SeitenAA

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    11 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007

    12 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2006

    11 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von INTERCARE HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AGUDELO, Jorge Mario Gomez
    7000 Cardinal Place
    Dublin
    Cardinal Health
    Ohio 43017
    United States
    Geschäftsführer
    7000 Cardinal Place
    Dublin
    Cardinal Health
    Ohio 43017
    United States
    UsaColombian119495610001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    British47388900001
    KNIGHT, Anthony
    122 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NX Chelmsford
    Essex
    Sekretär
    122 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NX Chelmsford
    Essex
    British126965310001
    LOFTHOUSE, Stephen David
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    Sekretär
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    British111617880001
    UTTLEY, Robert David
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    Sekretär
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    British37892760001
    VICARY, Gary Kevin
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    Sekretär
    Desborough Manorial Road
    Parkgate
    CH64 6QN Neston
    Wirral
    British18943850005
    WEST, David William
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    Sekretär
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    English18533210002
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Sekretär
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    COWAN, Peter Lawrence
    Flat 1 Hazelfields
    Delamere
    WA14 2NG Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Flat 1 Hazelfields
    Delamere
    WA14 2NG Altrincham
    Cheshire
    British42077520001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    British47388900001
    GARSTON, Clive Richard
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Sandy Ridge
    Bollinway Hale
    WA15 0NZ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish12179600001
    KAY, Andrew George
    9 Back Lane
    Whixley Gate
    YO26 8BG Whixley
    Yorkshire
    Geschäftsführer
    9 Back Lane
    Whixley Gate
    YO26 8BG Whixley
    Yorkshire
    British41347920003
    LOFTHOUSE, Stephen David
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    British111617880001
    OADES, Andrew Giovanni
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    Geschäftsführer
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    United KingdomBritish108839700002
    PARKER, John Francis
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    British47002780001
    SHEPHERD, Robert Priestley
    Woodcliffe Horncliffe
    BB4 6JS Rossendale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Woodcliffe Horncliffe
    BB4 6JS Rossendale
    Lancashire
    British8802110001
    SILLITTO, Martin
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    Geschäftsführer
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    United KingdomBritish126965260002
    TAYLOR, Malcolm Archibald, Dr
    Windsor House
    Cornwall Road
    NG1 2PW Harrowgate
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Windsor House
    Cornwall Road
    NG1 2PW Harrowgate
    North Yorkshire
    British111617640001
    UTTLEY, Robert David
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Shaw Cottage
    Langfield
    OL14 6HP Todmorden
    Lancashire
    EnglandBritish37892760001
    VICARY, Gary Kevin
    481 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK3 3AY Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    481 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK3 3AY Stockport
    Cheshire
    British18943850001
    WEST, David William
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    Geschäftsführer
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    EnglandEnglish18533210002
    WITHERS, Rees
    The Shenfield
    Chelford Road
    WA16 8LU Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Shenfield
    Chelford Road
    WA16 8LU Knutsford
    Cheshire
    British59651580001

    Hat INTERCARE HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 09. Okt. 2002
    Geliefert am 24. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transaktionen
    • 24. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Share pledge agreement
    Erstellt am 08. Okt. 2002
    Geliefert am 25. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the pledgors to the chargee in its capacity as agent, rbscs, and the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The 3.321 shares inclusive that they currently hold in pharmapar sa/nv any cash return on the shares (whether in the form of dividends declared out of retained earnings or reserves repayment of capital scripts or otherwise) the shares resulting from the exercise of any subscription right to be treated as coming within the definition of the shares (together the pledged assets). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Juli 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Okt. 1999
    Geliefert am 27. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All and any obligations and liabilities (whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the company to any of the secured parties (as defined) under or in connection with any of the financing documents (as defined) on the date therefor in the manner provided in the relevant financing documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of pledge of shares
    Erstellt am 12. Okt. 1999
    Geliefert am 27. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys,obligations and liabilities due or to become due from any of the obligors (as defined) to the chargee under or pursuant to any of the documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The original shares and voting rights and dividends thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC,as Security Trustee for and on Behalf of the Banks Pursuant Tothe Credit Agreement (As Defined) and Lombard Natwest Discounting Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    All assets debenture
    Erstellt am 12. Okt. 1999
    Geliefert am 27. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the discounting documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Sept. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 10. Nov. 1998
    Geliefert am 17. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Postponement and assignment of claim
    Erstellt am 20. Nov. 1995
    Geliefert am 22. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All debts/liabilities ................and all dividends/other sums payable; all rights/claims.....etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Bank of Canada
    Transaktionen
    • 22. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat INTERCARE HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    03. März 2011Beginn der Liquidation
    19. Apr. 2012Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0