ABSOLUTE RADIO LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ABSOLUTE RADIO LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02674136 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ABSOLUTE RADIO LIMITED?
- Rundfunk (60100) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich ABSOLUTE RADIO LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough United Kingdom |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ABSOLUTE RADIO LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TIML RADIO LIMITED | 12. Sept. 2008 | 12. Sept. 2008 |
VIRGIN RADIO LIMITED | 18. Dez. 1992 | 18. Dez. 1992 |
INDEPENDENT MUSIC RADIO LIMITED | 31. Jan. 1992 | 31. Jan. 1992 |
ROCK 1215 LIMITED | 21. Jan. 1992 | 21. Jan. 1992 |
MARK 2179 LIMITED | 24. Dez. 1991 | 24. Dez. 1991 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ABSOLUTE RADIO LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ABSOLUTE RADIO LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 23 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 38 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 03. Dez. 2019
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 28 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Bauer Group Secretariat Limited am 25. Sept. 2018 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Sarah Jane Vickery am 25. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Keenan am 25. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 41 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 14. Dez. 2017
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ABSOLUTE RADIO LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED | Sekretär | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England |
| 159023720001 | ||||||||||
FORD, Deidre Ann | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 109666380002 | ||||||||
KEENAN, Paul Anthony | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | Publisher | 243390510001 | ||||||||
VICKERY, Sarah Jane | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | England | British | Finance Director | 119137220004 | ||||||||
CLARKE, Sara | Sekretär | Old Stable Cottage Old Barn Farm, Uplawmoor G78 4AZ Glasgow | British | Chartered Management Accountan | 77963580002 | |||||||||
DAVIDSON, Dawn | Sekretär | Langhaugh Carmichael ML12 6PQ Biggar Lanarkshire | British | Company Secretary | 51065860001 | |||||||||
FLYNN, Roger Patrick | Sekretär | 4 Doneraile Street Fulham SW6 6EN London | British | Commercial Director | 66703670003 | |||||||||
LEGGE, Diana Patricia | Sekretär | 24a Enderby Street SE10 9PF London | British | 66675910001 | ||||||||||
ROBINSON, Adrian Mervyn | Sekretär | 6 Glenard Hall Goatstown Road IRISH Clonskeagh Dublin 14 Ireland | Irish | 77585790001 | ||||||||||
TAMES, Jane Elizabeth Anne | Sekretär | 5 Hatfield Drive Kelvinside G12 0XZ Glasgow | British | 118367070001 | ||||||||||
ZAMET, Naomi Rae | Sekretär | Flat 1 Merlin House Oak Hill Park Frognal Hampstead NW3 7LJ London | British | 42158970002 | ||||||||||
ZIPRIN, Geoffrey Charles | Bevollmächtigter Sekretär | The Old Carters House 53 Chenies Village WD3 6EQ Bucks | British | 900001590001 | ||||||||||
AUMONIER, John Martin | Geschäftsführer | Little Heath Nyetimber Lane West Chiltington RH20 2ND Pulborough West Sussex | Other | Managing Director | 63227690001 | |||||||||
BLACKABY, Oliver Guy | Geschäftsführer | Cholmeley Crescent Highgate N6 5EX London 47 | United Kingdom | British | Independent Consultant | 131001170001 | ||||||||
CAMPBELL, David Lachlan | Geschäftsführer | GU28 | England | British | Company Director | 58507320001 | ||||||||
DEVEREUX, Robert Harold Ferrers | Geschäftsführer | 5 Ladbroke Terrace W11 3PG London | England | British | Company Director | 68747470001 | ||||||||
DHARIWAL, Ravindra | Geschäftsführer | Oopp Nv Farms, Khasra No 1523 Sub Po S P School 110030 Bhatti Mines Ashray Farms Asola Village New Delhi India | India | Indian | Company Executive | 137478960001 | ||||||||
EMSLIE, Donald Gordon | Geschäftsführer | 32 Drumsheugh Gardens EH3 7RN Edinburgh | Scotland | British | Director | 61177720002 | ||||||||
FLANAGAN, Andrew Henry | Geschäftsführer | 7 Collylinn Road Bearsden G61 4PN Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | Chief Executive | 42787120004 | ||||||||
FLYNN, Roger Patrick | Geschäftsführer | 4 Doneraile Street Fulham SW6 6EN London | United Kingdom | British | Commercial Director | 66703670003 | ||||||||
GYNGELL, Bruce | Geschäftsführer | 57 Oakley Street SW3 5HB London | Australian | Company Director | 25950350001 | |||||||||
HAZLITT, Frances | Geschäftsführer | 73 Finlay Street SW6 6HF London | British | Company Director | 110554850001 | |||||||||
HUGHES, Gary William | Geschäftsführer | 64 Crown Road North Dowanhill G12 9HW Glasgow | Uk | British | Accountant | 72256160002 | ||||||||
HUNTINGFORD, Richard Norman Legh | Geschäftsführer | 11 Baronsmead Road Barnes SW13 9RR London | United Kingdom | British | Company Director | 3297910006 | ||||||||
IBBETT, Kenneth Richard Andre | Geschäftsführer | 31 Aldridge Road Villas W11 1BN London | United Kingdom | British | Director | 34929900001 | ||||||||
JACKSON, Paul | Geschäftsführer | Geeta London Road SL5 9RY Sunningdale Berkshire | British | Company Director | 117927650001 | |||||||||
LEVISON, Charles John Cuthbertson | Geschäftsführer | 40 Kensington Park Gardens W11 2QT London | British | Company Director | 76794220002 | |||||||||
MANFREY, Barbara Louise | Geschäftsführer | 55 Palace Gardens Terrace W8 4RU London | American | Director Of Venture Capital Fi | 34084460002 | |||||||||
MOLLETT, Andrew | Geschäftsführer | 4 White Heron Mews Park Lane TW11 0JQ Teddington Middlesex | British | Finance Director | 47101600001 | |||||||||
PARIGI, Amba Preetham | Geschäftsführer | 10th Floor, Flat 102, A Wing 66 Napean Sea Road 400 036 Mumbai Petit Hall Tahnee Heights Chsl Mumbai India | India | Indian | Company Director | 134398470002 | ||||||||
PEARSON, Anthony John | Geschäftsführer | Scamells Corner Red Lane Blackbrook RH5 4DU Dorking Surrey | Uk | British | Chief Executive Radio | 44001900002 | ||||||||
PEARSON, Anthony John | Geschäftsführer | Scamells Corner Red Lane Blackbrook RH5 4DU Dorking Surrey | Uk | British | Director | 44001900002 | ||||||||
PHIPPEN, Peter Sangster | Geschäftsführer | Templewood Lane Stoke Poges SL2 4BG Slough "Oak Acre" England | England | British | Director | 32688550001 | ||||||||
POTTER, Irene | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 55 Peel Place Clayhall Avenue IG5 0PT Ilford Essex | British | 900001600001 | ||||||||||
SHAH, Sanjeev | Geschäftsführer | Next To Maulya Centre, Senapati Bapat Marg, Lower Parel 400 013 Mumbai A/203 2nd Floor Casea Grande Tower India | India | Indian | Company Director | 148788520001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ABSOLUTE RADIO LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauer Ar Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ABSOLUTE RADIO LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Corporate loan agreement | Erstellt am 14. Dez. 2009 Geliefert am 23. Dez. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The assets, both moveable and immoveable see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental security agreement | Erstellt am 16. Feb. 2004 Geliefert am 03. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The trademarks and design rights specified next to its name in schedule 2 of the agreement under the heading specific intellectual property rights; any copyright or other intellectual property monopoly right in any of the above; or any interest (including by way of licence) in any of the above. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 04. Apr. 2003 Geliefert am 16. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company or any other of the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 18. Juli 2002 Geliefert am 24. Juli 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hedging debenture | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 18. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each of the obligors (as defined) to banque paribas (as security trustee for itself and the hedge provider) and to the hedge provider under the hedging documents together with all costs,charges and expenses incurred by the hedge provder and/or the security trustee in connection with the protection,preservation or enforcement of it's respective rights under the hedging documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 08. Dez. 1997 Geliefert am 24. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each of the obligors to the secured creditors(or any of them) under each of the senior facility documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. März 1997 Geliefert am 27. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the facility documents and/or this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over land (as defined) broadcasting licences all rights of the company uner or in respect of the broadcasting licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 06. Jan. 1995 Geliefert am 13. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An issue of secured debentures in a series | Erstellt am 13. Dez. 1993 Geliefert am 23. Dez. 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 31. Aug. 1993 Geliefert am 02. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 24. Aug. 1993 Geliefert am 02. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 05. Juli 1993 Geliefert am 23. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 28. Juni 1993 Geliefert am 29. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Transaktionen
| ||||
Issue of secured debentures | Erstellt am 21. Juni 1993 Geliefert am 25. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Transaktionen
| ||||
Series of debentures | Erstellt am 21. Mai 1993 Geliefert am 01. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Issue | Erstellt am 23. Apr. 1993 Geliefert am 10. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Series of debentures | Erstellt am 08. März 1993 Geliefert am 12. März 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Series of debentures | Erstellt am 08. März 1993 Geliefert am 12. März 1993 Datum des Sicherungsinstruments 08. März 1993 | Vollständig erfüllt | ||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of rent deposit | Erstellt am 19. Jan. 1993 Geliefert am 27. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag Forsecuring £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Pursuant to clause 2 (f) of the deed of rent deposit referred to virgin radio limited agreed to charge £50,000 to trafalgar house developments limited as security for the performance of its obligation in a lease dated 19/1/93 relating to the 2ND 3RD and 4TH floors 1 golden square london W1 and performance of its obligation in the rent deposit deed of the aforesaid date. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0