GRAPHISIGN UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGRAPHISIGN UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02675187
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GRAPHISIGN UK LIMITED?

    • (4525) /

    Wo befindet sich GRAPHISIGN UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Dte House
    Hollins Mount
    BL9 8AT Bury
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GRAPHISIGN UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2006

    Welche sind die letzten Einreichungen für GRAPHISIGN UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Aug. 2011

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    3 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Mai 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Nov. 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Mai 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 13. Mai 2010

    5 Seiten4.68

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Mai 2009

    11 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    11 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Nov. 2008

    10 Seiten2.24B

    legacy

    1 Seiten288b

    Vorschlag des Verwalters

    28 Seiten2.17B

    legacy

    1 Seiten287

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    5 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288b

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    7 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    5 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von GRAPHISIGN UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    TUPMAN, Carmel Ann
    Shawmere House
    Uppermill
    OL3 6LE Oldham
    Lancashire
    Sekretär
    Shawmere House
    Uppermill
    OL3 6LE Oldham
    Lancashire
    British22186930003
    BURR, Chantelle
    10 Kenworthy Gardens
    Uppermill
    OL3 6ET Oldham
    Geschäftsführer
    10 Kenworthy Gardens
    Uppermill
    OL3 6ET Oldham
    British119095640001
    TUPMAN, Alan
    Shawmere House
    Uppermill
    OL3 6LE Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Shawmere House
    Uppermill
    OL3 6LE Oldham
    Lancashire
    EnglandBritish35555250003
    TUPMAN, Bradley
    20 Corbett Way
    Denshaw
    OL3 5SX Oldham
    Geschäftsführer
    20 Corbett Way
    Denshaw
    OL3 5SX Oldham
    British119095630001
    TUPMAN, Carmel Ann
    Shawmere House
    Uppermill
    OL3 6LE Oldham
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Shawmere House
    Uppermill
    OL3 6LE Oldham
    Lancashire
    British22186930003
    BRITANNIA COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Sekretär
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001550001
    GLEDHILL, Christopher Brian
    26 Miller Meadow Close
    Shaw, Shaw
    OL2 8DT Oldham
    Geschäftsführer
    26 Miller Meadow Close
    Shaw, Shaw
    OL2 8DT Oldham
    EnglandBritish124591060001
    HUMPHREYS, Grant Christopher
    4 Ashdene
    OL12 6DJ Rochdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    4 Ashdene
    OL12 6DJ Rochdale
    Lancashire
    British29310910001
    STEAD, Anthony Paul
    Speeton Avenue
    BD7 4NQ Bradford
    23
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Speeton Avenue
    BD7 4NQ Bradford
    23
    West Yorkshire
    EnglandBritish138031410001
    DEANSGATE COMPANY FORMATIONS LIMITED
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    The Britannia Suite International House
    82-86 Deansgate
    M3 2ER Manchester
    900001540001

    Hat GRAPHISIGN UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 24. Apr. 2008
    Geliefert am 25. Apr. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Positive Cashflow Finance Limited
    Transaktionen
    • 25. Apr. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 27. Juni 2006
    Geliefert am 04. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 04. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 2005
    Geliefert am 15. Juni 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 52 high street saltney flintshire CH4 8SF. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 28. Sept. 2004
    Geliefert am 29. Sept. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Sept. 1995
    Geliefert am 21. Sept. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)

    Hat GRAPHISIGN UK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. Mai 2008Beginn der Verwaltung
    14. Mai 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Poxon
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancashire
    Praktiker
    Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount
    Bury Lancashire
    John Malcolm Titley
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount, Hollins Lane
    Bury, Lancashire
    Praktiker
    Dte Leonard Curtis
    Dte House
    BL9 8AT Hollins Mount, Hollins Lane
    Bury, Lancashire
    2
    DatumTyp
    14. Mai 2009Beginn der Liquidation
    30. Nov. 2011Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Poxon
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    Praktiker
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    John Malcolm Titley
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire
    Praktiker
    D T E House Hollins Lane
    BL9 8AT Bury
    Lancashire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0