MARR TAVERNS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MARR TAVERNS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02677899 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MARR TAVERNS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich MARR TAVERNS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MARR TAVERNS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OVAL (775) LIMITED | 15. Jan. 1992 | 15. Jan. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MARR TAVERNS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MARR TAVERNS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 86 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Forde als Geschäftsführer am 31. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. März 2020 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Jan. 2020
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 79 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
Ernennung von Mr Sean Michael Paterson als Direktor am 24. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David James Tannahill als Geschäftsführer am 24. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 24. Aug. 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 19. Aug. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Marr Holdings Limited as a person with significant control on 04. Sept. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MARR TAVERNS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Christopher John | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 136853310001 | |||||
| MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 112375050001 | |||||
| PATERSON, Sean Michael | Geschäftsführer | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | 257892140001 | |||||
| APPLEBY, Francesca | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191628080001 | |||||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Sekretär | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| BROWN, Robert Adam Southall | Sekretär | 24 Alders Brook Hilton DE65 5HF Derby Derbyshire | British | 67809020001 | ||||||
| DALEY, Frances Margaret Catherine | Sekretär | 1 Frank Dixon Way SE21 7BB London | United Kingdom | 45177440002 | ||||||
| HARRINGTON, Columb | Sekretär | 4 Drovers Way Newton Longville MK17 0HR Buckinghamshire | Irish | 51845740002 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175488540001 | |||||||
| JONES, Ian Andrew | Sekretär | 6 Pages Croft HP4 1BX Berkhamsted Hertfordshire | British | 54298280003 | ||||||
| KIRK, Ronald Leslie James | Sekretär | 16 Greet Park Close NG25 0EE Southwell Nottinghamshire | British | 71984630001 | ||||||
| LAZARUS, David Michael | Sekretär | 58 Woodside Park Road N12 8RS London | British | 62981490001 | ||||||
| MOORE, Alan | Sekretär | 47 Bolton Gardens TW11 9AX Teddington Middlesex | British | 8254860001 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161686170001 | |||||||
| WHITAKER, Jack Mcdonald | Sekretär | 16 Broadmead Road IG8 0AY Woodford Green Essex | British | 31871780001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Geschäftsführer | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
| BUNTING, Martin Brian | Geschäftsführer | The Long House 41 High Street, Odiham RG29 1LF Hook Hampshire | England | British | 64749460001 | |||||
| DALEY, Frances Margaret Catherine | Geschäftsführer | 17 Pickwick Road Dulwich SE21 7JN London | British | 45177440001 | ||||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FORDE, David | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | 180590780001 | |||||
| FREEDMAN, Cyril Winston | Geschäftsführer | Golden Mead Mead Road BR7 6AD Chislehurst Kent | British | 1631420001 | ||||||
| JACKSON, Alan Michael | Geschäftsführer | Woodrow Farm Wigginton HP23 6HT Tring Hertfordshire | England | British | 46903690001 | |||||
| KEMP, Deborah Jane | Geschäftsführer | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | 79388130005 | |||||
| KIRK, Ronald Leslie James | Geschäftsführer | 16 Greet Park Close NG25 0EE Southwell Nottinghamshire | United Kingdom | British | 71984630001 | |||||
| LAMBERT, Stephen David | Geschäftsführer | Fernley 84 Newmarket Road NR2 2LB Norwich Norfolk | British | 43572470001 | ||||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MOORE, Alan | Geschäftsführer | 47 Bolton Gardens TW11 9AX Teddington Middlesex | British | 8254860001 | ||||||
| NEAME, Robert Harry Beale | Geschäftsführer | Dane Court Farmhouse Kits Hill Selling ME13 9QP Faversham Kent | United Kingdom | British | 1511740001 | |||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| SHERLING, Clive Richard | Geschäftsführer | Lincoln House, Woodside Hill Chalfont St Peter SL9 9TF Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 20007920003 | |||||
| TANNAHILL, David James | Geschäftsführer | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | 237381690001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MARR TAVERNS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Uk Limited | 29. Aug. 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
| Marr Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MARR TAVERNS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 1999 Geliefert am 05. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors each of them to the secured creditors (or any of them) under the facility documents (or any of them) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 04. März 1996 Geliefert am 21. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 04. März 1996 Geliefert am 11. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The property k/a adam & eve 47 swan road rotherhithe london t/no 134241. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 12. Jan. 1996 Geliefert am 26. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other liable party (all as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) and to the finance parties or any of them under each of the liability documents (as defined) to which such liable party is a party | |
Kurze Angaben Golden lion public house 2 britannia street london WC1 t/n 221904,the victoria public house 2 mornington terrace camden NW1 t/n 340217,the marquis of granby public house west sompting lancing west sussex and the vauxhall public house 159 sturry road canterbury kent with all buildings and fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 31. Juli 1995 Geliefert am 02. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each liable party (as defined) to the chargee under the liability documents (as defined) | |
Kurze Angaben Reardons wine bar, bankside house 107/112 leadenhall street london EC3. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed of sub-charge | Erstellt am 18. Mai 1995 Geliefert am 24. Mai 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations due or to become due from the company and/or each liable party pursuant to the terms of the liability documents and/or this charge | |
Kurze Angaben First legal mortgage all the company's interest in the usher debenture the principal money and all interest due. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 20. Sept. 1994 Geliefert am 07. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The george & dragon public house cavendish street ramsgate kent title no K408946,the jolly caulkers public house batchelor street chatham kent title NO341831 tog with all buildings and fixtures the proceeds of sale and the benefit of any covenants. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture (seventh) | Erstellt am 21. Mai 1993 Geliefert am 26. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations of each liable party (as defined) to samuel montagu & co (as agent and trustee for the finance parties) and to the finance parties (as defined) or any of them under each of the liablility documents (also as defined)to which such liable party is a party see charge particulars form for details | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 02. Apr. 1993 Geliefert am 08. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever under each of the liability documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 02. Feb. 1993 Geliefert am 05. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations of each liable partie (as defined) to samuel montagu & co. (As agent and trustee for the finance parties) and to the finance parties (as defined) or any of them under each of the lability documents (also as defined) to which such liable party is a party | |
Kurze Angaben Property k/a merlin king arthurs way andover weymouth title no: HP443117. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 04. Dez. 1992 Geliefert am 10. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) under the terms of each of the liability documents (as defined) | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 21. Okt. 1992 Geliefert am 23. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee the deed | |
Kurze Angaben A separate designated interest earning account at a clearing bank. £19,260 tog: all sums paid into the said account. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 14. Okt. 1992 Geliefert am 16. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from marr taverns limited (formerly oval (775) limited) supplemental to a guarantee and debenture dated 23/03/92 to the chargee under each of the finance documents (as defined in the debenture) to which the company is a party | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 04. Sept. 1992 Geliefert am 09. Sept. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other member of the group to samuel montagu & co limited as security agent and trustee for the finance parties (as defined)under the terms of the liability documents (as defined) | |
Kurze Angaben Property k/a the british pilot station road allhallows kent ME3 9QW title no: P121192 (please see form 395 for full details ). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 10. Aug. 1992 Geliefert am 19. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations of the company and any subsidiaries of the company (the liable parties) to the chargee or any of them under each of theliability documents (as defined) to which such liable party is a party | |
Kurze Angaben F/H and l/h properties specified in the schedule together with buildings and fixtures the proceeds of sale thereof see doc for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 23. März 1992 Geliefert am 25. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the finance parties (as defined in the charge) on any account whatsoever under the terms of the liability documents (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben (For full details refer to doc M395 ref M77). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0