MARR TAVERNS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMARR TAVERNS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02677899
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MARR TAVERNS LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich MARR TAVERNS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MARR TAVERNS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OVAL (775) LIMITED15. Jan. 199215. Jan. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MARR TAVERNS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für MARR TAVERNS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. März 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    16 SeitenAA

    legacy

    86 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    legacy

    2 SeitenAGREEMENT2

    Beendigung der Bestellung von David Forde als Geschäftsführer am 31. Juli 2020

    1 SeitenTM01

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. März 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    1 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 17. Jan. 2020

    • Kapital: GBP 2.00
    4 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    legacy

    2 SeitenAGREEMENT1

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    legacy

    79 SeitenPARENT_ACC

    Ernennung von Mr Sean Michael Paterson als Direktor am 24. Apr. 2019

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David James Tannahill als Geschäftsführer am 24. Apr. 2019

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. März 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 24. Aug. 2018 bis 31. Dez. 2018

    1 SeitenAA01

    Bestätigungserklärung erstellt am 02. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 19. Aug. 2017

    3 SeitenAA

    Change of details for Marr Holdings Limited as a person with significant control on 04. Sept. 2017

    2 SeitenPSC05

    Wer sind die Geschäftsführer von MARR TAVERNS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Geschäftsführer
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritish257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191628080001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BROWN, Robert Adam Southall
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    24 Alders Brook
    Hilton
    DE65 5HF Derby
    Derbyshire
    British67809020001
    DALEY, Frances Margaret Catherine
    1 Frank Dixon Way
    SE21 7BB London
    Sekretär
    1 Frank Dixon Way
    SE21 7BB London
    United Kingdom45177440002
    HARRINGTON, Columb
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    Sekretär
    4 Drovers Way
    Newton Longville
    MK17 0HR Buckinghamshire
    Irish51845740002
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488540001
    JONES, Ian Andrew
    6 Pages Croft
    HP4 1BX Berkhamsted
    Hertfordshire
    Sekretär
    6 Pages Croft
    HP4 1BX Berkhamsted
    Hertfordshire
    British54298280003
    KIRK, Ronald Leslie James
    16 Greet Park Close
    NG25 0EE Southwell
    Nottinghamshire
    Sekretär
    16 Greet Park Close
    NG25 0EE Southwell
    Nottinghamshire
    British71984630001
    LAZARUS, David Michael
    58 Woodside Park Road
    N12 8RS London
    Sekretär
    58 Woodside Park Road
    N12 8RS London
    British62981490001
    MOORE, Alan
    47 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    Sekretär
    47 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    British8254860001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Sekretär
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161686170001
    WHITAKER, Jack Mcdonald
    16 Broadmead Road
    IG8 0AY Woodford Green
    Essex
    Sekretär
    16 Broadmead Road
    IG8 0AY Woodford Green
    Essex
    British31871780001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    BUNTING, Martin Brian
    The Long House
    41 High Street, Odiham
    RG29 1LF Hook
    Hampshire
    Geschäftsführer
    The Long House
    41 High Street, Odiham
    RG29 1LF Hook
    Hampshire
    EnglandBritish64749460001
    DALEY, Frances Margaret Catherine
    17 Pickwick Road
    Dulwich
    SE21 7JN London
    Geschäftsführer
    17 Pickwick Road
    Dulwich
    SE21 7JN London
    British45177440001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrish180590780001
    FREEDMAN, Cyril Winston
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Golden Mead
    Mead Road
    BR7 6AD Chislehurst
    Kent
    British1631420001
    JACKSON, Alan Michael
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Woodrow Farm
    Wigginton
    HP23 6HT Tring
    Hertfordshire
    EnglandBritish46903690001
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Geschäftsführer
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritish79388130005
    KIRK, Ronald Leslie James
    16 Greet Park Close
    NG25 0EE Southwell
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    16 Greet Park Close
    NG25 0EE Southwell
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish71984630001
    LAMBERT, Stephen David
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    Geschäftsführer
    Fernley 84 Newmarket Road
    NR2 2LB Norwich
    Norfolk
    British43572470001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MOORE, Alan
    47 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    Geschäftsführer
    47 Bolton Gardens
    TW11 9AX Teddington
    Middlesex
    British8254860001
    NEAME, Robert Harry Beale
    Dane Court Farmhouse
    Kits Hill Selling
    ME13 9QP Faversham
    Kent
    Geschäftsführer
    Dane Court Farmhouse
    Kits Hill Selling
    ME13 9QP Faversham
    Kent
    United KingdomBritish1511740001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    SHERLING, Clive Richard
    Lincoln House, Woodside Hill
    Chalfont St Peter
    SL9 9TF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Lincoln House, Woodside Hill
    Chalfont St Peter
    SL9 9TF Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20007920003
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritish237381690001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MARR TAVERNS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29. Aug. 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    Nein
    RechtsformCorporate
    RegistrierungslandScotland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (Scotland)
    RegistrierungsortCompanies House
    RegistrierungsnummerSc065527
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hat das Recht, wesentlichen Einfluss oder Kontrolle über das Unternehmen auszuüben oder übt diese tatsächlich aus.
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer2506120
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat MARR TAVERNS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 14. Sept. 1999
    Geliefert am 05. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors each of them to the secured creditors (or any of them) under the facility documents (or any of them) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Chase Manhattan International Limited (As Trustee for the Secured Creditors)
    Transaktionen
    • 05. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 04. März 1996
    Geliefert am 21. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 04. März 1996
    Geliefert am 11. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a adam & eve 47 swan road rotherhithe london t/no 134241. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 12. Jan. 1996
    Geliefert am 26. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other liable party (all as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) and to the finance parties or any of them under each of the liability documents (as defined) to which such liable party is a party
    Kurze Angaben
    Golden lion public house 2 britannia street london WC1 t/n 221904,the victoria public house 2 mornington terrace camden NW1 t/n 340217,the marquis of granby public house west sompting lancing west sussex and the vauxhall public house 159 sturry road canterbury kent with all buildings and fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co. Limited
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 31. Juli 1995
    Geliefert am 02. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each liable party (as defined) to the chargee under the liability documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Reardons wine bar, bankside house 107/112 leadenhall street london EC3. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed of sub-charge
    Erstellt am 18. Mai 1995
    Geliefert am 24. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations due or to become due from the company and/or each liable party pursuant to the terms of the liability documents and/or this charge
    Kurze Angaben
    First legal mortgage all the company's interest in the usher debenture the principal money and all interest due. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co as Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 24. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 20. Sept. 1994
    Geliefert am 07. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The george & dragon public house cavendish street ramsgate kent title no K408946,the jolly caulkers public house batchelor street chatham kent title NO341831 tog with all buildings and fixtures the proceeds of sale and the benefit of any covenants.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limitedas Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 07. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture (seventh)
    Erstellt am 21. Mai 1993
    Geliefert am 26. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations of each liable party (as defined) to samuel montagu & co (as agent and trustee for the finance parties) and to the finance parties (as defined) or any of them under each of the liablility documents (also as defined)to which such liable party is a party see charge particulars form for details
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited (As Agent and Trustee)
    Transaktionen
    • 26. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 02. Apr. 1993
    Geliefert am 08. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to samuel montagu & co limited as agent and trustee for the finance parties (as defined) on any account whatsoever under each of the liability documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 08. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 02. Feb. 1993
    Geliefert am 05. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations of each liable partie (as defined) to samuel montagu & co. (As agent and trustee for the finance parties) and to the finance parties (as defined) or any of them under each of the lability documents (also as defined) to which such liable party is a party
    Kurze Angaben
    Property k/a merlin king arthurs way andover weymouth title no: HP443117. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co
    Transaktionen
    • 05. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 04. Dez. 1992
    Geliefert am 10. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined) under the terms of each of the liability documents (as defined)
    Kurze Angaben
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited as Agent and Trustee for the Finance Parties(As Defined)
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 21. Okt. 1992
    Geliefert am 23. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee the deed
    Kurze Angaben
    A separate designated interest earning account at a clearing bank. £19,260 tog: all sums paid into the said account.
    Berechtigte Personen
    • Tower Bridge Business Centre Limited
    Transaktionen
    • 23. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 14. Okt. 1992
    Geliefert am 16. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from marr taverns limited (formerly oval (775) limited) supplemental to a guarantee and debenture dated 23/03/92 to the chargee under each of the finance documents (as defined in the debenture) to which the company is a party
    Kurze Angaben
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Which the Company is a Party
    • Samuel Montagu & Co. Limited as Agent and Trustee for Itself and Forthe Finance Parties (As Defined) and the Finance Parties (or Any of Them) Under Each of the Finance Documents (as Defined in the Debenture) To
    Transaktionen
    • 16. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 04. Sept. 1992
    Geliefert am 09. Sept. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other member of the group to samuel montagu & co limited as security agent and trustee for the finance parties (as defined)under the terms of the liability documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Property k/a the british pilot station road allhallows kent ME3 9QW title no: P121192 (please see form 395 for full details ). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited
    Transaktionen
    • 09. Sept. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 10. Aug. 1992
    Geliefert am 19. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations of the company and any subsidiaries of the company (the liable parties) to the chargee or any of them under each of theliability documents (as defined) to which such liable party is a party
    Kurze Angaben
    F/H and l/h properties specified in the schedule together with buildings and fixtures the proceeds of sale thereof see doc for details.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co Limited(The "Security Agent") and the Finance Parties(as Defined)
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 23. März 1992
    Geliefert am 25. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent & trustee for the finance parties (as defined in the charge) on any account whatsoever under the terms of the liability documents (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    (For full details refer to doc M395 ref M77). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Samuel Montagu & Co. Limited as Agent and Trustee for the Financeparties (As Defined in the Charge)
    Transaktionen
    • 25. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Juni 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0