TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED

TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTURNSTONE INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02677906
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen
    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Warehouse
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MISLEX (30) LIMITED15. Jan. 199215. Jan. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    2 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Jan. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    5 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Jan. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    8 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Jan. 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Jan. 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 026779060016 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 026779060014 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 026779060015 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 026779060017 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    4 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 026779060017, erstellt am 02. Sept. 2016

    22 SeitenMR01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 25. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 11 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    1 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 026779060016, erstellt am 27. Okt. 2015

    21 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 026779060014, erstellt am 27. Okt. 2015

    21 SeitenMR01

    Eintragung der Belastung 026779060015, erstellt am 27. Okt. 2015

    60 SeitenMR01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    4 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GOLDSMITH, Christopher William
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    Sekretär
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    British13230340005
    DEACON, Timothy John
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    United KingdomBritish102496140001
    GOLDSMITH, Christopher William
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    United KingdomBritish13230340005
    GREGORY, Yvette Marie
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    Geschäftsführer
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    EnglandBritish197416740001
    WESTLEX REGISTRARS LIMITED
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    Bevollmächtigter Sekretär
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    900005880001
    BARNES, Sara Anne
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    United Kingdom
    United KingdomBritish98921440001
    CARTER, Andrew Stewart
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Geschäftsführer
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    United KingdomBritish145669000001
    CARTER, Andrew Stewart
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Geschäftsführer
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    United KingdomBritish145669000001
    HOLMES, Colin Robert
    Chantry Mid Meadow
    Hungate Lane
    NR34 9TP Beccles
    Suffolk
    Geschäftsführer
    Chantry Mid Meadow
    Hungate Lane
    NR34 9TP Beccles
    Suffolk
    United KingdomBritish8041680001
    HUGHSON, David Callum
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    Geschäftsführer
    55 Gracechurch Street
    EC3V 0UF London
    British62284790002
    MARTIN, Julia Helen
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    Geschäftsführer
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    British84688790001
    MARTIN, Julia Helen
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    Geschäftsführer
    79 Streathbourne Road
    SW17 8RA London
    British84688790001
    MOULDER, Stuart Christopher
    Uvongo House Blackmore Road
    Blackmore
    CM4 0QX Ingatestone
    Essex
    Geschäftsführer
    Uvongo House Blackmore Road
    Blackmore
    CM4 0QX Ingatestone
    Essex
    EnglandBritish46329920001
    PARDOE, Richard Grenville
    Cherry Tree Cottage
    17 West Avenue
    HP10 8AE Penn
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Cherry Tree Cottage
    17 West Avenue
    HP10 8AE Penn
    Buckinghamshire
    EnglandBritish141544990001
    SCOTT, Nicholas Peter
    7 Poplar Close
    Great Gransden
    SG19 3AX Sandy
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    7 Poplar Close
    Great Gransden
    SG19 3AX Sandy
    Bedfordshire
    EnglandBritish108455130001
    TAME, Russell
    Orchard House
    1a Mill Road
    CB21 5LT West Wratting
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Orchard House
    1a Mill Road
    CB21 5LT West Wratting
    Cambridgeshire
    British117422530001
    WESTLEX REGISTRARS LIMITED
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    21 Southampton Row
    WC1B 5HS London
    900005880001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Turnstone Estates Ltd
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    England
    15. Jan. 2017
    33 Bridge Street
    CB2 1UW Cambridge
    The Warehouse
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat TURNSTONE INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 02. Sept. 2016
    Geliefert am 09. Sept. 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    By way of legal mortgage the property on the south west side of parkway chelmsford essex and registered at the land registry under title number EX641103.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Winchester Estates Limited (A Company Registered in Gibraltar with Company Number 90002)
    Transaktionen
    • 09. Sept. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 27. Okt. 2015
    Geliefert am 02. Nov. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The freehold property on the south west side of parkway chelmsford essex and registered at the land registry under title number EX641103.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Euro Dinero S.À R.L.
    Transaktionen
    • 02. Nov. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 27. Okt. 2015
    Geliefert am 28. Okt. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Any present or future freehold or leasehold property in which the company has an interest and includes all buildings and fixtures on that property, the proceeds of sale of any part of that property, any licence, agreement for sale or agreement for lease in relation to that property, the benefit of any covenants for title given or entered into by any predecessor in title of the company in respect of that property and any monies paid or payable in respect of those covenants.. All patents, trademarks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, know how and other intellectual property rights and any interests including by way of licence in any of the foregoing in each case whether registered or not and the benefit of all applications for and rights to use any such assets.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Euro Dinero S.À R.L.
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 27. Okt. 2015
    Geliefert am 28. Okt. 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    The freehold property on the south west side of parkway chelmsford essex and registered at the land registry under title number EX641103.
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Euro Dinero S.À R.L.
    Transaktionen
    • 28. Okt. 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 09. Jan. 2017Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Dez. 2007
    Geliefert am 08. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land k/a army & navy parkway chelmsford essex t/no EX641103, 128 parkway chelmsford essex t/no EX342427, 130 parkway chelmsofrd essex EX433394 (for further details of properties charged please refer to form 395) all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge
    Erstellt am 06. Dez. 2007
    Geliefert am 08. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of a first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over agreement for lease
    Erstellt am 06. Dez. 2007
    Geliefert am 08. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its present and future rights title and interest in and to the agreement for lease; sums which shall from time to time become payable to the company from the operator. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over agreement for lease
    Erstellt am 06. Dez. 2007
    Geliefert am 08. Dez. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to any related security document to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All of its present and future rights title and interest in and to the agreement for lease; sums which shall from time to time become payable to the company from the operator. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge
    Erstellt am 28. Jan. 2000
    Geliefert am 02. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 103 mill road cambridge fixtures and fittings thereon all monies to the credit of any account all rental and other monies and the proceeds of any insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 02. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. März 1999
    Geliefert am 01. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H kwik-save supermarket 1-3 upper green east micham-SGL109533. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Jan. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Dez. 1997
    Geliefert am 13. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h land and buildings k/a 3 high street brentwood essex t/n EX347522, 4 culver street west colchester essex t/n EX439617 and 23 strait bargate boston lincolnshire t/n LL142866 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transaktionen
    • 13. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 21. Okt. 1997
    Geliefert am 21. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this charge as defined therein
    Kurze Angaben
    23 strait bargate, boston, lincolnshire title number LL142866 and the proceeds of sale, benefit of all rights and claims. Floating charge over all movable plant, machinery, implements, building materials of all kinds, utensils, furniture and equipment, undertaking and all other property assets and rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limitedincluding Where the Context Admits Its Successors, Transferees and Assigns
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Conveyance
    Erstellt am 05. Mai 1995
    Geliefert am 10. Mai 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the conveyance
    Kurze Angaben
    Land situate to the north west of springfield road chelmsford essex.
    Berechtigte Personen
    • Secretary of State for Transport
    Transaktionen
    • 10. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental charge
    Erstellt am 30. März 1995
    Geliefert am 31. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a facility letter,the charge or this charge supplemental to the charge dated 2 november 1993
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge the benefit of all rights and claims to which the mortgagor is entitled under the documents listed in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 31. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Sept. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 13. Juli 1994
    Geliefert am 18. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any transferee (as defined in clause 17.1 of the deed) under the terms of the facility letter (as defined) and all other monies due on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land situated on the north west side of springfield road, chelmsford, essex and by way of specific charge all the income and rights relating thereto floating charge over all movable plant, materials, machinery, implements, utensils, furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 18. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Mai 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 20. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 02. Nov. 1993
    Geliefert am 10. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 3 new street boston t/n/ LL61670, and various other properties as listed on schedule to form 395 all rights, and/or the proceeds of sale thereof the details in col.5 Have this day been amended.please see doc.M91C.J.M.evans 1/12/93. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Sept. 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 16. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 05. Mai 1992
    Geliefert am 12. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 24TH march 1992 and/or this charge and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (See 395 for full details of property charged). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 12. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0