CITY SCREEN (CLAPHAM) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CITY SCREEN (CLAPHAM) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02682013 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITY SCREEN (CLAPHAM) LIMITED?
- Filmvorführungen (59140) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich CITY SCREEN (CLAPHAM) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8th Floor Vantage London Great West Road TW8 9AG Brentford England England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITY SCREEN (CLAPHAM) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CITY SCREEN (CLAPHAM) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Roei Kaufman als Direktor am 21. März 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ariel Nisim Bouskila als Geschäftsführer am 21. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. Jan. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Fiona Elizabeth Smith am 24. Okt. 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Vincent Gregory Jervis als Geschäftsführer am 30. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Widerruf des Antrags auf Löschung der Gesellschaft | 1 Seiten | DS02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ariel Nisim Bouskila als Direktor am 31. Okt. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lyn Mary Goleby als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Power Road Studios 114 Power Road Chiswick London W4 5PY zum 8th Floor Vantage London Great West Road Brentford England TW8 9AG am 24. Okt. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Merav Keren als Direktor am 01. Juli 2015 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Jan. 2015 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Bowcock als Geschäftsführer am 09. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 2 Seiten | MISC | ||||||||||
Verschiedenes Section 519 | 3 Seiten | MISC | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 26. Dez. 2013 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Wiener als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CITY SCREEN (CLAPHAM) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Fiona Elizabeth | Sekretär | Great West Road TW8 9AG Brentford 8th Floor Vantage London England England | British | 182083190001 | ||||||||||
| KAUFMAN, Roei | Geschäftsführer | Great West Road TW8 9AG Brentford 8th Floor Vantage London England England | United Kingdom | Romanian | 227938020001 | |||||||||
| KEREN, Merav | Geschäftsführer | Great West Road TW8 9AG Brentford 8th Floor Vantage London England England | United Kingdom | Israeli | 199412670001 | |||||||||
| OATEY, Alastair Irven | Sekretär | Lawrance Lea Harston CB22 7QR Cambridge 3 Cambridgeshire | British | 85567070003 | ||||||||||
| PALMER, Leigh Graham | Sekretär | 46 Farriers Road IP14 2NS Stowmarket Suffolk | British | 16962140001 | ||||||||||
| SHERWOOD, Jacquelyn | Sekretär | Courtlands Rushbrooke Lane IP33 2RR Bury St Edmunds Suffolk | British | 37270270001 | ||||||||||
| OLSWANG COSEC LIMITED | Sekretär | High Holborn WC1V 6XX London 90 United Kingdom |
| 83864780002 | ||||||||||
| BOUSKILA, Ariel Nisim | Geschäftsführer | Great West Road TW8 9AG Brentford 8th Floor Vantage London England England | Israel | Israeli | 217850580001 | |||||||||
| BOWCOCK, Philip | Geschäftsführer | Power Road Chiswick W4 5PY London Power Road Studios United Kingdom | United Kingdom | British | 166007090001 | |||||||||
| GOLEBY, Lyn Mary | Geschäftsführer | Witnesham Hall Church Lane Witnesham IP6 9JD Ipswich Suffolk | England | British | 7611970003 | |||||||||
| JERVIS, Vincent Gregory | Geschäftsführer | Great West Road TW8 9AG Brentford 8th Floor Vantage London England England | United Kingdom | British | 83038090001 | |||||||||
| JONES, Anthony John | Geschäftsführer | 6 Hauxton Road Trumpington CB2 2LT Cambridge Cambridgeshire | England | British | 61423430002 | |||||||||
| WIENER, Stephen Mark | Geschäftsführer | Power Road W4 5PY Chiswick Power Road Studios London United Kingdom | United Kingdom | United States | 41603390004 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CITY SCREEN (CLAPHAM) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picturehouse Cinemas Limited | 06. Apr. 2016 | Great West Road TW8 9AG Brentford 8th Floor Vantage West Middlesex | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CITY SCREEN (CLAPHAM) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 18. Aug. 2010 Geliefert am 31. Aug. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 04. Apr. 2003 Geliefert am 10. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 21. Mai 1999 Geliefert am 04. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Feb. 1999 Geliefert am 25. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Venn house, venn street, clapham, london borough of lambeth title number TGL151086. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Feb. 1999 Geliefert am 25. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The plough hall venn street clapham l/b lambeth-TGL76955. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Feb. 1999 Geliefert am 17. Feb. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 30. Juni 1998 Geliefert am 08. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The l/h property k/a venn house venn street clapham london t/n TGL29642. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 29. März 1996 Geliefert am 12. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H-76 venn street clapham t/n-TGL76955 and or the proceeds of sale tehreof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. März 1996 Geliefert am 05. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 10. Aug. 1992 Geliefert am 17. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of guaranteed secured bonds 1994-98 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0