CLARKE LYONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCLARKE LYONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02682939
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CLARKE LYONS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich CLARKE LYONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O BAKER TILLY RESTRUCTURING & RECOVERY LLP
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CLARKE LYONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Mai 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CLARKE LYONS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für CLARKE LYONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    20 Seiten4.72

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Mill House 211 Buxton Road, Hazel Grove Stockport Greater Manchester SK7 6NA* am 04. Apr. 2014

    2 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    6 Seiten4.20

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESEX

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Änderung der Details des Direktors für Mr Derek Rodney Fisk am 03. Sept. 2010

    3 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. März 2014

    Kapitalaufstellung am 07. März 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Christopher Sanderson Swain am 03. März 2010

    2 SeitenCH03

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Mai 2012

    4 SeitenAA

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Nov. 2011 bis 31. Mai 2012

    1 SeitenAA01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Derek Rodney Fisk am 30. Jan. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Kenneth Clarke am 30. Jan. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2010

    5 SeitenAA

    legacy

    5 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2011

    14 SeitenAR01

    legacy

    5 SeitenMG01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Jan. 2010

    14 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Derek Fisk als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Nov. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    Wer sind die Geschäftsführer von CLARKE LYONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SWAIN, Christopher Sanderson
    Cors Goch
    LL76 8TZ Llanbedrgoch
    Mynydd
    Gwynedd
    United Kingdom
    Sekretär
    Cors Goch
    LL76 8TZ Llanbedrgoch
    Mynydd
    Gwynedd
    United Kingdom
    British25436300003
    CLARKE, Stephen Kenneth
    Mill House
    211 Buxton Road Hazelgrove
    SK7 6NA Stockport
    Geschäftsführer
    Mill House
    211 Buxton Road Hazelgrove
    SK7 6NA Stockport
    EnglandBritish23397880003
    FISK, Derek Rodney
    211 Buxton Road
    Hazel Grove
    SK7 6NA Stockport
    Mill House
    Cheshire
    Uk
    Geschäftsführer
    211 Buxton Road
    Hazel Grove
    SK7 6NA Stockport
    Mill House
    Cheshire
    Uk
    United KingdomBritish20469990010
    FISK, Derek Rodney
    Deveron
    Ilbert Road Thurleston
    TQ7 3NY Kingsbridge
    Sekretär
    Deveron
    Ilbert Road Thurleston
    TQ7 3NY Kingsbridge
    British20469990007
    LYONS, William John
    12 Winchester Park
    Didsbury
    M20 2TN Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    12 Winchester Park
    Didsbury
    M20 2TN Manchester
    Lancashire
    British2199540001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Sekretär
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    FISK, Gillian Mary
    46 Moss Road
    SK9 7HZ Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    46 Moss Road
    SK9 7HZ Alderley Edge
    Cheshire
    British39267240002
    LYONS, William John
    12 Winchester Park
    Didsbury
    M20 2TN Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    12 Winchester Park
    Didsbury
    M20 2TN Manchester
    Lancashire
    British2199540001
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    Hat CLARKE LYONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 06. Apr. 2011
    Geliefert am 07. Apr. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £800,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land at palatine road northenden manchester t/n GM956890.
    Berechtigte Personen
    • Martin Andrew Rawlings
    Transaktionen
    • 07. Apr. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Feb. 2011
    Geliefert am 04. Feb. 2011
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the south side of palatine road manchester t/no. GM956890 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 04. Feb. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Dez. 2006
    Geliefert am 19. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to the south of eddystone road yarmer estate thurlestone kingsbridge devon k/a plot no 7 eddystone road aforesaid. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 02. Sept. 2005
    Geliefert am 17. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Sept. 2005
    Geliefert am 15. Sept. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plot 2 deveron ibert road devon. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Juli 2002
    Geliefert am 20. Juli 2002
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage 35 old broadway, withington, manchester and land adjoining. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 2002Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Aug. 2000
    Geliefert am 31. Aug. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as development land at 2 heaton road withington manchester and at rear of 425 wilmslow road withington manchester. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Jan. 1996
    Geliefert am 06. Feb. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 102 palatine road west didsbury manchester t/n gm 707237 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Mai 1995
    Geliefert am 23. Mai 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings at churchwood road didbury manchester t/nos. GM577794 GM662809 and GM528143. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Vernon Building Society
    Transaktionen
    • 23. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Dez. 1994
    Geliefert am 23. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings fronting and to the rear of 1A,1B and 1C churchwood road didsbury manchester greater manchester title nos GM577794,GM528143 and GM662809 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Mai 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. März 1994
    Geliefert am 07. Apr. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/as land at bath street, sandbach, cheshire t/nos CH318495 and CH289691 the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Apr. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 25. Aug. 1993
    Geliefert am 10. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at 18 & 20 grove lane didsbury manchester with the proceeds of sale with a the assignment of the goodwill of the business & the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Jan. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Mai 1992
    Geliefert am 06. Mai 1992
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at redland avenue reddish stockport greater manchester title no: GM563262 CH80891(part) GM597336, GM597337 and/orthe proceeds of sale thereof floating charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment the entry in col.6 Above has this day been amended please see doc.M57 R.M.groves 10/8/92.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)

    Hat CLARKE LYONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. März 2014Beginn der Liquidation
    15. Aug. 2015Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Donald Bailey
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Lindsey J Cooper
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    M3 3HF Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0