LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02683478 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
- Herstellung von sonstigen Spezialmaschinen (28990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lock House Neville Street Chadderton OL9 6LF Oldham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| YAMATO LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED | 28. Jan. 1992 | 28. Jan. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Edward Ufland als Geschäftsführer am 13. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Matthew Deakin als Geschäftsführer am 30. Okt. 2017 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 3 Seiten | AC92 | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für S & J Registrars Limited am 01. Mai 2015 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 05. Aug. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 7 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Jan. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ola Tricia Aramita Barreto-Morley als Geschäftsführer am 31. März 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S & J REGISTRARS LIMITED | Sekretär | Aldermanbury Square 13th Floor EC2V 7HR London 5 England |
| 43122090005 | ||||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Geschäftsführer | Lock House Neville Street Chadderton OL9 6LF Oldham | United Kingdom | British | 161583790003 | |||||||||
| CODRINGTON, Ronald George | Sekretär | 7 Saumur Way CV34 6LH Warwick Warwickshire | British | 776800001 | ||||||||||
| GARNETT, David John Edward | Sekretär | 13 Cunliffe Drive M33 3WS Sale Cheshire | British | 41691700001 | ||||||||||
| SMITH, Maureen | Sekretär | 31 Juliet Drive Bilton CV22 6LY Rugby Warwickshire | British | 23498410001 | ||||||||||
| SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 9 Perseverance Works Kingsland Road E2 8DD London | 900000980001 | |||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Geschäftsführer | Lock House Neville Street Chadderton OL9 6LF Oldham | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Geschäftsführer | Lock House Neville Street Chadderton OL9 6LF Oldham | United Kingdom | British | 146225080002 | |||||||||
| DEIGHTON, David Martin | Geschäftsführer | 47 Ivygreen Drive Springhead OL4 4PR Oldham Lancashire | British | 67817050001 | ||||||||||
| GARNETT, David John Edward | Geschäftsführer | 13 Cunliffe Drive M33 3WS Sale Cheshire | England | British | 41691700001 | |||||||||
| HARTLEY, Peter Robert | Geschäftsführer | 29 Kirkdale Drive Royton OL2 5TG Oldham Lancashire | England | British | 67818140001 | |||||||||
| HIRANI, Hitesh Ratna | Geschäftsführer | 20 Wensleydale Close Royton OL2 5TQ Oldham Lancashire | England | British | 67817320001 | |||||||||
| HIRANO, Takashi | Geschäftsführer | 9-53 Rikyumae-Cho Suma-Ku FOREIGN Kobe-City Hyogo-Pref Japan | Japanese | 28029510001 | ||||||||||
| KAWANISHI, Shozo | Geschäftsführer | 4-12-5 Kurakuen FOREIGN Nishinomiya-City Hyogo-Pref 673 Japan | Japanese | 40054040001 | ||||||||||
| KIRKMAN, Anthony Terence | Geschäftsführer | 3 Cawdon Grove Dorridge B93 8EA Solihull West Midlands | British | 41435170001 | ||||||||||
| LOGUE, Neil Joseph | Geschäftsführer | The Stable House Lutterworth Road, North Kilworth LE17 6JE Lutterworth Leicestershire | United Kingdom | Irish | 151942010001 | |||||||||
| LONDON, Philip Ronald | Geschäftsführer | 31 Mayall Drive Four Oaks B75 5LR Sutton Coldfield West Midlands | British | 70642220001 | ||||||||||
| LONG, Mark Peter | Geschäftsführer | 11 Ashley Drive Bramhall SK7 1EW Stockport Cheshire | British | 52377020001 | ||||||||||
| MASSEY, Harry | Geschäftsführer | 25 Strathmore Close Ramsbottom BL0 9YW Bury Lancashire | British | 67817440001 | ||||||||||
| MCCARTHY, John Patrick | Geschäftsführer | 184 Simmondley Lane SK13 6LY Glossop Derbyshire | British | 70339800001 | ||||||||||
| PRINGLE, Frank Edwin | Geschäftsführer | 1109b Aspen Court FOREIGN Kohler Wisconsin 53044 Usa | American | 28029500001 | ||||||||||
| RANDALL, Michael Raymond David, Dr | Geschäftsführer | Poplars The Avenue Rowledge GU10 4AL Farnham Surrey | England | British | 15272540001 | |||||||||
| RANDALL, Michael Raymond David, Dr | Geschäftsführer | Poplars The Avenue Rowledge GU10 4AL Farnham Surrey | England | British | 15272540001 | |||||||||
| ROBINSON, Geoffrey | Geschäftsführer | Orchards Munstead Heath GU8 4AR Godalming Surrey | England | British | 79887440001 | |||||||||
| ROSS, Alan Irving | Geschäftsführer | 20 Rawson Crescent KA5 5AT Mauchline Ayrshire | England | British | 120484750001 | |||||||||
| STALKER, Michael | Geschäftsführer | 3 Tatchbury Road Failsworth M35 9PZ Manchester Lancashire | British | 70339920001 | ||||||||||
| SUMMERFIELD, Peter Humphrey | Geschäftsführer | 17 Grendon Road B92 7EL Solihull West Midlands | British | 56557810002 | ||||||||||
| UFLAND, Edward | Geschäftsführer | Lock House Neville Street Chadderton OL9 6LF Oldham | United Kingdom | British | 87558180001 | |||||||||
| WALSH, James Laurence | Geschäftsführer | 4 Canterbury Park Holme Road M20 2UQ Didsbury Lancashire | British | 61934910003 | ||||||||||
| WOOD, John Denis George | Geschäftsführer | 21 Northwick Crescent B91 3TU Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 41350610001 | |||||||||
| WILDMAN & BATTELL LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 9 Perseverance Works Kingsland Road E2 8DD London | 900000970001 |
Hat LOCK INSPECTION SYSTEMS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of deposit | Erstellt am 12. Nov. 2012 Geliefert am 27. Nov. 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit of £15,000 and all amounts in the future credited to account number 64303586 with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 15. Okt. 2004 Geliefert am 20. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 15. Okt. 2004 Geliefert am 20. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings on the east side of neville street, oldham t/no. GM577209 and l/h property k/a premises on the west side of neville street, oldham t/no. GM481866. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Dez. 1998 Geliefert am 08. Jan. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (including for the avoidance of doubt, the debenture) | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage f/h & l/h land at neville street oldham t/nos: GM481866 and GM577209. .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Geliefert am 21. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Geliefert am 21. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and buildings situate on the west side of neville street oldham greater manchester t/n gm 481866. together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 17. Dez. 1992 Geliefert am 21. Dez. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land and buildings situate on the east side of neville street oldham greater manchester t/n gm 577209. together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0