NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED

NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02684941
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SIMCO 474 LIMITED06. Feb. 199206. Feb. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    8 Seiten4.71

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 1 Admiral Way Doxford International Business Park, Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP am 14. Sept. 2012

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 04. Sept. 2012

    LRESSP

    Ernennung von Mr Kenneth Mcintyre Carlaw als Direktor am 28. Aug. 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Nigel Paul Featham als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von David Cocker als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    6 SeitenAA

    Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 26. Mai 2012

    1 SeitenCH03

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Mai 2012

    Kapitalaufstellung am 03. Mai 2012

    • Kapital: GBP 210,002
    SH01

    Ernennung von David Cocker als Direktor am 19. März 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David John Barry als Geschäftsführer am 19. März 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    6 SeitenAA

    Ernennung von Nigel Paul Featham als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Jonathan May als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für Richard Anthony Bowler am 04. Mai 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr David John Barry am 04. Mai 2011

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Paul May am 04. Mai 2011

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 03. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 03. Mai 2010

    1 SeitenCH03

    Wer sind die Geschäftsführer von NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    Geschäftsführer
    Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11
    EnglandBritish161250030001
    LAUCHT, Robert Ian
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    Sekretär
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    British13774020001
    RICHARDS, Lewis
    16 Dove House Lane
    B91 2EX Solihull
    West Midlands
    Sekretär
    16 Dove House Lane
    B91 2EX Solihull
    West Midlands
    British2452070001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    WATSON, Kenneth James
    1 Portsmouth Place
    DL1 2XH Darlington
    County Durham
    Sekretär
    1 Portsmouth Place
    DL1 2XH Darlington
    County Durham
    British29509590001
    SIMCO COMPANY SERVICES LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Sekretär
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    900004040001
    BARRY, David John
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish132225520001
    BOWLER, Richard Anthony
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish35116070001
    COCKER, David
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish37574310001
    FEATHAM, Nigel Paul
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritish161124990001
    GRACE, David Martin
    Woodhouse Back Lane
    Woolley
    WF4 2JT Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Woodhouse Back Lane
    Woolley
    WF4 2JT Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish27031320002
    HODGSON, Gordon William
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British1108360001
    HODGSON, Kenneth
    The Grange Church Lane
    Elvington
    YO41 4HD York
    Geschäftsführer
    The Grange Church Lane
    Elvington
    YO41 4HD York
    United KingdomBritish9946200002
    HUNTER, Michael John
    100 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    100 Manygates Lane
    Sandal
    WF2 7DP Wakefield
    West Yorkshire
    British1058260002
    KERSLAKE, Brian John
    Oaklands
    Coppenhall
    ST18 9BW Stafford
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Oaklands
    Coppenhall
    ST18 9BW Stafford
    Staffordshire
    British34169610003
    LAUCHT, Robert Ian
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    Geschäftsführer
    1 High Meadows, Church Lane
    Kirk Ella
    HU10 7NJ Hull
    East Riding Yorkshire
    United KingdomBritish13774020001
    LEEDER, David John
    3 Juniper House
    140 Narrow Street
    E14 8BP London
    Geschäftsführer
    3 Juniper House
    140 Narrow Street
    E14 8BP London
    EnglandBritish110562870001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Geschäftsführer
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    MARTIN, David Robert
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Bondwood Barn Repton Shrubs
    Bretby
    DE15 0RJ Burton On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish6874440001
    MAY, Jonathan Paul
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    1 Admiral Way
    Doxford International Business
    SR3 3XP Park, Sunderland
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish125675730002
    NOBLE, Stephen Leslie
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Brewery Close
    Stamfordham
    NE18 0PQ Northumberland
    Close House
    United Kingdom
    United KingdomBritish128655430001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Geschäftsführer
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    RICHARDSON, Susan
    3 Woodside
    NE46 1HU Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    3 Woodside
    NE46 1HU Hexham
    Northumberland
    British62146850001
    WATSON, Kenneth James
    1 Portsmouth Place
    DL1 2XH Darlington
    County Durham
    Geschäftsführer
    1 Portsmouth Place
    DL1 2XH Darlington
    County Durham
    EnglandBritish29509590001
    WHITE, Philip Michael
    25 Viceroy Close
    Bristol Road
    B5 7UR Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    25 Viceroy Close
    Bristol Road
    B5 7UR Birmingham
    West Midlands
    British5721830002
    WOOLNER, Andrew Edward
    Green Farm Back Lane
    Shustoke
    B46 2AP Coleshill
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Green Farm Back Lane
    Shustoke
    B46 2AP Coleshill
    Warwickshire
    British45409730001
    SIMCO DIRECTOR A LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    41 Park Square
    LS1 2NS Leeds
    West Yorkshire
    900004030001
    SIMCO DIRECTOR B LIMITED
    41 Park Square
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    England
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    41 Park Square
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    England
    900004020001

    Hat NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 31. Jan. 1995
    Geliefert am 10. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Bus depot caroline street bishop auckland title no DU168017,bus depot thorngate barnard castle durham title no DU166794,central workshop and headquarter offices morton road yarm road industrial estate darlington title no DU189820 tog with 23 various other properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Sept. 1994
    Geliefert am 15. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company undr the provisions of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land hereditaments and premises known as caroline street depot cockton hill bishop auckland durham together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Sept. 1994
    Geliefert am 15. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due form dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land hereditaments and premises k/a land and buildings on the east side of boathouse lane stockton on tees cleveland together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Sept. 1994
    Geliefert am 15. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the provisions of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land hereditaments and premises k/a land and bus depot at union street middlesbrough cleveland together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Sept. 1994
    Geliefert am 15. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the provisions of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land hereditaments and premises k/a land and buildings to the west of waddington street durham together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Sept. 1994
    Geliefert am 15. Sept. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dawntalk limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the provisions of the charge
    Kurze Angaben
    F/H land hereditaments and premises k/a land and buildings on the south side of davy drive north west industrial estate peterlee together with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 1993
    Geliefert am 30. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a land and bildings on south of davy drive north west ind: est: peterlee t/n DU119600. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 1993
    Geliefert am 30. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account wharsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a land and buildings on east of boathouse lane stockton-on-tees cleveland t/n CE96794. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 1993
    Geliefert am 30. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a caroline street depot and warehouse seymour st. Cockton hill bishop aukland durham t/n DU168017. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 1993
    Geliefert am 30. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Land and bus depot union street middlesborough cleveland t/n CE11928. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Dez. 1993
    Geliefert am 30. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from westcourt group limited to the chargee on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a land and buildings to west of waddington st. Durham t/n DU168088. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 08. Dez. 1993
    Geliefert am 13. Dez. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H propery k/a the travel enquiry office and toilets (ground floors only) at the bus station north road durham title no: DU76614.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the information kiosk and land beneath at the new bus station between clayton and saddler street bishop auckland county durham.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land at and k/a the bus station feethams darlington county durham title no: DU166934.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a first floor offices at middlesborough bus station middlesborough.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a the staff canteen at new bus station between clayton and saddler streets bishop auckland county durham.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a first floor offices kitchen and canteen at middlesborough bus station new port road middlesborough title no: CE83893.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a shpo unit no.7 Being premises on ground floor of middlesborough bus station.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 13. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land and buildings to nth. West of ovenhope way peterlee title no: DU84160.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge dated 23/03/1990
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 10. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal charge all/and every interest in the f/h land near to waddington street and shawwood,durham,county durham.t/no.du 168088.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge dated 23/03/1990
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 10. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal charge all/and every interest in the f/h land at the corner of park street and firby lane,ripon,north yorkshire containing 1,444 sq.yds and four ninths of a square yard.t/no.nyk 100128.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 10. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal charge all/and every interest in or over the f/h property k/a the bus depot situated in union street,derwent street,tay street and victoria street,middlesbrough,cleveland.t/no.ce 115928.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 10. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal charge all/and every interest in the f/h land lying to the south and south west side of north road,durham city.t/nos.du 54876 and du 31915.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer of whole and legal charge dated 23/03/1990
    Erstellt am 24. März 1992
    Geliefert am 10. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal charge all/and every intest in the f/h land at bents foot,gayle, near hawes,north yorkshire.t/no.nyk 99504.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NORTH EAST BUS PROPERTIES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    08. Apr. 2013Aufgelöst am
    04. Sept. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praktiker
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praktiker
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0