HOMEMALT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HOMEMALT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02686221 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HOMEMALT LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HOMEMALT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 17 Rochester Row Westminster SW1P 1QT London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HOMEMALT LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BRADVINE LIMITED | 11. Feb. 1992 | 11. Feb. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HOMEMALT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für HOMEMALT LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für HOMEMALT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mrs Francesca Anne Todd als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Shearer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2011
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 13 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Richard John Shearer als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Capita Group Secretary Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Ernennung von Capita Corporate Director Limited als Direktor | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HOMEMALT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Sekretär | Rochester Row Westminster SW1P 1QT London 17 England |
| 135207160001 | ||||||||||
| TODD, Francesca Anne | Geschäftsführer | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | England | British | 72249980002 | |||||||||
| CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED | Geschäftsführer | Rochester Row Westminster SW1P 1QT London 17 England |
| 129795770003 | ||||||||||
| BASHFORD, Howard | Sekretär | Grovelands 22 Station Road Cholsey OX10 9PT Wallingford Oxfordshire | British | 68140690003 | ||||||||||
| COSTER, Malcolm David | Sekretär | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | British | 39034110001 | ||||||||||
| COTTRELL, Paul Alan | Sekretär | 16 Goldcrest Drive TN22 5QG Uckfield East Sussex | British | 13754300002 | ||||||||||
| DUNN, Nigel Anthony | Sekretär | The White Lodge 219 Melton Road Edwalton NG12 4AF Nottingham Nottinghamshire | British | 3835120001 | ||||||||||
| GREEN, Michael | Sekretär | 4 Potterton Close Barwick In Elmet LS15 4DY Leeds West Yorkshire | British | 9581830001 | ||||||||||
| HART, Darren | Sekretär | 9 Siskin Close Mickleover DE3 0UL Derby Derbyshire | British | 109555160001 | ||||||||||
| MCINTYRE, David | Sekretär | Woodfield Park Colinton EH13 0RA Edinburgh 65 Scotland | 146806480001 | |||||||||||
| SMITH, David | Sekretär | Monks Way Hagg Nook Wood Newstead Abbey Park NG15 3GD Nottingham Notts | British | 31420700001 | ||||||||||
| L & A SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001450001 | |||||||||||
| ANDROLIA, Brian Melvin | Geschäftsführer | Draycott House Kempsey WR5 3NY Worcester | England | British | 8975540001 | |||||||||
| BASHFORD, Howard | Geschäftsführer | Grovelands 22 Station Road Cholsey OX10 9PT Wallingford Oxfordshire | British | 68140690003 | ||||||||||
| BRADLEY, Michael John | Geschäftsführer | Vantage Point 208 Henwick Road WR2 5PF Worcester | British | 40818740003 | ||||||||||
| CHAMBERS, Mark Richard | Geschäftsführer | 348 Goldington Road MK41 9NS Bedford Bedfordshire | United Kingdom | British | 141463800001 | |||||||||
| COSTER, Malcolm David | Geschäftsführer | Rivendell 46 Golfside South Cheam SM2 7EZ Sutton Surrey | England | British | 39034110001 | |||||||||
| DONOGHUE, William | Geschäftsführer | 22 Ennismore Gardens Knightsbridge SW7 1AB London | United Kingdom | Irish | 98508020002 | |||||||||
| DUNN, Nigel Anthony | Geschäftsführer | The White Lodge 219 Melton Road Edwalton NG12 4AF Nottingham Nottinghamshire | England | British | 3835120001 | |||||||||
| GREEN, Michael | Geschäftsführer | 4 Potterton Close Barwick In Elmet LS15 4DY Leeds West Yorkshire | England | British | 9581830001 | |||||||||
| MATTHEW, Gordon John | Geschäftsführer | Rogers Lane Ettrington CV37 3TA Stratford Upon Avon Saracens Yard Warwickshire | England | British | 151547160001 | |||||||||
| MCINTYRE, David Stephen | Geschäftsführer | Woodfield Park Colinton EH13 0RA Edinburgh 65 Scotland | United Kingdom | British | 107518360001 | |||||||||
| SHEARER, Richard John | Geschäftsführer | Rochester Row Westminster SW1P 1QT London 17 England | United Kingdom | British | 132651920002 | |||||||||
| SMITH, David | Geschäftsführer | Monks Way Hagg Nook Wood Newstead Abbey Park NG15 3GD Nottingham Notts | British | 31420700001 | ||||||||||
| SMITH, Peter John | Geschäftsführer | 73 Upton End Road Shillington SG5 3PE Hitchin Hertfordshire | United Kingdom | British | 94974400001 | |||||||||
| WINGFIELD, Richard Alan | Geschäftsführer | 1 Town Farm Close Thame OX9 2DA Oxford | England | British | 76932830002 | |||||||||
| L & A REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 31 Corsham Street N1 6DR London | 900001440001 |
Hat HOMEMALT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 2005 Geliefert am 20. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Dez. 2005 Geliefert am 15. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Erstellt am 02. Dez. 2005 Geliefert am 15. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 21. Dez. 2000 Geliefert am 09. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental guarantee and debenture between homemalt limited (the chargor), the data base (nottingham) limited & scart holdings limited (together "the charging companies") and skandinaviska enskilda banken ab (publ) (the security trustee) | Erstellt am 13. Jan. 2000 Geliefert am 31. Jan. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money and liabilities due or to become due from the chargor to each beneficiary (as defined) under or pursuant to the senior finance documents (as defined) and all money and liablities due or to become due by each other company (except as guarantor for the chargor) under or pursuant to the senior finance documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0