VXL INSTRUMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VXL INSTRUMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02687048 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VXL INSTRUMENTS LIMITED?
- Sonstige Informationsdienstleistungen im Bereich Informationstechnologie (62090) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich VXL INSTRUMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Langley House Park Road East Finchley N2 8EY London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VXL INSTRUMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VXL INSTRUMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Hinweis auf den Abschlussbericht vor der Auflösung | 11 Seiten | WU15 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dipak Shanker Rao als Sekretär am 21. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Dipak Shanker Rao als Geschäftsführer am 21. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Carrington Business Park, Carrington, Manchester Cheshire M31 4DD zum Langley House Park Road East Finchley London N2 8EY am 24. Feb. 2017 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Liquidators | 1 Seiten | 4.31 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Francis Noon als Geschäftsführer am 30. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2015 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Francis Noon am 13. Feb. 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2014 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2013 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | MG02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kumar Shyam als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mangalore Vittal Shetty am 01. Juli 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VXL INSTRUMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGARAJ, Madireddy Venkateshwaralu | Geschäftsführer | 23/50 11 Cross Vasanthnagar 560 052 Bangalore India | India | Indian | 41461720001 | |||||
| SHETTY, Mangalore Vittal | Geschäftsführer | No 605 Pine Block Raheja Residency Jakkasandra 560034 Kormangala Bangalore India | India | British | 98921310003 | |||||
| RAO, Dipak Shanker | Sekretär | 1 Salisbury Close KT4 7BY Worcester Park Surrey | British | 10793550001 | ||||||
| LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
| GAMBLE, Christopher | Geschäftsführer | 3 Hillmorton Lane Lilbourne CV23 0SS Rugby Warwickshire | British | 28335990001 | ||||||
| KASARGOD, Arvind Vithal | Geschäftsführer | Shri Kunj 24 Hanuman Road Vile Parle (East) 400 057 Bombay India | Indian | 35420200001 | ||||||
| MUNDKUR, Jagdish Ramesh | Geschäftsführer | 871 12th Main 111 Block Koramangala 560 034 Bangalore India | Indian | 35420130001 | ||||||
| NOON, Francis | Geschäftsführer | Hellifield Road Bolton By Bowland BB7 4NS Clitheroe Yew Tree Cottage Lancashire England | United Kingdom | British | 80894430002 | |||||
| RAO, Dipak Shanker | Geschäftsführer | 1 Salisbury Close KT4 7BY Worcester Park Surrey | England | British | 10793550001 | |||||
| SAVOOR, Sujai Raghunandan | Geschäftsführer | 1 Oldfield Drive Timperley WA15 6RU Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 24755950001 | |||||
| SHYAM, Kumar | Geschäftsführer | No. 72 10th Cross,, Temple Road 560 003 Malleswaram Bangalore India | India | British | 98921560002 | |||||
| LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Hat VXL INSTRUMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 08. Juli 2004 Geliefert am 17. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £700,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over all assets stocks and debtors. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 09. Dez. 2003 Geliefert am 18. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 02. Aug. 1995 Geliefert am 16. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 05. Apr. 1994 Geliefert am 07. Apr. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben The sum of £1,875.00 and any other sums from time to time paid by vxl instruments limited pursuant to the rent deposit deed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rent deposit deed | Erstellt am 30. Sept. 1992 Geliefert am 01. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed | |
Kurze Angaben The sum of £1,875.00 and any other sums from time to time paid by vxl instruments limited pursuant to the rent deposit deed feferred to above and not withdrawn by LCP properties limited and any interest earned on such monies and retained in the account in which such monies are lodged pursuant to the terms of the above mentioned rent deposit deed. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat VXL INSTRUMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0