SPRINGS COMMUNITY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSPRINGS COMMUNITY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02689545
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SPRINGS COMMUNITY LIMITED?

    • (7487) /

    Wo befindet sich SPRINGS COMMUNITY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Godden Green Clinic
    Godden Green
    TN15 0JR Sevenoaks
    Kent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SPRINGS COMMUNITY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GABLEDINE LIMITED20. Feb. 199220. Feb. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SPRINGS COMMUNITY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2008

    Welche sind die letzten Einreichungen für SPRINGS COMMUNITY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2008

    12 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    11 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    15 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    3 Seiten363a

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Gewährung finanzieller Unterstützung für den Erwerb von Aktien

    RES07
    capital

    Beschlüsse

    The documents 28/02/2008
    RES13

    legacy

    66 Seiten155(6)a

    legacy

    66 Seiten155(6)a

    legacy

    66 Seiten155(6)a

    legacy

    13 Seiten395

    legacy

    11 Seiten395

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    7 Seiten363s

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten288a

    legacy

    13 Seiten155(6)a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    9 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von SPRINGS COMMUNITY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DINHAM, Robin Christopher
    Hopgarden Road
    TN10 4QS Tonbridge
    21
    Kent
    Sekretär
    Hopgarden Road
    TN10 4QS Tonbridge
    21
    Kent
    British128459000001
    HUGHES, John Craig
    Lansdowne Crescent
    W11 2NT London
    41a
    Geschäftsführer
    Lansdowne Crescent
    W11 2NT London
    41a
    United KingdomUs84916320001
    WILSON, Kenneth Adrian Raymond
    179 Kings Road
    KT2 5JH Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    179 Kings Road
    KT2 5JH Kingston Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish51898330001
    HOLLANDS, Patricia
    Mallards
    Coast Drive, St. Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    Sekretär
    Mallards
    Coast Drive, St. Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    British59368340002
    HOLLANDS, Winifred May
    The Springs Coast Drive
    St Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    Sekretär
    The Springs Coast Drive
    St Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    British38967110002
    MUNDAY, Adrian
    14 Berkeley Avenue
    UB6 0NX North Greenford
    Middlesex
    Sekretär
    14 Berkeley Avenue
    UB6 0NX North Greenford
    Middlesex
    Uk99118300002
    SEMPLE, Robert Alan
    Eagle House
    Cranleigh Close
    CR2 Sanderstead
    Surrey
    Sekretär
    Eagle House
    Cranleigh Close
    CR2 Sanderstead
    Surrey
    British25345940001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Sekretär
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    HOLLANDS, James Ernest
    16 Ashenden Avenue
    TN31 7DU Rye
    Geschäftsführer
    16 Ashenden Avenue
    TN31 7DU Rye
    British112304880001
    HOLLANDS, Patricia
    Mallards
    Coast Drive, St. Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    Geschäftsführer
    Mallards
    Coast Drive, St. Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    British59368340002
    HOLLANDS, Patricia Anne
    Gun House Cannon Street
    TN28 8BH New Romney
    Kent
    Geschäftsführer
    Gun House Cannon Street
    TN28 8BH New Romney
    Kent
    British59368340001
    HOLLANDS, Richard
    Mallards
    Coast Drive, St. Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    Geschäftsführer
    Mallards
    Coast Drive, St. Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    British56146340002
    HOLLANDS, Richard Edward
    Gun House Cannon Street
    TN28 8BH New Romney
    Kent
    Geschäftsführer
    Gun House Cannon Street
    TN28 8BH New Romney
    Kent
    British25345960001
    HOLLANDS, Winifred May
    The Springs Coast Drive
    St Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    Geschäftsführer
    The Springs Coast Drive
    St Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    British38967110002
    WHITE, Albert Henry
    The Springs Coast Drive
    St Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    Geschäftsführer
    The Springs Coast Drive
    St Marys Bay
    TN29 0HN Romney Marsh
    Kent
    English13337830002
    WHITE, Clair
    90 Livingstone Road
    CR7 8JU Thornton Heath
    Surrey
    Geschäftsführer
    90 Livingstone Road
    CR7 8JU Thornton Heath
    Surrey
    British29853180001
    WHITE, David Leonard
    90 Livingstone Road
    CR7 8JU Thornton Heath
    Surrey
    Geschäftsführer
    90 Livingstone Road
    CR7 8JU Thornton Heath
    Surrey
    English13337840001
    WHITE, Derek Sidney
    69 Buxton Lane
    CR3 5HL Caterham
    Surrey
    Geschäftsführer
    69 Buxton Lane
    CR3 5HL Caterham
    Surrey
    British25345970003
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    Hat SPRINGS COMMUNITY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Feb. 2008
    Geliefert am 10. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each obligor to the chargee (as trustee for the finance parties) and the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Feb. 2008
    Geliefert am 10. März 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each obligor to the chargee (as trustee for the finance parties) and the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent for National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Mai 2006
    Geliefert am 30. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H property k/a pirate springs (otherwise the springs) coast drive st marys bay romney marsh kent t/n K152423 f/h land on the east side coast drive st marys bay romney marsh kent t/n K525615 and the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Jan. 2001
    Geliefert am 25. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property known as the springs coast drive st mary's bay kent TN29 ohn; t/nos K152423 and K525615. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2001
    Geliefert am 25. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Okt. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 28. Aug. 1998
    Geliefert am 04. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 04. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Aug. 1998
    Geliefert am 02. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a buildings and land on east side of coast drive littlestone on sea kent t/n K525615 and pirate springs coast drive littlestone on sea kent t/n K152423. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Aug. 1998
    Geliefert am 02. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Mallards coast drive st mary's bay kent t/n K128358. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transaktionen
    • 02. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Apr. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 01. Dez. 1992
    Geliefert am 10. Dez. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £180,000
    Kurze Angaben
    F/H property k/a pirate springs coast drive littlestine-on-sea new romney kent together with adjoining land t/nos K152423 and K525615 together with all fixtures (including trade fixtures)plant and machinery plus a first floating charge on all the company's other assets present and future including its uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Peter John Guest
    Transaktionen
    • 10. Dez. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0