EBBGATE NURSING HOMES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | EBBGATE NURSING HOMES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02690211 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Angel Court EC2R 7HJ London United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BASISFOCUS LIMITED | 24. Feb. 1992 | 24. Feb. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Harrison als Direktor am 27. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Stephen Picken als Geschäftsführer am 27. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Bupa Secretaries Limited am 08. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift 1 Angel Court London EC2R 7HJ verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Change of details for Bupa Investments Limited as a person with significant control on 08. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Bupa Secretaries Limited am 08. Dez. 2017 | 1 Seiten | CH04 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jonathan Stephen Picken am 08. Dez. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Bridge House, Outwood Lane Horsforth Leeds LS18 4UP zum 1 Angel Court London EC2R 7HJ am 08. Dez. 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Bupa House 15-19 Bloomsbury Way London WC1A 2BA verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 07. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 07. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | 107319700001 | |||||||||||
| HARRISON, Michael | Geschäftsführer | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 241166230001 | |||||||||
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom |
| 162768400001 | ||||||||||
| KING, Robert Frederick | Sekretär | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | 10012650001 | ||||||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 | |||||||||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||||||
| CANNON, Andrew John | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | England | British | 200461360001 | |||||||||
| DALY, Geoffrey William Stuart | Geschäftsführer | Sixpenny Buckle Coldhouse Hill GU22 0QS Woking Surrey | United Kingdom | British | 19464860003 | |||||||||
| DALY, Geoffrey William Stuart | Geschäftsführer | 97 Valiant House Vicarage Crescent SW11 3LX London | British | 19464860001 | ||||||||||
| DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||||||
| DHANDSA, Narinder, Dr | Geschäftsführer | D102 Montevetro 100 Battersea Church Road Battersea SW11 3YL London | England | British | 115844000001 | |||||||||
| ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | 40582650004 | |||||||||
| GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | 107664270003 | |||||||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||||||
| KING, Robert Frederick | Geschäftsführer | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | 10012650001 | ||||||||||
| LOS, Steven Michael | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 116895800001 | |||||||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Geschäftsführer | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||||||
| MOORE, Keith | Geschäftsführer | Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 49217290002 | |||||||||
| PICKEN, Jonathan Stephen | Geschäftsführer | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | United Kingdom | British | 189611450001 | |||||||||
| REITER, Simon Philip | Geschäftsführer | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 England | United Kingdom | British | 135845570001 | |||||||||
| ROBINSON, Anthony Leake | Geschäftsführer | 17 Chad Road Edgbaston B15 3ER Birmingham West Midlands | British | 48323880001 | ||||||||||
| SALISBURY, Nicholas William | Geschäftsführer | 14 Charmouth Road AL1 4SW St Albans Hertfordshire | England | British | 4380320002 | |||||||||
| SINCLAIR BROWN, Frederick John | Geschäftsführer | Rudge House Itchel Lane Crondall GU10 5PR Farnham Surrey | United Kingdom | British | 8070730003 | |||||||||
| STOREY, Roger Christopher | Geschäftsführer | 11 Newlands SG6 2JE Letchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 1663050001 | |||||||||
| TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||||||
| THOMAS, Oliver Henry Dixon | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 256549290001 | |||||||||
| TINDALL, Terence William | Geschäftsführer | 19 Oak Tree Close GU25 4JF Virginia Water Surrey | England | British | 4380330001 | |||||||||
| WALFORD, Arthur David | Geschäftsführer | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 6658190001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei EBBGATE NURSING HOMES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bupa Investments Limited | 06. Apr. 2016 | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat EBBGATE NURSING HOMES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2004 Geliefert am 14. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 2001 Geliefert am 11. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations due or to become due from the company to the chargee as trustee for the secured parties (as defined) (the "security trustee") or any of the other secured parties (as defined) including any liability in respect of any further advances made under the facilities or the mezzanine loan facility (as defined) on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second debenture | Erstellt am 27. Okt. 1998 Geliefert am 02. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All liabilities of any nature of ebbgate nursing homes (london) limited to the chargee and/or any receiver howsoever arising whether under or in connection with the indemnity or otherwise | |
Kurze Angaben Legal mortgage - f/h property k/a chestnut court nursing home newton street bury greater manchester-GM509158 and all and whole that plot of ground in the city of edinburgh and county of midlothian (for further details see form 395). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Standard security | Erstellt am 03. Sept. 1993 Geliefert am 16. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The whole of the plot of ground in the city of edingburgh and the county of mithlothian extending 4 acres on the soputh of liberton drive in the city of edingburgh and all fixtures and fittings and plant machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Aug. 1993 Geliefert am 20. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 12. Aug. 1993 Geliefert am 17. Aug. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposits held by the bank on account nos 40115894 and 22202960. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Mai 1992 Geliefert am 05. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 11/03/92,this debenture,and/or any other security documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0