QUDIS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | QUDIS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02692069 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von QUDIS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich QUDIS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von QUDIS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| QUDIS BYTECH LIMITED | 18. Aug. 1992 | 18. Aug. 1992 |
| SHELFCORP 17 LIMITED | 28. Feb. 1992 | 28. Feb. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von QUDIS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2014 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für QUDIS LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für QUDIS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 13. März 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 2 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 3 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2014 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Steven Paul Rigby am 23. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sir Peter Rigby am 23. Juli 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Feb. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von QUDIS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIGBY, Peter, Sir | Geschäftsführer | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | United Kingdom | British | 15654920006 | |||||
| RIGBY, Steven Paul | Geschäftsführer | James House Warwick Road B11 2LE Birmingham | England | British | 41996820011 | |||||
| BRATTESANI, Ingrid | Sekretär | 19 Hannington Way Burghfield Common RG7 3BE Reading Berkshire | British | 37646750003 | ||||||
| GILPIN, Nigel Peter | Sekretär | 172 Widney Lane B91 3LH Solihull West Midlands | British | 42299200003 | ||||||
| GOSSAGE, Neal Trevor | Sekretär | 20 Cawdell Drive LE12 5BW Long Whatton Leicestershire | British | 79300420001 | ||||||
| IVES, David Jonathan | Sekretär | 14 Hood Road Wimbledon SW20 0SR London | British | 16867340001 | ||||||
| MONKS, Terence John | Sekretär | Brantingham 24 Green Lane SL1 8DX Burnham Buckinghamshire | British | 80344460001 | ||||||
| RIGBY, James Peter | Sekretär | The Bell House Old Warwick Road CV35 7BT Rowington Warwickshire | British | 88633720001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Sekretär | Rivendell Little Aston Park Road Little Aston B74 3BZ Sutton Coldfield West Midlands | British | 12470210003 | ||||||
| TALLYSHAW LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 15 Wimpole Street W1M 8AP London | 900008440001 | |||||||
| IVES, David Jonathan | Geschäftsführer | 14 Hood Road Wimbledon SW20 0SR London | British | 16867340001 | ||||||
| JEFFERSON, Robert Charles | Geschäftsführer | Flat 5 The Grange 4 Boyn Hill Avenue SL6 4ER Maidenhead Berkshire | British | 62022640003 | ||||||
| JORDAN, Stephen | Geschäftsführer | 94 Oaklands Avenue Oxhey WD1 4LW Watford Hertfordshire | British | 25018550001 | ||||||
| PEIRSON, Keith Edward | Geschäftsführer | 4 Chantry Drive CM4 9HR Ingatestone Essex | British | 24346380001 | ||||||
| POWER, Penelope Frances | Geschäftsführer | Holly Cottages 29 Middle Bourne Lane Lower Bourne GU10 3NH Farnham Surrey | British | 59243160001 | ||||||
| ROBERTS, Neal Anthony | Geschäftsführer | Rivendell Little Aston Park Road Little Aston B74 3BZ Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 12470210003 | |||||
| RYAN, Peter Henry | Geschäftsführer | Chilbrook Farm Chilbrook Road Downside KT11 3PE Cobham Surrey | British | 25011740001 | ||||||
| SIMKIN, Paul | Geschäftsführer | 50 Heaton Road B91 2DZ Solihull West Midlands | British | 51418250001 | ||||||
| WHEELER, Debra Ann | Geschäftsführer | 7 Streeton Close South End RG7 6NZ Bradfield Berkshire | British | 37646640001 | ||||||
| TALLYSHAW LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 15 Wimpole Street W1M 8AP London | 900008440001 |
Hat QUDIS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed and floating charge | Erstellt am 19. Okt. 1995 Geliefert am 28. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Aug. 1992 Geliefert am 20. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Aug. 1992 Geliefert am 20. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from shelfcorp 17 limited now known as qudis bytech limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Aug. 1992 Geliefert am 25. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due fro shelfcorp 17 limited now known as qudis bytech LTD to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Aug. 1992 Geliefert am 21. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Aug. 1992 Geliefert am 21. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Aug. 1992 Geliefert am 20. Aug. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in respect of the business sale agreement dated 18 july 1992 and/or the stock facility agreement dated 17 august 1990 and/or this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0