RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aktiv |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02692529 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED?
- Erzeugung von Elektrizität (35110) / Versorgung mit Elektrizität, Gas, Dampf und klimatisierten Luft
- Tätigkeit anderer Holdinggesellschaften n.n.a. (64209) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Windmill Hill Business Park Whitehill Way SN5 6PB Swindon Wiltshire England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
E.ON CLIMATE & RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED | 08. Apr. 2008 | 08. Apr. 2008 |
E.ON UK RENEWABLES OPERATIONS LIMITED | 23. Mai 2007 | 23. Mai 2007 |
E.ON UK RENEWABLES LIMITED | 05. Juli 2004 | 05. Juli 2004 |
POWERGEN RENEWABLES LIMITED | 11. Okt. 1996 | 11. Okt. 1996 |
POWERGEN HAVERIGG LIMITED | 05. Juni 1995 | 05. Juni 1995 |
POWERGEN (HAVERIGG) LIMITED | 13. Apr. 1992 | 13. Apr. 1992 |
EMITFOCUS LIMITED | 02. März 1992 | 02. März 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED?
Überfällig | Nein |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 31. Dez. 2024 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Sept. 2025 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2023 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED?
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 11. Apr. 2025 |
---|---|
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 25. Apr. 2025 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 11. Apr. 2024 |
Überfällig | Nein |
Welche sind die letzten Einreichungen für RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2023 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Katja Loncaric als Sekretär am 01. Mai 2024 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Penelope Anne Sainsbury als Sekretär am 01. Mai 2024 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Timothy Roy Hillsdon als Direktor am 24. Mai 2024 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nia Ann Griffiths als Geschäftsführer am 22. März 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Apr. 2024 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Mark Henderson als Geschäftsführer am 22. März 2024 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Nia Ann Griffiths am 12. Jan. 2024 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Nia Ann Griffiths als Direktor am 01. Okt. 2023 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adam Charles Greenslade als Geschäftsführer am 01. Okt. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Apr. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Windmill Hill Business Park Whitehill Way Swindon Wiltshire SN5 6PB verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||||||||||
Change of details for Rwe Renewables Uk Limited as a person with significant control on 01. März 2023 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Greenwood House Westwood Way Westwood Business Park Coventry CV4 8PB England zum Windmill Hill Business Park Whitehill Way Swindon Wiltshire SN5 6PB am 01. März 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 32 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Alex Ian Murkin als Direktor am 01. Mai 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Benjamin James Freeman als Geschäftsführer am 30. Apr. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 11. Apr. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jonathan Mark Henderson als Direktor am 28. Feb. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 35 Seiten | AA | ||||||||||
Change of details for Rwe Renewables Uk Limited as a person with significant control on 01. Juli 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Erklärung der Unternehmensgegenstände | 2 Seiten | CC04 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 17 Seiten | MA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LONCARIC, Katja | Sekretär | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | 324224220001 | |||||||||||
BURGESS, Dean | Geschäftsführer | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | England | British | Director | 277079830001 | ||||||||
HILLSDON, Timothy Roy | Geschäftsführer | Windmill Hill Business Park Whitehill Way SN5 6PB Swindon Trigonos Wiltshire England | Wales | British | Director | 315053260001 | ||||||||
MURKIN, Alex Ian | Geschäftsführer | Windmill Hill Business Park Whitehill Way SN5 6PB Swindon Trigonos Wiltshire England | England | British | Accountant | 305651260001 | ||||||||
BYGRAVES, Mark Lindsay | Sekretär | 30 Heath Terrace CV32 5NA Leamington Spa Warwickshire | British | 64653700001 | ||||||||||
FAIRCLOUGH, Ian Peter | Sekretär | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8LG Coventry | British | 55444950001 | ||||||||||
FAIRCLOUGH, Ian Peter | Sekretär | 17 Claremont Road CV31 3EH Leamington Spa Warwickshire | British | 55444950001 | ||||||||||
JACKSON, David John | Sekretär | Firs House Bampton Road OX18 2RG Clanfield Oxfordshire | British | 6518080003 | ||||||||||
SAINSBURY, Penelope Anne | Sekretär | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | 272681140001 | |||||||||||
THOMAS, Chantal | Sekretär | 173 Station Road Kings Heath B14 7TB Birmingham West Midlands | British | 76279290001 | ||||||||||
E.ON UK SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Westwood Business Park CV4 8LG Coventry Westwood Way England |
| 65676600010 | ||||||||||
BALDWIN, Nicholas Peter | Geschäftsführer | 4 Barbourne Court Barbourne Crescent WR1 3JF Worcester | British | Director | 54043530001 | |||||||||
BARBER, Rodney George | Geschäftsführer | 39 Chiswick Staithe Hartington Road W4 3TP London | British | Corporate Treasurer | 34400980001 | |||||||||
BELL, Timothy James | Geschäftsführer | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8PB Coventry Greenwood House England | United Kingdom | British | Head Of Controlling Offshore And Onshore Eu | 203003320001 | ||||||||
BLOKHUIZEN, Rene | Geschäftsführer | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8LG Coventry | England | Dutch | Onshore Wind Origination Manager | 186957240001 | ||||||||
CHAPPELL, Terence Edward | Geschäftsführer | Markham House The Common Broadheath WR2 6RL Worcester Worcestershire | British | Projects Manager | 33534580001 | |||||||||
COCKER, Anthony David | Geschäftsführer | The Tythe Barn Snitterfield Road Bearley CV37 0SH Stratford On Avon Warwickshire | England | British | Managing Director | 236308800001 | ||||||||
DAVYS, Vian Robert | Geschäftsführer | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8LG Coventry | England | British | Head Of Asset Construction | 200600930001 | ||||||||
DRAPER, Mark Robert | Geschäftsführer | Dale Hill Dale Road, Southfleet DA13 9NX Gravesend Kent | British | Divisional Managing Director | 78733130001 | |||||||||
FARRIER, David Allen | Geschäftsführer | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8LG Coventry West Midlands | United Kingdom | British | Development Manager | 42900110001 | ||||||||
FLAIG, Roland Sven Walter | Geschäftsführer | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8PB Coventry Greenwood House England | Sweden | Swedish | Head Of Operations Northern Europe | 211592460001 | ||||||||
FREEMAN, Benjamin James | Geschäftsführer | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | England | British | Accountant | 172561030002 | ||||||||
GREENSLADE, Adam Charles | Geschäftsführer | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | England | British | Onshore Wind Operations Manager Uk & Nordic | 225909920001 | ||||||||
GRIFFITHS, Nia Ann | Geschäftsführer | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | Wales | Welsh | Director | 314358670002 | ||||||||
HENDERSON, Jonathan Mark | Geschäftsführer | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | England | British | Director | 264250790001 | ||||||||
JACKSON, David John | Geschäftsführer | Firs House Bampton Road OX18 2RG Clanfield Oxfordshire | British | Solicitor | 6518080003 | |||||||||
KENNETT, Robert John | Geschäftsführer | Robert Hall Road LE8 5UX Arnesby The Old Farmhouse Leicestershire | United Kingdom | British | Managing Director | 133649950001 | ||||||||
LOCKE, Alasdair James Dougall | Geschäftsführer | Glenrinnes Lodge Dufftown AB55 4BS Keith Banffshire Scotland | United Kingdom | British | Finacial Consultant | 115457770001 | ||||||||
MELVILLE-SMITH, Peter Haldane, Doctor | Geschäftsführer | 5 Martley Croft B91 3TW Solihull West Midlands | British | Commercial Manager | 17862790001 | |||||||||
MULVIHILL, Paul, Dr | Geschäftsführer | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8LG Coventry | England | British | Operations Manager | 174491740001 | ||||||||
PLOWMAN, Keith | Geschäftsführer | 14 Hanbury Road Stoke Heath B60 4LR Bromsgrove Worcestershire | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 89116210001 | ||||||||
ROBERTS, Alfred, Dr | Geschäftsführer | 34 Biddenham Turn Biddenham MK40 4AZ Bedford Bedfordshire | British | Company Director | 17052270001 | |||||||||
SALTER, Michael John Lawrence | Geschäftsführer | Kingdom Glassel AB31 4BY Banchory Kincardineshire | Scotland | British | Company Director | 514740002 | ||||||||
SCAGELL, Jason | Geschäftsführer | 3 Hirdemonsway Dickens Heath B90 1SE Solihull West Midlands | British | General Manager | 93931810001 | |||||||||
SHAW, Daniel Steven | Geschäftsführer | Westwood Way Westwood Business Park CV4 8LG Coventry | England | British | Head Of Origination & Development | 118094220001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwe Renewables Uk Limited | 06. Apr. 2016 | Whitehill Way SN5 6PB Swindon Windmill Hill Business Park Wiltshire England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat RWE RENEWABLES UK OPERATIONS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A standard security which was presented for registration in scotland on 20 november 2001 and | Erstellt am 14. Nov. 2001 Geliefert am 30. Nov. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the facility agreement | |
Kurze Angaben Windfarm site at bowbeat by innerleithen title numbers mid 13215 amnd pbl 1382. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 4 june 2001 and | Erstellt am 30. Mai 2001 Geliefert am 22. Juni 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement (as defined therein) | |
Kurze Angaben The property k/a 165 square metres or thereby lying to the west south west of the public road running from carradale to tarbert t/n arg 1594. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on 20TH april 2001 and | Erstellt am 30. Apr. 2001 Geliefert am 08. Mai 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility agreement | |
Kurze Angaben Three discontiguous areas of land at deucheran hill, kintyre, registered in the land register under title number ARG1523 and two strips of land at carradale forest, kintyre, registered under title number ARG1524. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 03. Sept. 1999 Geliefert am 06. Sept. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility agreement dated 4TH june 1999 | |
Kurze Angaben Land and premises at bessy bell newtownstewart omagh county tyrone barons court and in the townlands of cashty aghafad and ballyrenan with all buildings and structures erected thereon the benefit of all agreements and the right to receive the full benefit of all monies owing to the company by way of rent or licence fees the goodwill of any business see form 395 for full details. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 04. Juni 1999 Geliefert am 16. Juni 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the finance parties (as defined) under any finance document (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed charge over all freehold and leasehold property wheresoever situate each of the site leases (other than the excluded site leases) all buildings fixtures (including trade fixtures but excluding tenants trade fixtures) fixed plant and machinery,rights of easements and privelages appurtenant to the property all stocks shares bonds and securities of any kind whatsoever all book and other debts and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0