WOODLINE FILMS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | WOODLINE FILMS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02693721 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von WOODLINE FILMS LIMITED?
- Filmproduktionsaktivitäten (59111) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich WOODLINE FILMS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Suite 18 Ealing House 33 Hanger Lane W5 3HJ London England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von WOODLINE FILMS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
AURORA ENTERTAINMENT LIMITED | 04. März 1992 | 04. März 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WOODLINE FILMS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für WOODLINE FILMS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 2 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 1 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2022 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2021 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Nicola Glinwood as a person with significant control on 01. Sept. 2020 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Cessation of Hendrina Glinwood as a person with significant control on 01. Sept. 2020 | 1 Seiten | PSC07 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2020 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2019 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2018 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 22. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 19a Connaught Road London N4 4NT England zum Suite 18 Ealing House 33 Hanger Lane London W5 3HJ am 29. März 2017 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von WOODLINE FILMS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMMERMANS, Franciscus Johannes Maria | Sekretär | Ealing House 33 Hanger Lane W5 3HJ London Suite 18 England | 175645320001 | |||||||
BATCHELER, Caroline Anne | Geschäftsführer | Grinzing Linersh Wood Close Bramley GU5 0EQ Guildford Surrey | England | British | Midwife | 58918310002 | ||||
GLINWOOD, Nicola Marijke | Geschäftsführer | Wanderdown Road Ovingdean BN2 7BT Brighton 38 England | England | British | Valuer | 146501010001 | ||||
GLINWOOD, Nicola Marijke | Sekretär | Wanderdown Road Ovingdean BN2 7BT Brighton 38 Sussex | British | 88315350007 | ||||||
LIU, Edwin S K | Sekretär | 103 Rosebery Road N10 2LD London | British | 30620550001 | ||||||
SWINDELL, Norman Geoffrey | Sekretär | Beeches St Marys Trinity Hill EX13 5SL Axminster Devon | British | Company Secretary | 36540550004 | |||||
WRIGHT, Dominic Michael | Sekretär | 316 Ladbroke Grove W10 5NQ London | British | Film Producer | 51281440002 | |||||
RWL REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Regis House 134 Percival Road EN1 1QU Enfield Middlesex | 900007870001 | |||||||
FAULKNER, James Sebastian | Geschäftsführer | Cranbrook 8 Nutley Terrace NW3 5SY London | British | Actor/Producer | 37234670001 | |||||
GLINWOOD, Derek Peter | Geschäftsführer | 2 Clerics Walk TW17 8JQ Shepperton Middlesex | British | Technical Service Specialist | 31100520001 | |||||
GLINWOOD, Hendrina Antonia | Geschäftsführer | 5 Riverside Drive Bramley GU5 0DT Guildford Surrey | England | Dutch | Script Writer | 35265520005 | ||||
GLINWOOD, Terence Anthony | Geschäftsführer | 5 Riverside Drive Bramley GU5 0DT Guildford Surrey | England | British | Film Executive | 23750470005 | ||||
GLINWOOD MALIK, Nicola | Geschäftsführer | West Normanhurst The Common GU6 8NS Cranleigh Surrey | British | Company Director | 88315350001 | |||||
POOLMAN, Gavin Willem Maxted | Geschäftsführer | 21 Chesilton Road SW6 5AA London | Dutch | Film Producer | 114374540001 | |||||
TIMMERMANS, Franciscus Johannes Maria | Geschäftsführer | 10 Dingwall Gardens Golders Green NW11 7ET London | Dutch | Film Executive | 17869770001 | |||||
WRIGHT, Dominic Michael | Geschäftsführer | 316 Ladbroke Grove W10 5NQ London | British | Film Producer | 51281440002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei WOODLINE FILMS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Ms Nicola Marijke Glinwood | 01. Sept. 2020 | Ealing House 33 Hanger Lane W5 3HJ London Suite 18 England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Mrs Hendrina Glinwood | 06. Apr. 2016 | Ealing House 33 Hanger Lane W5 3HJ London Suite 18 England | Ja |
Nationalität: Dutch Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat WOODLINE FILMS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge and deed of assignment | Erstellt am 09. Jan. 1995 Geliefert am 27. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter of 29 december 1994 | |
Kurze Angaben All the right, title and interest in the film and any other film and all copies of the film and all other rights and properties of the producer.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
An agreement | Erstellt am 05. Jan. 1995 Geliefert am 17. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "financing agreements" (as defined in the agreement) and a guarantee of completion | |
Kurze Angaben All the rights title and interest of the company of and in the film provisionally entitled "the pillow book" and in the script and all other written and musical matter embodied or used in the film or acquired in connection with its production and the negative and prints thereof and all rights of representing exploiting and exhibiting the same. All the interest and rights of the company of and in the agreements with the financiers of the film. All property acquired for the production of the film and all agreements made for its production. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and deed of assignment | Erstellt am 03. Juni 1993 Geliefert am 08. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 03/06/93 | |
Kurze Angaben All the producers right title and interest in the film and any other film all copies of the filmall other rights and properties of the producer. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 16. Apr. 1993 Geliefert am 17. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £400,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the film entitled "prince of jutland" please see rider to form 395 M126C for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Agreement and charge | Erstellt am 15. Apr. 1993 Geliefert am 27. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the completion guaranty (as defined) and this charge | |
Kurze Angaben The "photoplay" (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0