HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHIGHWAY (BURNLEY) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02693859
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    • (8514) /

    Wo befindet sich HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Craegmoor House
    Perdiswell Park
    WR3 7NW Worcestershire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BRIAN CHRISTOPHER PROPERTY LIMITED16. Apr. 199216. Apr. 1992
    BANDNAME LIMITED05. März 199205. März 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von David Manson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David James Hall als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Ernennung von Mr Philip Henry Scott als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Jason David Lock als Direktor

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Mr Matthew Franzidis als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Scott Morrison als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Albert Smith als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christine Cameron als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Julian Ball als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. März 2011

    Kapitalaufstellung am 30. März 2011

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    16 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353a

    legacy

    1 Seiten190a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HALL, David James
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Sekretär
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    159660530001
    FRANZIDIS, Matthew
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandUk129251300001
    LOCK, Jason David
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish144822040001
    SCOTT, Philip Henry
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Randalls Way
    KT22 7TP Leatherhead
    Priory House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish174231320001
    CHRISTOPHER, Brian John
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Sekretär
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037120001
    CHRISTOPHER, Richard Robert Edward
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    Sekretär
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    British54424700002
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    Sekretär
    7th Floor Beaufort House
    15 St Botolph Street
    EC3A 7NJ London
    39680630001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ANDREWS, Carole
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    155 Watermoor Road
    GL7 1LF Cirencester
    Gloucestershire
    British102238960001
    BALL, Julian Charles
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Mill Fleam
    Hilton
    DE65 5HE Derby
    14
    Derbyshire
    EnglandBritish138044110001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Orchard Manor
    Church Lane Martin Hussingtree
    WR3 8TQ Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish113187140001
    CAMERON, Christine Isabel
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    Geschäftsführer
    10 Mount Crescent
    HR1 NQ1 Hereford
    EnglandBritish163745150001
    CAVANAGH, Peter Kenneth
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    Geschäftsführer
    8 Fir Grove
    Paddington
    WA1 3JF Warrington
    British114627410002
    CHRISTOPHER, Barbara Ruth
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037140001
    CHRISTOPHER, Brian John
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    11 Acres Brook Road
    Higham
    BB12 9BY Burnley
    Lancashire
    British18037120001
    CHRISTOPHER, Richard Robert Edward
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    9 Millcombe Way
    Walton Le Dale
    PR5 4NB Preston
    Lancashire
    British54424700002
    HILL, Margaret
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    11 Pear Tree Close
    Hollingsworth
    S43 2LU Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritish102587360001
    KAY, Allyson
    12 Folks Wood Way
    Stone Street Lympne
    CT21 4EW Hythe
    Kent
    Geschäftsführer
    12 Folks Wood Way
    Stone Street Lympne
    CT21 4EW Hythe
    Kent
    British93464240001
    KEATING, Denise Elizabeth
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    62 Church Street
    Cogenhoe
    NN7 1LS Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish111513540001
    MANSON, David Lindsay
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    111 Lodge Road
    Knowle
    B93 0HG Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish126071210001
    NEWHAM, Pamela Maria
    Rowan Cottage
    38 Reedley Road Reedley
    BB10 2LU Burnley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Rowan Cottage
    38 Reedley Road Reedley
    BB10 2LU Burnley
    Lancashire
    British69690300002
    SAVILLE, Richard Cyril Campbell
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Fairings
    Valley Way
    SL9 7PL Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish38530070001
    SMITH, Albert Edward
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    Flint House
    Froxfield
    SN8 3JY Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish77631340001
    SPURLING, Julian Neville Guy
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Foundry House
    GU35 9LY Kingsley
    Hampshire
    EnglandBritish110225070001
    STRATFORD, Michael Anthony
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    Geschäftsführer
    10 Anne Hathaway Drive
    GL3 2PX Churchdown
    Gloucestershire
    United KingdomBritish38853720002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of accession and charge acceeding to the debenture dated 18 july 2008 and
    Erstellt am 02. Okt. 2008
    Geliefert am 08. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The acquisition agreement claims all rights in respect of the insurance policies, the hedging agreements, any structural intra group loans fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 08. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Feb. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 17. Sept. 2007
    Geliefert am 26. Sept. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 26. Sept. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal mortgage
    Erstellt am 11. März 2006
    Geliefert am 21. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental legal mortgage
    Erstellt am 11. März 2006
    Geliefert am 21. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property being 3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Lenders)
    Transaktionen
    • 21. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 11. März 2006
    Geliefert am 21. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (Security Agent)
    Transaktionen
    • 21. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite debenture
    Erstellt am 31. Dez. 2004
    Geliefert am 06. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Sept. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Okt. 2003
    Geliefert am 06. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Feb. 1999
    Geliefert am 05. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Nov. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. März 1993
    Geliefert am 13. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 30 talbot street burnley inc: fixtuer and fittings title no: LA485170. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Nov. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0