HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02693859 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?
- (8514) /
Wo befindet sich HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Craegmoor House Perdiswell Park WR3 7NW Worcestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BRIAN CHRISTOPHER PROPERTY LIMITED | 16. Apr. 1992 | 16. Apr. 1992 |
| BANDNAME LIMITED | 05. März 1992 | 05. März 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Manson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David James Hall als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Ernennung von Mr Philip Henry Scott als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jason David Lock als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Matthew Franzidis als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Scott Morrison als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Albert Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christine Cameron als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Julian Ball als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALL, David James | Sekretär | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | 159660530001 | |||||||
| FRANZIDIS, Matthew | Geschäftsführer | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | England | Uk | 129251300001 | |||||
| LOCK, Jason David | Geschäftsführer | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | England | British | 144822040001 | |||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | Randalls Way KT22 7TP Leatherhead Priory House Surrey United Kingdom | England | British | 174231320001 | |||||
| CHRISTOPHER, Brian John | Sekretär | 11 Acres Brook Road Higham BB12 9BY Burnley Lancashire | British | 18037120001 | ||||||
| CHRISTOPHER, Richard Robert Edward | Sekretär | 9 Millcombe Way Walton Le Dale PR5 4NB Preston Lancashire | British | 54424700002 | ||||||
| MORRISON, Scott | Sekretär | 24 Gaveston Road CV32 6EU Leamington Spa Warwickshire | British | 99297890001 | ||||||
| BLG (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED | Sekretär | 7th Floor Beaufort House 15 St Botolph Street EC3A 7NJ London | 39680630001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ANDREWS, Carole | Geschäftsführer | 155 Watermoor Road GL7 1LF Cirencester Gloucestershire | British | 102238960001 | ||||||
| BALL, Julian Charles | Geschäftsführer | Mill Fleam Hilton DE65 5HE Derby 14 Derbyshire | England | British | 138044110001 | |||||
| CAMERON, Charles Donald Ewen | Geschäftsführer | Orchard Manor Church Lane Martin Hussingtree WR3 8TQ Worcester Worcestershire | England | British | 113187140001 | |||||
| CAMERON, Christine Isabel | Geschäftsführer | 10 Mount Crescent HR1 NQ1 Hereford | England | British | 163745150001 | |||||
| CAVANAGH, Peter Kenneth | Geschäftsführer | 8 Fir Grove Paddington WA1 3JF Warrington | British | 114627410002 | ||||||
| CHRISTOPHER, Barbara Ruth | Geschäftsführer | 11 Acres Brook Road Higham BB12 9BY Burnley Lancashire | British | 18037140001 | ||||||
| CHRISTOPHER, Brian John | Geschäftsführer | 11 Acres Brook Road Higham BB12 9BY Burnley Lancashire | British | 18037120001 | ||||||
| CHRISTOPHER, Richard Robert Edward | Geschäftsführer | 9 Millcombe Way Walton Le Dale PR5 4NB Preston Lancashire | British | 54424700002 | ||||||
| HILL, Margaret | Geschäftsführer | 11 Pear Tree Close Hollingsworth S43 2LU Chesterfield Derbyshire | England | British | 102587360001 | |||||
| KAY, Allyson | Geschäftsführer | 12 Folks Wood Way Stone Street Lympne CT21 4EW Hythe Kent | British | 93464240001 | ||||||
| KEATING, Denise Elizabeth | Geschäftsführer | 62 Church Street Cogenhoe NN7 1LS Northampton Northamptonshire | England | British | 111513540001 | |||||
| MANSON, David Lindsay | Geschäftsführer | 111 Lodge Road Knowle B93 0HG Solihull West Midlands | England | British | 126071210001 | |||||
| NEWHAM, Pamela Maria | Geschäftsführer | Rowan Cottage 38 Reedley Road Reedley BB10 2LU Burnley Lancashire | British | 69690300002 | ||||||
| SAVILLE, Richard Cyril Campbell | Geschäftsführer | Fairings Valley Way SL9 7PL Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 38530070001 | |||||
| SMITH, Albert Edward | Geschäftsführer | Flint House Froxfield SN8 3JY Marlborough Wiltshire | England | British | 77631340001 | |||||
| SPURLING, Julian Neville Guy | Geschäftsführer | Foundry House GU35 9LY Kingsley Hampshire | England | British | 110225070001 | |||||
| STRATFORD, Michael Anthony | Geschäftsführer | 10 Anne Hathaway Drive GL3 2PX Churchdown Gloucestershire | United Kingdom | British | 38853720002 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Hat HIGHWAY (BURNLEY) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession and charge acceeding to the debenture dated 18 july 2008 and | Erstellt am 02. Okt. 2008 Geliefert am 08. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The acquisition agreement claims all rights in respect of the insurance policies, the hedging agreements, any structural intra group loans fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Sept. 2007 Geliefert am 26. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal mortgage | Erstellt am 11. März 2006 Geliefert am 21. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben 3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal mortgage | Erstellt am 11. März 2006 Geliefert am 21. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property being 3 talbot street burnley t/n LA486809,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 11. März 2006 Geliefert am 21. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite debenture | Erstellt am 31. Dez. 2004 Geliefert am 06. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Okt. 2003 Geliefert am 06. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Okt. 2003 Geliefert am 06. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Okt. 2003 Geliefert am 06. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from craegmoor homes limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 26. Feb. 1999 Geliefert am 05. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. März 1993 Geliefert am 13. März 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 30 talbot street burnley inc: fixtuer and fittings title no: LA485170. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0