VECTOR INVESTMENTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VECTOR INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02693876 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VECTOR INVESTMENTS LIMITED?
- Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich VECTOR INVESTMENTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O INTERPATH LTD 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von VECTOR INVESTMENTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BEFOREKEEP LIMITED | 05. März 1992 | 05. März 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VECTOR INVESTMENTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VECTOR INVESTMENTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 17 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2023 | 17 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2022 | 18 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 104 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fleet Place London EC4M 7QS zum 10 Fleet Place London EC4M 7RB am 01. Juli 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 16 Palace Street London England SW1E 5JQ zum 10 Fleet Place London EC4M 7QS am 04. Jan. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 8 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Khwaja Kamran Shah als Direktor am 09. Apr. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rashidi Olugbenga Keshiro als Geschäftsführer am 09. Apr. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 19. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Guat Hoon (Known as Christina) Ong als Geschäftsführer am 06. Okt. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VECTOR INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUHAMMAD, Junaid Muhammad Rahimullah | Geschäftsführer | Level 15, Sheikh Zayed Road P.O. BOX 17000 Dubai Conrad Building United Arab Emirates | United Arab Emirates | Pakistani | 214227180001 | |||||
| SHAH, Khwaja Kamran | Geschäftsführer | 0000 Discovery Gardens Apt 204 Building 107 United Arab Emirates | United Arab Emirates | Pakistani | 245280080001 | |||||
| COOMBE, Cynthia Mary | Sekretär | Palace Street SW1E 5JQ London 16 England England | 155194520001 | |||||||
| HOWARD, Albert Larry | Sekretär | Highlands 15 Vernon Road SS9 2NG Leigh On Sea Essex | British | 73770040001 | ||||||
| HUDSON, Alan Edmund Wilchen | Sekretär | 79 Porchfield Square St John's Gardens M3 4FG Manchester | British | 38798810002 | ||||||
| JONES, Roger Kenneth | Sekretär | 41 Townscliffe Lane Marple Bridge SK6 5AP Stockport Cheshire | British | 11127840001 | ||||||
| MCCAUSLAND, Siobhan Mary | Sekretär | 64 Shawdene Road M22 4AL Manchester Lancashire | British | 2583820001 | ||||||
| MOORE, Michael Anthony | Sekretär | 17 Pine Road Didsbury M20 6UY Manchester Lancashire | British | 4609510001 | ||||||
| PARKINSON, Evelyn | Sekretär | 53 Tyrer Road WA12 8SP Newton Le Willows Merseyside | British | 9842960001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALUISI, Patricia Ann | Geschäftsführer | 76 Cadogan Place SW1X 9RP London | American | 23362430001 | ||||||
| BARNETT, Ian Gregory Howie | Geschäftsführer | Palace Street SW1E 5JQ London 16 England England | United Kingdom | British | 11591280001 | |||||
| BATE, Dennis | Geschäftsführer | 109 Carmill Road Billinge WN5 7TY Wigan Lancashire | British | 28569910001 | ||||||
| BEVERTON, John Davey | Geschäftsführer | 29 Eaton Square SW1 9DF London | British | 7646360002 | ||||||
| BROOKS, Gary | Geschäftsführer | Palace Street SW1E 5JQ London 16 England England | United Kingdom | British | 108919970001 | |||||
| CHARLTON, Richard Wingate Edward | Geschäftsführer | 8 Fernshaw Road SW10 0TF London | United Kingdom | British | 15470710001 | |||||
| CORSER, Raymond Bidlake | Geschäftsführer | Robinswood 1 Dashwood Close West Byfleet KT14 6QH Wey Bridge Surrey | British | 55914130002 | ||||||
| FLETCHER, Angus Howard | Geschäftsführer | Lees Heights OX7 3EZ Charlbury 9 United Kingdom | United Kingdom | British | 65254010001 | |||||
| HOWARD, Albert Larry | Geschäftsführer | Highlands 15 Vernon Road SS9 2NG Leigh On Sea Essex | England | British | 73770040001 | |||||
| JOHNSON, David Arthur | Geschäftsführer | 133 Newtown Road BH31 6EH Verwood Dorset | British | 10394350002 | ||||||
| KESHIRO, Rashidi Olugbenga | Geschäftsführer | Palace Street SW1E 5JQ London 16 England | United Kingdom | British | 120935530001 | |||||
| LEESE, Richard Charles, Sir | Geschäftsführer | 19 Westbury Road Crumpsall M8 5RX Manchester | United Kingdom | British | 53459790002 | |||||
| LEESE, Richard Charles, Sir | Geschäftsführer | 19 Westbury Road Crumpsall M8 5RX Manchester | United Kingdom | British | 53459790002 | |||||
| MACKIE, Colin Dwight | Geschäftsführer | Highcourt 11 Tadcaster Road YO23 3UL Copmanthorpe North Yorkshire | United Kingdom | British | 78640920001 | |||||
| MOORE, Michael Anthony | Geschäftsführer | 17 Pine Road Didsbury M20 6UY Manchester Lancashire | British | 4609510001 | ||||||
| ONG, Guat Hoon (Known As Christina) | Geschäftsführer | The Galleries Building 4, Level 6 Downtown Jebel Ali, PO BOX 17000 Dubai Istithmar World Pjsc United Arab Emirates | United Arab Emirates | Singaporean | 197371130001 | |||||
| REAMES, Rodney Charles Dudley | Geschäftsführer | 83 Tiddington Road CV37 7AF Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | 33215200001 | ||||||
| THOMAS OF MACCLESFIELD, Terence James, Lord | Geschäftsführer | 51 Willowmead Drive SK10 4DD Prestbury Cheshire | British | 85130800001 | ||||||
| TRIPPIER, David Austin, Sir | Geschäftsführer | Dowry Head Helmshore BB4 4AE Rossendale Lancashire | British | 27871400001 | ||||||
| TURNER, Norman Patrick | Geschäftsführer | Hillside Macclesfield Road SK9 7BW Alderley Edge Cheshire | British | 9842980001 | ||||||
| WADDINGTON, Robert | Geschäftsführer | 83 Bourne Street SW1W 8HQ London | British | 72682390002 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VECTOR INVESTMENTS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istithmar P&O Estates (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | Palace Street SW1E 5JQ London 16 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat VECTOR INVESTMENTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Third security assignment | Erstellt am 30. Mai 2003 Geliefert am 05. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in to and arising under the relevant agreements and the relevant insurances and any moneys payable or to the account of the assignor thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 02. Okt. 2000 Geliefert am 05. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the amended lease agreements or any of the other financing documents (as defined) | |
Kurze Angaben All the company's right title benefit and interest in and to the assigned rights where the assigned rights are all the right title benefit and interest of the chargor in to or arising out of or in connection with clause 5 of the release and guarantee agreement dated 2ND october 2000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 26. Sept. 1997 Geliefert am 01. Okt. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the lessors, under or pursuant to any of the lease agreements or any of the other financing documents (as defined in the deed) | |
Kurze Angaben All of the assignor's right title benefit and interest to and in the assigned rights and all the benefits of all policies, contracts and agreements in respect of the relevant insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security assignment | Erstellt am 29. Dez. 1995 Geliefert am 10. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the lease agreements or any of the other financing documents | |
Kurze Angaben All of the assignor's right title benefit and interst to and in the assigned rights, the charged account, the deposit and all the benefits of all policies, contracts and agreements in respect of the relevant insurances. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Dez. 1995 Geliefert am 10. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any lease agreements or any of the other financing documents | |
Kurze Angaben L/H-the international olympic arena, manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security account charge | Erstellt am 29. Dez. 1995 Geliefert am 09. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any of the lease agreements or any of the other financing documents | |
Kurze Angaben All of the company's right title benefit and interest to and in the deposit of £2,000,000 deposited in the account numbered 70329986 in the company's name held with co-op bank at its branch at po box 101, 1 balloon street, manchester M60 4EP sort code 08-90-00. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of building contract | Erstellt am 05. Nov. 1993 Geliefert am 25. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC and agent and trustee for itself, bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever under the terms of the assignment (as defined therein) | |
Kurze Angaben A building contract d/d 24/08/93 to construct an indoor sports arena adjacent to victoria railways station manchester. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 05. Nov. 1993 Geliefert am 25. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC as agent and trustee for itself,bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them under the terms of the assignment (as defined therein) | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company under a building agreement and underlease d/d 04/12/92 an agreement d/d 14/04/93 and an agreement d/d 27/05/93. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Nov. 1993 Geliefert am 25. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC as agent and trustee for itself and bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever under the terms of the debenture (as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Feb. 1993 Geliefert am 19. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Feb. 1993 Geliefert am 15. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Jan. 1993 Geliefert am 11. Feb. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Nov. 1992 Geliefert am 27. Nov. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings at roger street/brighton street cheetham hill manchester t/no's la 34630 la 52063 la 115564 & la 52062 with buildings & fixtures and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat VECTOR INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0