VECTOR INVESTMENTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVECTOR INVESTMENTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02693876
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    • Vermietung und Verpachtung von Immobilien von Wohnungsbaugesellschaften (68201) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O INTERPATH LTD
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BEFOREKEEP LIMITED05. März 199205. März 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2020

    Welche sind die letzten Einreichungen für VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    17 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2023

    17 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 12. Dez. 2022

    18 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    104 SeitenLIQ10

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fleet Place London EC4M 7QS zum 10 Fleet Place London EC4M 7RB am 01. Juli 2022

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 16 Palace Street London England SW1E 5JQ zum 10 Fleet Place London EC4M 7QS am 04. Jan. 2022

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 13. Dez. 2021

    LRESSP

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2021 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Erfüllung der Belastung 8 vollständig

    1 SeitenMR04

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020

    9 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019

    9 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    19 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 26. Sept. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    18 SeitenAA

    Ernennung von Khwaja Kamran Shah als Direktor am 09. Apr. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Rashidi Olugbenga Keshiro als Geschäftsführer am 09. Apr. 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 19. Sept. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    22 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Guat Hoon (Known as Christina) Ong als Geschäftsführer am 06. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MUHAMMAD, Junaid Muhammad Rahimullah
    Level 15,
    Sheikh Zayed Road
    P.O. BOX 17000 Dubai
    Conrad Building
    United Arab Emirates
    Geschäftsführer
    Level 15,
    Sheikh Zayed Road
    P.O. BOX 17000 Dubai
    Conrad Building
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesPakistani214227180001
    SHAH, Khwaja Kamran
    0000 Discovery Gardens
    Apt 204 Building 107
    United Arab Emirates
    Geschäftsführer
    0000 Discovery Gardens
    Apt 204 Building 107
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesPakistani245280080001
    COOMBE, Cynthia Mary
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Sekretär
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    155194520001
    HOWARD, Albert Larry
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    Sekretär
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    British73770040001
    HUDSON, Alan Edmund Wilchen
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    Sekretär
    79 Porchfield Square
    St John's Gardens
    M3 4FG Manchester
    British38798810002
    JONES, Roger Kenneth
    41 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    41 Townscliffe Lane
    Marple Bridge
    SK6 5AP Stockport
    Cheshire
    British11127840001
    MCCAUSLAND, Siobhan Mary
    64 Shawdene Road
    M22 4AL Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    64 Shawdene Road
    M22 4AL Manchester
    Lancashire
    British2583820001
    MOORE, Michael Anthony
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    Sekretär
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    British4609510001
    PARKINSON, Evelyn
    53 Tyrer Road
    WA12 8SP Newton Le Willows
    Merseyside
    Sekretär
    53 Tyrer Road
    WA12 8SP Newton Le Willows
    Merseyside
    British9842960001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALUISI, Patricia Ann
    76 Cadogan Place
    SW1X 9RP London
    Geschäftsführer
    76 Cadogan Place
    SW1X 9RP London
    American23362430001
    BARNETT, Ian Gregory Howie
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Geschäftsführer
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    United KingdomBritish11591280001
    BATE, Dennis
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    109 Carmill Road
    Billinge
    WN5 7TY Wigan
    Lancashire
    British28569910001
    BEVERTON, John Davey
    29 Eaton Square
    SW1 9DF London
    Geschäftsführer
    29 Eaton Square
    SW1 9DF London
    British7646360002
    BROOKS, Gary
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    Geschäftsführer
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    England
    United KingdomBritish108919970001
    CHARLTON, Richard Wingate Edward
    8 Fernshaw Road
    SW10 0TF London
    Geschäftsführer
    8 Fernshaw Road
    SW10 0TF London
    United KingdomBritish15470710001
    CORSER, Raymond Bidlake
    Robinswood 1 Dashwood Close
    West Byfleet
    KT14 6QH Wey Bridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Robinswood 1 Dashwood Close
    West Byfleet
    KT14 6QH Wey Bridge
    Surrey
    British55914130002
    FLETCHER, Angus Howard
    Lees Heights
    OX7 3EZ Charlbury
    9
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lees Heights
    OX7 3EZ Charlbury
    9
    United Kingdom
    United KingdomBritish65254010001
    HOWARD, Albert Larry
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    Highlands
    15 Vernon Road
    SS9 2NG Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish73770040001
    JOHNSON, David Arthur
    133 Newtown Road
    BH31 6EH Verwood
    Dorset
    Geschäftsführer
    133 Newtown Road
    BH31 6EH Verwood
    Dorset
    British10394350002
    KESHIRO, Rashidi Olugbenga
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    Geschäftsführer
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    England
    United KingdomBritish120935530001
    LEESE, Richard Charles, Sir
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    Geschäftsführer
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    United KingdomBritish53459790002
    LEESE, Richard Charles, Sir
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    Geschäftsführer
    19 Westbury Road
    Crumpsall
    M8 5RX Manchester
    United KingdomBritish53459790002
    MACKIE, Colin Dwight
    Highcourt
    11 Tadcaster Road
    YO23 3UL Copmanthorpe
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Highcourt
    11 Tadcaster Road
    YO23 3UL Copmanthorpe
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78640920001
    MOORE, Michael Anthony
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    17 Pine Road
    Didsbury
    M20 6UY Manchester
    Lancashire
    British4609510001
    ONG, Guat Hoon (Known As Christina)
    The Galleries Building 4, Level 6
    Downtown Jebel Ali, PO BOX 17000
    Dubai
    Istithmar World Pjsc
    United Arab Emirates
    Geschäftsführer
    The Galleries Building 4, Level 6
    Downtown Jebel Ali, PO BOX 17000
    Dubai
    Istithmar World Pjsc
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesSingaporean197371130001
    REAMES, Rodney Charles Dudley
    83 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    83 Tiddington Road
    CV37 7AF Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British33215200001
    THOMAS OF MACCLESFIELD, Terence James, Lord
    51 Willowmead Drive
    SK10 4DD Prestbury
    Cheshire
    Geschäftsführer
    51 Willowmead Drive
    SK10 4DD Prestbury
    Cheshire
    British85130800001
    TRIPPIER, David Austin, Sir
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dowry Head
    Helmshore
    BB4 4AE Rossendale
    Lancashire
    British27871400001
    TURNER, Norman Patrick
    Hillside Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Hillside Macclesfield Road
    SK9 7BW Alderley Edge
    Cheshire
    British9842980001
    WADDINGTON, Robert
    83 Bourne Street
    SW1W 8HQ London
    Geschäftsführer
    83 Bourne Street
    SW1W 8HQ London
    British72682390002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VECTOR INVESTMENTS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Palace Street
    SW1E 5JQ London
    16
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer6067171
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat VECTOR INVESTMENTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Third security assignment
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 05. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in to and arising under the relevant agreements and the relevant insurances and any moneys payable or to the account of the assignor thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank Corporate Finance PLC
    Transaktionen
    • 05. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security assignment
    Erstellt am 02. Okt. 2000
    Geliefert am 05. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the amended lease agreements or any of the other financing documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's right title benefit and interest in and to the assigned rights where the assigned rights are all the right title benefit and interest of the chargor in to or arising out of or in connection with clause 5 of the release and guarantee agreement dated 2ND october 2000. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank Corporate Finance PLC
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security assignment
    Erstellt am 26. Sept. 1997
    Geliefert am 01. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the lessors, under or pursuant to any of the lease agreements or any of the other financing documents (as defined in the deed)
    Kurze Angaben
    All of the assignor's right title benefit and interest to and in the assigned rights and all the benefits of all policies, contracts and agreements in respect of the relevant insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Bank Corporate Finance PLC
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security assignment
    Erstellt am 29. Dez. 1995
    Geliefert am 10. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the lease agreements or any of the other financing documents
    Kurze Angaben
    All of the assignor's right title benefit and interst to and in the assigned rights, the charged account, the deposit and all the benefits of all policies, contracts and agreements in respect of the relevant insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nws Corporate Finance PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Lessors
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 1995
    Geliefert am 10. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any lease agreements or any of the other financing documents
    Kurze Angaben
    L/H-the international olympic arena, manchester. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nws Corporate Finance PLC as Agent and Security Trustee for Itself and the Lessors
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Dez. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security account charge
    Erstellt am 29. Dez. 1995
    Geliefert am 09. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any of the lease agreements or any of the other financing documents
    Kurze Angaben
    All of the company's right title benefit and interest to and in the deposit of £2,000,000 deposited in the account numbered 70329986 in the company's name held with co-op bank at its branch at po box 101, 1 balloon street, manchester M60 4EP sort code 08-90-00.
    Berechtigte Personen
    • Nws Corporate Finance PLC(As Agent and Security Trustee for Itself and the Lessors)
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Sept. 2021Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment of building contract
    Erstellt am 05. Nov. 1993
    Geliefert am 25. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC and agent and trustee for itself, bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever under the terms of the assignment (as defined therein)
    Kurze Angaben
    A building contract d/d 24/08/93 to construct an indoor sports arena adjacent to victoria railways station manchester. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC ("the Agent")
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment
    Erstellt am 05. Nov. 1993
    Geliefert am 25. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC as agent and trustee for itself,bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them under the terms of the assignment (as defined therein)
    Kurze Angaben
    All right title and interest of the company under a building agreement and underlease d/d 04/12/92 an agreement d/d 14/04/93 and an agreement d/d 27/05/93. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC ("the Agent")
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 05. Nov. 1993
    Geliefert am 25. Nov. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the co-operative bank PLC as agent and trustee for itself and bovis construction limited and/or the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever under the terms of the debenture (as defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC ("the Agent")
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Feb. 1993
    Geliefert am 19. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bovis Construction Limited
    Transaktionen
    • 19. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. März 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Feb. 1993
    Geliefert am 15. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Jan. 1993
    Geliefert am 11. Feb. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Feb. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Feb. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Nov. 1992
    Geliefert am 27. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings at roger street/brighton street cheetham hill manchester t/no's la 34630 la 52063 la 115564 & la 52062 with buildings & fixtures and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat VECTOR INVESTMENTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    13. Dez. 2021Beginn der Liquidation
    25. Apr. 2024Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen John Absolom
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicholas James Timpson
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0