SANCTUARY RECORDS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | SANCTUARY RECORDS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02694276 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SANCTUARY RECORDS LIMITED?
- Künstlerische Tätigkeit (90030) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
- Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich SANCTUARY RECORDS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 33 Wigmore Street W1U 1QX London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SANCTUARY RECORDS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
SANCTUARY ASSOCIATED INVESTMENTS LIMITED | 05. März 1992 | 05. März 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SANCTUARY RECORDS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SANCTUARY RECORDS LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SANCTUARY RECORDS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Maximilian Dressendoerfer am 17. Okt. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark David Ranyard am 17. Okt. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 28. Aug. 2014
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS United Kingdom zum Simons Muirhead & Burton 8 9 Frith Street London W1D 3JB geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Simons Muirhead & Burton 8 9 Frith Street London W1D 3JB verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Davenport Lyons 30 Old Burlington Street London W1S 3NL am 10. Sept. 2013 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark David Ranyard als Direktor am 30. Apr. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Maximilian Dressendoerfer als Direktor am 30. Apr. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von John Leslie Dobinson als Direktor am 30. Apr. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Spencer Smith als Geschäftsführer am 30. Apr. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 364-366 Kensington High Street London W14 8NS England am 10. Mai 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Michael Constant als Geschäftsführer am 21. Nov. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Brown als Geschäftsführer am 21. Nov. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Abolanle Abioye als Sekretär am 21. Nov. 2012 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Timothy Spencer Smith als Direktor am 21. Nov. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SANCTUARY RECORDS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOBINSON, John Leslie | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | United Kingdom | British | Chief Operating Officer - Europe | 34942720003 | ||||
DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | Germany | German | Company Director | 157717080010 | ||||
RANYARD, Mark David | Geschäftsführer | Wigmore Street W1U 1QX London 33 England | England | British | Finance Director | 154884950002 | ||||
ABIOYE, Abolanle | Sekretär | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | British | Secretary | 88802330001 | |||||
JOY, Matthew Robert | Sekretär | 2 Chestnut Place KT21 2DY Ashtead Surrey | British | 115905420001 | ||||||
MILLER, Michael David | Sekretär | 76 Marsworth Avenue HA5 4TT Pinner Middlesex | British | 44250870001 | ||||||
STANDING, Sarah Elizabeth Anne | Sekretär | 1 Pilsdon Close Inner Park Road Wimbledon SW19 6DR London | British | 41378870002 | ||||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
BROWN, Andrew | Geschäftsführer | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | England | British | International Chief Financial Officer | 163199590001 | ||||
BURTON, Paul Anthony | Geschäftsführer | 65 Hartford Road DA5 1NL Bexley Kent | England | British | Chartered Accountant | 34303730002 | ||||
COKELL, Joseph | Geschäftsführer | Talltrees Orpington Road BR7 6RA Chislehurst Kent | Gb-Eng | British | Company Director | 76396440001 | ||||
CONSTANT, Richard Michael | Geschäftsführer | Kensington High Street W14 8NS London 364-366 United Kingdom | United Kingdom | British | General Counsel | 43836310003 | ||||
COURTNEY, Rohan Richard | Geschäftsführer | Deepwood Lower Wood Road SY8 2JQ Ludlow Shropshire | British | Company Director | 9512790002 | |||||
DAVIES, David Michael | Geschäftsführer | 13 Marine Parade CF64 3BG Penarth South Glamorgan | United Kingdom | British | Director | 3792920003 | ||||
DAVIES, Hywel Hadley | Geschäftsführer | 2b Florence Road W5 3TX London | British | Managing Director | 13515170001 | |||||
DRISCOLL, James Christopher | Geschäftsführer | 66 Norton Road DY8 2AQ Stourbridge West Midlands | British | Company Director | 98716480001 | |||||
DRISCOLL, James Christopher | Geschäftsführer | 66 Norton Road DY8 2AQ Stourbridge West Midlands | British | Director | 98716480001 | |||||
HAXBY, Martin James, Mr. | Geschäftsführer | Wildhern 133 Silverdale Avenue Ashley Park KT12 1EJ Walton On Thames Surrey | United Kingdom | British | Business Affairs Director | 6001160002 | ||||
MILLER, Michael David | Geschäftsführer | High Trees 15a Linksway HA6 2XA Northwood Middlesex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 44250870002 | ||||
MUIR, Boyd Johnston | Geschäftsführer | Colorado Avenue CA 90404 Santa Monica 2220 Usa | United States | British | Evp & Chief Financial Officer | 172824510001 | ||||
NAJEEB, Aky | Geschäftsführer | The Old School House Bovington Green SL7 2JH Marlow Buckinghamshire | British | Company Director | 10689380007 | |||||
SMALLWOOD, Roderick Charles | Geschäftsführer | 42 Hartingdon Road Chiswick W4 London | British | Manager | 43907530001 | |||||
SMITH, Timothy Spencer | Geschäftsführer | Avonmore Road Kensington Village W14 8TS London Beaumont House United Kingdom | England | British | Solicitor | 130003340001 | ||||
TAYLOR, Andrew John | Geschäftsführer | The Bridge House Bisham Road SL7 1RP Marlow Buckinghamshire | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 54448520001 | ||||
WALLACE, Paul Frederick | Geschäftsführer | Westfield House Nunnery Lane TN11 8HA Penshurst Kent | England | British | Chartered Accountant | 76655520001 | ||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Hat SANCTUARY RECORDS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 14. Juni 2002 Geliefert am 27. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 (the "deed") | Erstellt am 11. Aug. 2000 Geliefert am 30. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred to the chargee under the mezzanine documents by any charging company (as defined) | |
Kurze Angaben L/H property k/a 45-53 sinclair road, hammersmith, london t/no BGL14049 together with all buildings, fixtures and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 | Erstellt am 01. Juli 1999 Geliefert am 09. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the mezzanine documents (as defined) | |
Kurze Angaben All its f/h and l/h interest in the properties being the l/h property k/a 45-53 sinclair road,hammersmith,london t/no BGL14049 together with all buildings,fixtures (excluding in the case of l/h property landlord's fixtures but including other trade fixtures and excluding in the case of f/h property and l/h property which is let or sub-let to a third party,tenant's and trade fixtures and fittings of such third party) and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 29. Okt. 1998 Geliefert am 17. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Okt. 1998 Geliefert am 06. Nov. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of amendment to a composite guarantee and debenture originally dated 3RD september 1997 | Erstellt am 03. Juli 1998 Geliefert am 21. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from sanctuary enterprises PLC (borrower) to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 3 september 1997 | Erstellt am 20. Mai 1998 Geliefert am 06. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies which are as at 20 may 1998 due or to become due from sanctuary enterprises PLC (the "borrower") to the chargee under the mezzanine loan agreement dated 3 september 1997 whether pursuant to the guarantee as therein defined) or otherwise and all other sums payable pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee & debenture | Erstellt am 03. Sept. 1997 Geliefert am 19. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag That part of the mezzanine loan facility drawndown by the the sanctuary group PLC to the company or to nomis studios limited and/or to companies in which either of the company or nomis holds an equity interest | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 26. Aug. 1997 Geliefert am 16. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 24. März 1997 Geliefert am 26. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 28. Sept. 1994 Geliefert am 01. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0