SANCTUARY RECORDS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSANCTUARY RECORDS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02694276
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SANCTUARY RECORDS LIMITED?

    • Künstlerische Tätigkeit (90030) / Kunst, Unterhaltung und Erholung
    • Andere Dienstleistungen n.a. (96090) / Sonstige Dienstleistungsbereiche

    Wo befindet sich SANCTUARY RECORDS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    33 Wigmore Street
    W1U 1QX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SANCTUARY RECORDS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SANCTUARY ASSOCIATED INVESTMENTS LIMITED05. März 199205. März 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SANCTUARY RECORDS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SANCTUARY RECORDS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SANCTUARY RECORDS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Änderung der Details des Direktors für Maximilian Dressendoerfer am 17. Okt. 2014

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Mark David Ranyard am 17. Okt. 2014

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    8 SeitenAA

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 28. Aug. 2014

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom Beaumont House Avonmore Road Kensington Village London W14 8TS United Kingdom zum Simons Muirhead & Burton 8 9 Frith Street London W1D 3JB geändert

    1 SeitenAD02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Simons Muirhead & Burton 8 9 Frith Street London W1D 3JB verlegt

    1 SeitenAD03

    Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Davenport Lyons 30 Old Burlington Street London W1S 3NL am 10. Sept. 2013

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Mark David Ranyard als Direktor am 30. Apr. 2013

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Maximilian Dressendoerfer als Direktor am 30. Apr. 2013

    2 SeitenAP01

    Ernennung von John Leslie Dobinson als Direktor am 30. Apr. 2013

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Timothy Spencer Smith als Geschäftsführer am 30. Apr. 2013

    1 SeitenTM01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 364-366 Kensington High Street London W14 8NS England am 10. Mai 2013

    2 SeitenAD01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 05. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Beendigung der Bestellung von Richard Michael Constant als Geschäftsführer am 21. Nov. 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Andrew Brown als Geschäftsführer am 21. Nov. 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Abolanle Abioye als Sekretär am 21. Nov. 2012

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Timothy Spencer Smith als Direktor am 21. Nov. 2012

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von SANCTUARY RECORDS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DOBINSON, John Leslie
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    United KingdomBritishChief Operating Officer - Europe34942720003
    DRESSENDOERFER, Maximilian, Dr
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    GermanyGermanCompany Director157717080010
    RANYARD, Mark David
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    Geschäftsführer
    Wigmore Street
    W1U 1QX London
    33
    England
    EnglandBritishFinance Director154884950002
    ABIOYE, Abolanle
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Sekretär
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    BritishSecretary88802330001
    JOY, Matthew Robert
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    2 Chestnut Place
    KT21 2DY Ashtead
    Surrey
    British115905420001
    MILLER, Michael David
    76 Marsworth Avenue
    HA5 4TT Pinner
    Middlesex
    Sekretär
    76 Marsworth Avenue
    HA5 4TT Pinner
    Middlesex
    British44250870001
    STANDING, Sarah Elizabeth Anne
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    Sekretär
    1 Pilsdon Close
    Inner Park Road Wimbledon
    SW19 6DR London
    British41378870002
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BROWN, Andrew
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    EnglandBritishInternational Chief Financial Officer163199590001
    BURTON, Paul Anthony
    65 Hartford Road
    DA5 1NL Bexley
    Kent
    Geschäftsführer
    65 Hartford Road
    DA5 1NL Bexley
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant34303730002
    COKELL, Joseph
    Talltrees
    Orpington Road
    BR7 6RA Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Talltrees
    Orpington Road
    BR7 6RA Chislehurst
    Kent
    Gb-EngBritishCompany Director76396440001
    CONSTANT, Richard Michael
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Kensington High Street
    W14 8NS London
    364-366
    United Kingdom
    United KingdomBritishGeneral Counsel43836310003
    COURTNEY, Rohan Richard
    Deepwood
    Lower Wood Road
    SY8 2JQ Ludlow
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Deepwood
    Lower Wood Road
    SY8 2JQ Ludlow
    Shropshire
    BritishCompany Director9512790002
    DAVIES, David Michael
    13 Marine Parade
    CF64 3BG Penarth
    South Glamorgan
    Geschäftsführer
    13 Marine Parade
    CF64 3BG Penarth
    South Glamorgan
    United KingdomBritishDirector3792920003
    DAVIES, Hywel Hadley
    2b Florence Road
    W5 3TX London
    Geschäftsführer
    2b Florence Road
    W5 3TX London
    BritishManaging Director13515170001
    DRISCOLL, James Christopher
    66 Norton Road
    DY8 2AQ Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    66 Norton Road
    DY8 2AQ Stourbridge
    West Midlands
    BritishCompany Director98716480001
    DRISCOLL, James Christopher
    66 Norton Road
    DY8 2AQ Stourbridge
    West Midlands
    Geschäftsführer
    66 Norton Road
    DY8 2AQ Stourbridge
    West Midlands
    BritishDirector98716480001
    HAXBY, Martin James, Mr.
    Wildhern 133 Silverdale Avenue
    Ashley Park
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Wildhern 133 Silverdale Avenue
    Ashley Park
    KT12 1EJ Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritishBusiness Affairs Director6001160002
    MILLER, Michael David
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Geschäftsführer
    High Trees 15a Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritishChartered Accountant44250870002
    MUIR, Boyd Johnston
    Colorado Avenue
    CA 90404 Santa Monica
    2220
    Usa
    Geschäftsführer
    Colorado Avenue
    CA 90404 Santa Monica
    2220
    Usa
    United StatesBritishEvp & Chief Financial Officer172824510001
    NAJEEB, Aky
    The Old School House
    Bovington Green
    SL7 2JH Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Old School House
    Bovington Green
    SL7 2JH Marlow
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director10689380007
    SMALLWOOD, Roderick Charles
    42 Hartingdon Road
    Chiswick
    W4 London
    Geschäftsführer
    42 Hartingdon Road
    Chiswick
    W4 London
    BritishManager43907530001
    SMITH, Timothy Spencer
    Avonmore Road
    Kensington Village
    W14 8TS London
    Beaumont House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Avonmore Road
    Kensington Village
    W14 8TS London
    Beaumont House
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor130003340001
    TAYLOR, Andrew John
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Bridge House Bisham Road
    SL7 1RP Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChartered Accountant54448520001
    WALLACE, Paul Frederick
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Westfield House
    Nunnery Lane
    TN11 8HA Penshurst
    Kent
    EnglandBritishChartered Accountant76655520001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Hat SANCTUARY RECORDS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juni 2002
    Geliefert am 27. Juni 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 27. Juni 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998 (the "deed")
    Erstellt am 11. Aug. 2000
    Geliefert am 30. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due owing or incurred to the chargee under the mezzanine documents by any charging company (as defined)
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 45-53 sinclair road, hammersmith, london t/no BGL14049 together with all buildings, fixtures and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 30. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 29 october 1998
    Erstellt am 01. Juli 1999
    Geliefert am 09. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to the terms of the mezzanine documents (as defined)
    Kurze Angaben
    All its f/h and l/h interest in the properties being the l/h property k/a 45-53 sinclair road,hammersmith,london t/no BGL14049 together with all buildings,fixtures (excluding in the case of l/h property landlord's fixtures but including other trade fixtures and excluding in the case of f/h property and l/h property which is let or sub-let to a third party,tenant's and trade fixtures and fittings of such third party) and its fixed plant and machinery at any time thereon.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 09. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 29. Okt. 1998
    Geliefert am 17. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine documents
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Okt. 1998
    Geliefert am 06. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 06. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Sept. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture originally dated 3RD september 1997
    Erstellt am 03. Juli 1998
    Geliefert am 21. Juli 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from sanctuary enterprises PLC (borrower) to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 21. Juli 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of amendment to a composite guarantee and debenture dated 3 september 1997
    Erstellt am 20. Mai 1998
    Geliefert am 06. Juni 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies which are as at 20 may 1998 due or to become due from sanctuary enterprises PLC (the "borrower") to the chargee under the mezzanine loan agreement dated 3 september 1997 whether pursuant to the guarantee as therein defined) or otherwise and all other sums payable pursuant to the terms of the mezzanine loan agreement and the deed
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 06. Juni 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Sept. 1997
    Geliefert am 19. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    That part of the mezzanine loan facility drawndown by the the sanctuary group PLC to the company or to nomis studios limited and/or to companies in which either of the company or nomis holds an equity interest
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Abn Amro Causeway Mezzanine Partnership LP
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 26. Aug. 1997
    Geliefert am 16. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Brown Shipley & Co Limited
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 24. März 1997
    Geliefert am 26. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 26. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Sept. 1994
    Geliefert am 01. Okt. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 01. Okt. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0