NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02699287 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Severn Trent Centre St. Johns Street CV1 2LZ Coventry England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| CUMBRIA GAS LIMITED | 23. Apr. 1992 | 23. Apr. 1992 |
| DIRECTMASTER SYSTEMS LIMITED | 20. März 1992 | 20. März 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2023 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |
|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2023 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 3 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2021 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Beendigung der Bestellung von John Anthony Jackson als Geschäftsführer am 31. März 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||
Ernennung von Mr Adam Peter Stephens als Direktor am 31. März 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2020 | 3 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2019 | 4 Seiten | AA | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2018 | 4 Seiten | AA | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Dez. 2018 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||
Change of details for Dee Valley Plc as a person with significant control on 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. März 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||
Register(s) wurden an die Geschäftsanschrift Severn Trent Centre St. Johns Street Coventry CV1 2LZ verlegt | 1 Seiten | AD04 | ||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen Wrexham LL14 4EH zum Severn Trent Centre St. Johns Street Coventry CV1 2LZ am 27. Feb. 2018 | 1 Seiten | AD01 | ||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2017 | 4 Seiten | AA | ||
Beendigung der Bestellung von Mark James Dovey als Geschäftsführer am 14. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 2 st. Johns Street Coventry CV1 2LZ verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||
Wer sind die Geschäftsführer von NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE, Gemma Louise | Sekretär | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | 227679500001 | |||||||
| MCPHEELY, Robert Craig | Geschäftsführer | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | England | British | 104273610001 | |||||
| STEPHENS, Adam Peter | Geschäftsführer | 2 St John’S Street CV1 2LZ Coventry Severn Trent Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 281599070001 | |||||
| BAILEY, John | Sekretär | 21 The Croft Kirby Hill YO51 9YA Boroughbridge North Yorkshire | British | 58501700001 | ||||||
| BICKERTON, Andrew Alan | Sekretär | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | 187483960001 | |||||||
| BRAGG, Tracy Elaine | Sekretär | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | 222116530001 | |||||||
| GUEST, David James | Sekretär | 3 Harvey Avenue CW5 6LE Nantwich Cheshire | British | 6573790001 | ||||||
| MILNOR, Lisa Rachael | Sekretär | Goal Farm Hellifield BD23 4JR Skipton North Yorkshire | British | 53306760001 | ||||||
| STANFORD, Thomas Martin | Sekretär | 127 Arthurs Avenue HG2 0EH Harrogate North Yorkshire | British | 40126480003 | ||||||
| STRAHAN, David Edward | Sekretär | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | 174729570001 | |||||||
| YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000880001 | |||||||
| BAILEY, John | Geschäftsführer | 21 The Croft Kirby Hill YO51 9YA Boroughbridge North Yorkshire | British | 58501700001 | ||||||
| BELLIS, Brynley | Geschäftsführer | Erw Fran Llandyrnog LL16 4LY Denbigh | British | 33428580002 | ||||||
| BICKERTON, Andrew Alan | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | United Kingdom | British | 187480330001 | |||||
| CARLSON, Carl Sidney | Geschäftsführer | Becks Barn School Road Hanbury WR9 7EA Droitwich Worcestershire | United Kingdom | British | 36366460002 | |||||
| DOVEY, Mark James, Mr. | Geschäftsführer | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | England | British | 166254070001 | |||||
| GUEST, David James | Geschäftsführer | 3 Harvey Avenue CW5 6LE Nantwich Cheshire | England | British | 6573790001 | |||||
| HOLLADAY, Norman Charles | Geschäftsführer | Norwood Drive Westminster Park CH4 7RH Chester 33 Cheshire | United Kingdom | British | 136424810001 | |||||
| HOWARTH, Stuart Belton, Dr | Geschäftsführer | Chapel House Threapwood SY14 7AX Malpas Cheshire | United Kingdom | British | 37875800001 | |||||
| ILLINGWORTH, David Stephen | Geschäftsführer | Woodside Greystone Plain Lane Hampsthwaite HG3 2HT Harrogate North Yorkshire | United Kingdom | British | 13110120001 | |||||
| ILLINGWORTH, Howard Seth | Geschäftsführer | Ashcroft Rowden Lane Hampsthwaite HG3 2HR Harrogate North Yorkshire | England | British | 13110110001 | |||||
| ILLINGWORTH, Mark Richard | Geschäftsführer | Hampsthwaite Head Hampsthwaite HG3 2HT Harrogate North Yorkshire | British | 13110130002 | ||||||
| JACKSON, John Anthony | Geschäftsführer | St. Johns Street CV1 2LZ Coventry 2 England | United Kingdom | Irish | 190509470001 | |||||
| JENKINS, Brian Stuart | Geschäftsführer | Beeston House CW6 9ST Tarporley Cheshire | British | 14981320001 | ||||||
| MILNOR, Lisa Rachael | Geschäftsführer | Goal Farm Hellifield BD23 4JR Skipton North Yorkshire | United Kingdom | British | 53306760001 | |||||
| PLENDERLEITH, Ian John Alexander | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | England | British | 130393790001 | |||||
| STRAHAN, David Edward | Geschäftsführer | Packsaddle Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham | Northern Ireland | British | 145588240001 | |||||
| WALMSLEY, Steven Adrian | Geschäftsführer | The Gables Minskip Road, Boroughbridge YO51 9HY York North Yorkshire | United Kingdom | British | 33287040002 | |||||
| YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 York Place LS1 2DS Leeds West Yorkshire | 900000870001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dee Valley Limited | 06. Apr. 2016 | Wrexham Road Rhostyllen LL14 4EH Wrexham Packsaddle Wales | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat NORTHERN GAS SUPPLIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Fixed charge | Erstellt am 29. Aug. 1997 Geliefert am 03. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The computer equipment and accessories in invoice number INV01644 from technology products limited dated 12TH june 1997 the proceeds and products thereofand all policies of insurance and elated rights thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. Mai 1997 Geliefert am 06. Juni 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balances | Erstellt am 02. Aug. 1993 Geliefert am 09. Aug. 1993 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The sum of £49,500 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 67045405. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0