MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED

MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02702022
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    • (9231) /

    Wo befindet sich MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Quadrant House
    4 Thomas More Square
    E1W 1YW London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SPEED 2486 LIMITED31. März 199231. März 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Juli 2007
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Mai 2008
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Juli 2006

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis31. März 2017
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung14. Apr. 2017
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2025

    15 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2023

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2022

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2022

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2021

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2021

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2020

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2020

    5 Seiten4.68

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER zum Quadrant House 4 Thomas More Square London E1W 1YW am 07. Juni 2019

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2019

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2018

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2017

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2016

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2015

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2014

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2013

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Juli 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Jan. 2012

    5 Seiten4.68

    Wer sind die Geschäftsführer von MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    HUDSON, Kathleen Mary
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Sekretär
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Australian27259310004
    MARSHALL, Wilfred Terrence
    Perth Y Felin
    SY20 9JG Dinas Mawddwy
    Gwynedd
    Geschäftsführer
    Perth Y Felin
    SY20 9JG Dinas Mawddwy
    Gwynedd
    WalesBritish112866220001
    MBC SECRETARIES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Bevollmächtigter Sekretär
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000700001
    HUDSON, John Richard
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Geschäftsführer
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    British27259300005
    HUDSON, Kathleen Mary
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Geschäftsführer
    135 Gloucester Avenue
    NW1 8JN London
    Australian27259310004
    MILLS, Daniel
    29 Ronald Close
    BR3 3HX Beckenham
    Kent
    Geschäftsführer
    29 Ronald Close
    BR3 3HX Beckenham
    Kent
    British100906470001
    MBC NOMINEES LIMITED
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Classic House
    174-180 Old Street
    EC1V 9BP London
    900000690001

    Hat MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 25. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    11A sharpeshall street london t/n NGL124684 including all rights attached or appurtenant to it and all buildings fixtures fittings plant and machinery from time to time situate on it. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Israel Discount Bank Limited
    Transaktionen
    • 25. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over credit balance
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 25. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Israel Discount Bank Limited
    Transaktionen
    • 25. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 11. Juli 2006
    Geliefert am 25. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Israel Discount Bank Limited
    Transaktionen
    • 25. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Mai 2005
    Geliefert am 19. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold known as 11 sharpleshall st,london NW1; NGL124684; all fixed plant machinery implements utensils furniture and equipment; the goodwill of business and benefit of all covenants rights and agreements thereon.
    Berechtigte Personen
    • Cheval Bridging Finance Limited
    Transaktionen
    • 19. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 24. Dez. 2004
    Geliefert am 06. Jan. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assigns the equipment, ssl console xl 90000K serial no. 91481 and the proceeds of all policies of insurance;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trust PLC
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 28. Jan. 2004
    Geliefert am 09. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trust PLC
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 28. Jan. 2004
    Geliefert am 09. Feb. 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    As security for the payment or discharge of the secured monies the mortgagor as beneficial owner assigns the equipment being 1 comelit vox 200 door intercom system, 4 white window planters with plants, 1 blue sack trolley for further details of the equipment charged please refer to the form 395 and assigns to the mortgagee the proceeds of all policies of insurance and the benefit of all options and rights devolving upon the mortgagor under any such policy of insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trust PLC
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Dez. 2003
    Geliefert am 07. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H and l/h property, book debts, credit balances, stocks and shares, documents deposited with bank, goodwill, licence, patents, trademarks, copyrights floating charge undertaking and all property assets and rights present and future.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 29. Dez. 2003
    Geliefert am 07. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    11A sharpleshall street london t/no NGL124684 proceeds of sale floating security all property and assets present and future specific equitable charge shares insurances building contracts and guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Bank Leumi (UK) PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 09. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £181250.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chattels being studio one - control room, solid state logic console 6048, recall, g eq, bargraph metering emt remote, lh producers desk, rh patchbay, built in outboard wing g+ softwear computer, twin bemouli integral synchroniser system & 3 machine s/no. 1984, lexicon 224X with larc s/no. 1329 (for further details of chattels charged please see form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of mortgage
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 09. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property k/a 11A sharpleshall street london NW1 8YN t/n NGL124684.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. März 2002
    Geliefert am 09. Apr. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • State Securities PLC
    Transaktionen
    • 09. Apr. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 25. Sept. 2001
    Geliefert am 27. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Cheval Property Finance PLC
    Transaktionen
    • 27. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Dez. 1999
    Geliefert am 23. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 11A sharplehall street london t/n NGL124684. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 23. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Nov. 1999
    Geliefert am 20. Nov. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Nov. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 10. März 1997
    Geliefert am 12. März 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A charge by way of legal mortgage over 11A sharpleshall street harrow district t/no.ngl 124684 and the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company
    Transaktionen
    • 12. März 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Nov. 1996
    Geliefert am 27. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 11A sharpleshall street london t/no NGL124684 &. together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Chartered Trust PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 27. Nov. 1996
    Geliefert am 27. Nov. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that policy of assurance on the life of john richard hudson with legal and general assurance society under policy no 0083671925 and all monies assured by or to become payable under the said policy and the full benefit thereof.
    Berechtigte Personen
    • Chartered Trust PLC
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Corporate mortgage
    Erstellt am 11. Apr. 1995
    Geliefert am 27. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 1ST march 1995 including any modification or replacement thereof
    Kurze Angaben
    Master transport selector fitted-serial number-1984. Mitsubishi X86032 track 1" digital recorder-serial number-4057201.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 03. März 1995
    Geliefert am 21. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MAYFAIR RECORDING STUDIOS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    22. Dez. 2006Beginn der Verwaltung
    05. Jan. 2009Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stephen Mark Katz
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    2
    DatumTyp
    05. Jan. 2009Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian N Johnson
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11/15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11/15 William Road
    London
    Stephen Mark Katz
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Praktiker
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    David Birne
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London
    Praktiker
    Fisher Partners
    Acre House
    NW1 3ER 11-15 William Road
    London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0