MAIDEN HOLDINGS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMAIDEN HOLDINGS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02704072
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MAIDEN HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich MAIDEN HOLDINGS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MAIDEN HOLDINGS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    THE MAIDEN GROUP LIMITED06. Mai 199306. Mai 1993
    MATAHARI 451 LIMITED06. Apr. 199206. Apr. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAIDEN HOLDINGS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für MAIDEN HOLDINGS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    12 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. März 2013

    15 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. März 2012

    14 Seiten4.68

    Vermögensübersicht mit Formular 4.19

    5 Seiten4.20

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Außerordentlicher Beschluss zur Vergleichsverfahren am 22. März 2011

    LRESEX

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 186 City Road London EC1V 2NT am 30. März 2011

    1 SeitenAD01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2009

    6 SeitenAR01

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    14 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    7 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    12 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    14 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von MAIDEN HOLDINGS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Sekretär
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    British122298900001
    ALLMAN, Donald Russell
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Geschäftsführer
    55 Arrowhead Way
    Darien
    Connecticut 06820
    Usa
    Usa113088010001
    APFELBAUM, William Michael
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    Geschäftsführer
    143 Byram Shore Road
    Greenwich
    Connecticut 06830
    Usa
    American113086280001
    GOLDSMITH, Scott
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    Geschäftsführer
    200 East 71st Street
    New York
    Ny 10021
    Usa
    American111559610001
    JOHNSTON, Matthew Ian
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    Geschäftsführer
    2 Boxgate
    TN6 1SF Crowborough
    East Sussex
    EnglandBritish122298900001
    MOUG, Andrew John
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Wintons
    Tanhouse Lane Peasmarsh
    TN31 6UX Rye
    East Sussex
    EnglandBritish85481770002
    SLATKIN, Jonathan Aaron
    Stanhope Gardens
    NW7 2JD London
    26
    Geschäftsführer
    Stanhope Gardens
    NW7 2JD London
    26
    American117628600002
    SAVAGE, Timothy John
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    Sekretär
    Squirrels Wood
    Clock House Lane, Bramley
    GU5 0AP Guildford
    Surrey
    British8871460006
    TKB REGISTRARS LIMITED
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    Bevollmächtigter Sekretär
    50 Stratton Street
    W1X 6NX London
    900002650001
    BOASE, Martin
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    Geschäftsführer
    27 St Leonards Terrace
    SW3 4QG London
    United KingdomBritish1460150003
    BOYLE, Tobias Humphrey James
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    Geschäftsführer
    67 Carlton Hill
    NW8 0EN London
    EnglandBritish141831310001
    DRON, David John Anthony
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    Somerville 5 Adelaide Road
    KT12 1NB Walton On Thames
    Surrey
    British1730460002
    GOODWIN, Francis Dominic
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    Geschäftsführer
    The Mansion House
    1 Purley Magna
    RG8 8EL Purley On Thames
    Berkshire
    United KingdomUnited Kingdom127055040001
    POWELL, Ian
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    The Weir House
    7 Preston Crowmarsh
    OX10 6SL Benson
    Oxfordshire
    EnglandBritish33706140001
    PUGH, David John
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    Geschäftsführer
    12 Vineyard Hill Road
    SW19 7JH London
    British70814670001
    REAY, Alison
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    Geschäftsführer
    Flat 2
    1 Parkhill Road
    NW3 2YJ London
    EnglandBritish113085780001
    ROPER, Mervyn Edward Patrick
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    19 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    British900002640001
    SWAINSON, John Frederick
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    Geschäftsführer
    15 Chaldon Way
    CR5 1DG Coulsdon
    Surrey
    British114617510001
    ZEGHIBE, Ronald William
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    Geschäftsführer
    19 Cheyne Walk
    SW3 5RA London
    United KingdomAmerican51349440001

    Hat MAIDEN HOLDINGS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Security agreement
    Erstellt am 15. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage over shares
    Erstellt am 15. Aug. 2006
    Geliefert am 31. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from titan outdoor ireland limited and titan outdoor advertising limited to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All rights in and to the original shares any further shares and any related assets including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • General Electric Capital Corporation
    Transaktionen
    • 31. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security agreement
    Erstellt am 22. Dez. 2004
    Geliefert am 07. Jan. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, intellectual property and miscellaneous. Floating charge all its assets.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The "Security Trustee")
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Juni 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Security agreement
    Erstellt am 19. Juli 2002
    Geliefert am 05. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from maiden group PLC to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC(The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Juni 1995
    Geliefert am 29. Juni 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 14 half moon street (ngl 459043), l/h property k/a fifth floor churchill house titheborn street liverpool MS1087453. L/h property k/a suite 15 floor c josephs well westgate leeds. L/h property k/a part first floor 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a part second floor, 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a unit 2 22/24 glanville street birmingham.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co Limitedthe "Security Agent"
    Transaktionen
    • 29. Juni 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 01. Juni 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Apr. 1995
    Geliefert am 25. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each or any of the finance documents or any other document
    Kurze Angaben
    See schedule attached to form M395 for details of all the properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limited(The "Security Agent") as Agent and Trustee Foritself and Each of the Lenders (as Defined)
    Transaktionen
    • 25. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignment of key-man policies
    Erstellt am 21. Juli 1993
    Geliefert am 29. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and each of the key-man life assurance policies set out on the reverse of the form 395 and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and the full benefit thereof and all rights, title and interest therin (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 29. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 08. Apr. 1993
    Geliefert am 22. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with each of the financing documents (all as defined)
    Kurze Angaben
    (For full details see form 395 and contd sheets). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee) and the Banks
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Apr. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat MAIDEN HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Dez. 2013Aufgelöst am
    22. März 2011Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Stuart Charles Edward Mackellar
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Praktiker
    Toronto Square Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    Simon Jonathan Appell
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0