MAIDEN HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MAIDEN HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02704072 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MAIDEN HOLDINGS LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich MAIDEN HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | The Zenith Building 26 Spring Gardens M2 1AB Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MAIDEN HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| THE MAIDEN GROUP LIMITED | 06. Mai 1993 | 06. Mai 1993 |
| MATAHARI 451 LIMITED | 06. Apr. 1992 | 06. Apr. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MAIDEN HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MAIDEN HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 12 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. März 2013 | 15 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. März 2012 | 14 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 4.19 | 5 Seiten | 4.20 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 186 City Road London EC1V 2NT am 30. März 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 19. Juni 2009 | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MAIDEN HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSTON, Matthew Ian | Sekretär | 2 Boxgate TN6 1SF Crowborough East Sussex | British | 122298900001 | ||||||
| ALLMAN, Donald Russell | Geschäftsführer | 55 Arrowhead Way Darien Connecticut 06820 Usa | Usa | 113088010001 | ||||||
| APFELBAUM, William Michael | Geschäftsführer | 143 Byram Shore Road Greenwich Connecticut 06830 Usa | American | 113086280001 | ||||||
| GOLDSMITH, Scott | Geschäftsführer | 200 East 71st Street New York Ny 10021 Usa | American | 111559610001 | ||||||
| JOHNSTON, Matthew Ian | Geschäftsführer | 2 Boxgate TN6 1SF Crowborough East Sussex | England | British | 122298900001 | |||||
| MOUG, Andrew John | Geschäftsführer | Wintons Tanhouse Lane Peasmarsh TN31 6UX Rye East Sussex | England | British | 85481770002 | |||||
| SLATKIN, Jonathan Aaron | Geschäftsführer | Stanhope Gardens NW7 2JD London 26 | American | 117628600002 | ||||||
| SAVAGE, Timothy John | Sekretär | Squirrels Wood Clock House Lane, Bramley GU5 0AP Guildford Surrey | British | 8871460006 | ||||||
| TKB REGISTRARS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | 50 Stratton Street W1X 6NX London | 900002650001 | |||||||
| BOASE, Martin | Geschäftsführer | 27 St Leonards Terrace SW3 4QG London | United Kingdom | British | 1460150003 | |||||
| BOYLE, Tobias Humphrey James | Geschäftsführer | 67 Carlton Hill NW8 0EN London | England | British | 141831310001 | |||||
| DRON, David John Anthony | Geschäftsführer | Somerville 5 Adelaide Road KT12 1NB Walton On Thames Surrey | British | 1730460002 | ||||||
| GOODWIN, Francis Dominic | Geschäftsführer | The Mansion House 1 Purley Magna RG8 8EL Purley On Thames Berkshire | United Kingdom | United Kingdom | 127055040001 | |||||
| POWELL, Ian | Geschäftsführer | The Weir House 7 Preston Crowmarsh OX10 6SL Benson Oxfordshire | England | British | 33706140001 | |||||
| PUGH, David John | Geschäftsführer | 12 Vineyard Hill Road SW19 7JH London | British | 70814670001 | ||||||
| REAY, Alison | Geschäftsführer | Flat 2 1 Parkhill Road NW3 2YJ London | England | British | 113085780001 | |||||
| ROPER, Mervyn Edward Patrick | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 19 Criffel Avenue SW2 4AY London | British | 900002640001 | ||||||
| SWAINSON, John Frederick | Geschäftsführer | 15 Chaldon Way CR5 1DG Coulsdon Surrey | British | 114617510001 | ||||||
| ZEGHIBE, Ronald William | Geschäftsführer | 19 Cheyne Walk SW3 5RA London | United Kingdom | American | 51349440001 |
Hat MAIDEN HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Erstellt am 15. Aug. 2006 Geliefert am 31. Aug. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage over shares | Erstellt am 15. Aug. 2006 Geliefert am 31. Aug. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from titan outdoor ireland limited and titan outdoor advertising limited to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All rights in and to the original shares any further shares and any related assets including dividends,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 22. Dez. 2004 Geliefert am 07. Jan. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, intellectual property and miscellaneous. Floating charge all its assets.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security agreement | Erstellt am 19. Juli 2002 Geliefert am 05. Aug. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from maiden group PLC to any transaction party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Juni 1995 Geliefert am 29. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture) | |
Kurze Angaben L/H property k/a 14 half moon street (ngl 459043), l/h property k/a fifth floor churchill house titheborn street liverpool MS1087453. L/h property k/a suite 15 floor c josephs well westgate leeds. L/h property k/a part first floor 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a part second floor, 371/375 kennington lane london SE11. L/h property k/a unit 2 22/24 glanville street birmingham.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Apr. 1995 Geliefert am 25. Apr. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each or any of the finance documents or any other document | |
Kurze Angaben See schedule attached to form M395 for details of all the properties. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment of key-man policies | Erstellt am 21. Juli 1993 Geliefert am 29. Juli 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and each of the key-man life assurance policies set out on the reverse of the form 395 and all moneys thereby assured which may become payable thereunder and the full benefit thereof and all rights, title and interest therin (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 08. Apr. 1993 Geliefert am 22. Apr. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with each of the financing documents (all as defined) | |
Kurze Angaben (For full details see form 395 and contd sheets). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MAIDEN HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0