MERSEYRIDER LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MERSEYRIDER LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02708460 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MERSEYRIDER LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MERSEYRIDER LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MERSEYRIDER LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MERSEYRIDER LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 8 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Admiral Way Doxford International Business Park Sunderland Tyne & Wear SR3 3XP am 14. Sept. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Anthony Bowler als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Martin Stone als Geschäftsführer am 28. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 26. Mai 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Kenneth Mcintyre Carlaw als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Turner als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Anthony Bowler am 22. Apr. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Paul Turner am 22. Apr. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Philip Martin Stone am 22. Apr. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Malcolm Gilkerson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Ms Elizabeth Anne Thorpe am 22. Apr. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MERSEYRIDER LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIES, Elizabeth Anne | Sekretär | Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | British | 102907000002 | ||||||
| CARLAW, Kenneth Mcintyre | Geschäftsführer | Clifton Moor Business Village James Nicolson Link Clifton Moor YO30 4XG York 11 | England | British | 161250030001 | |||||
| MILLINGTON, Ronald Gordon | Sekretär | 3 Teddington Close Dudlows Green WA4 5QG Warrington Cheshire | British | 30257840002 | ||||||
| MORRIS, Roderick Gruffydd | Sekretär | 26 Greenhill Place The Park Huyton Wnn Roby L36 5RU Liverpool Merseyside | British | 102834790001 | ||||||
| THORPE, Elizabeth Anne | Sekretär | 2 Oakwood DH7 0NP Lanchester County Durham | British | 102907000001 | ||||||
| TURNER, David Paul | Sekretär | 139 Eastern Way Darras Hall Ponteland NE20 9RH Newcastle Upon Tyne | British | 48937720001 | ||||||
| VIRTUE, John | Sekretär | 91 Hollywood Avenue Gosforth NE3 5BU Newcastle Upon Tyne Tyne & Wear | British | 102404840001 | ||||||
| WOODWARD, Deborah Anne | Sekretär | 37a Lavender Gardens SW11 1DJ London | British | 3219400004 | ||||||
| CORPORATE NOMINEE SECRETARIES LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Falcon House 24 North John Street L2 9RP Liverpool | 900001010001 | |||||||
| BOWLER, Richard Anthony | Geschäftsführer | Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 35116070001 | |||||
| BRADY, Dominic | Geschäftsführer | 54 High Street Hale Village L24 4AF Liverpool Merseyside | Uk | British | 125406360001 | |||||
| CAMPBELL, Iain Fraser | Geschäftsführer | 3 Hallgate Daisy Hill Westhoughton BL5 2SF Bolton Lancashire | British | 66379980001 | ||||||
| CLAYTON, Stephen John | Geschäftsführer | New Hall Farmhouse Fanhams Hall Road Newhall Green Wareside SG12 7SD Ware Hertfordshire | England | British | 46866840005 | |||||
| COLEMAN, Alan Hague | Geschäftsführer | 17 Kent Close Bromborough L63 0EF Wirral Merseyside | British | 18844210001 | ||||||
| COOMBES, Peter Geoffrey | Geschäftsführer | 7 Mclauchlan Rise Aberdour KY3 0SS Burntisland Fife Scotland | British | 34146400001 | ||||||
| FULLER, Colin Eric | Geschäftsführer | Broadmore House Broadmore Lane ST18 0LD Stowe-By-Chartley Staffordshire | England | British | 59600860003 | |||||
| GILKERSON, Malcolm | Geschäftsführer | 111 Min-Y-Don LL22 7LY Abergele Clwyd | United Kingdom | British | 46793270001 | |||||
| HIND, Robert Andrew | Geschäftsführer | 18 Maplewell Road Woodhouse Eaves LE12 8QZ Loughborough Leicestershire | United Kingdom | British | 21961900002 | |||||
| LONSDALE, Stephen Philip | Geschäftsführer | 5 Lintfort Picktree Farm Picktree NE38 9HX Chester Le Street County Durham | United Kingdom | British | 4971910001 | |||||
| MARTIN, David Robert | Geschäftsführer | Bondwood Barn Repton Shrubs Bretby DE15 0RJ Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | 6874440001 | |||||
| MILLINGTON, Ronald Gordon | Geschäftsführer | 3 Teddington Close Dudlows Green WA4 5QG Warrington Cheshire | British | 30257840002 | ||||||
| MORRIS, Roderick Gruffydd | Geschäftsführer | 26 Greenhill Place The Park Huyton Wnn Roby L36 5RU Liverpool Merseyside | United Kingdom | British | 102834790001 | |||||
| RAY, John Alfred | Geschäftsführer | 50 The Gables Sedgefield TS21 3EU Stockton On Tees Cleveland | British | 58415290001 | ||||||
| ROBERTS, Graham Stanley | Geschäftsführer | Wheelwrights Todenham GL56 9NZ Moreton In Marsh Gloucestershire | British | 72671680001 | ||||||
| SNAPE, Paul | Geschäftsführer | 51 Seaton Way Cambridge Park PR9 9GJ Southport Merseyside | British | 34326560001 | ||||||
| STONE, Philip Martin | Geschäftsführer | Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | England | British | 69200640003 | |||||
| STONE, Philip Martin | Geschäftsführer | 21 Beechfield Road Mayfield PR25 3BG Leyland Lancashire | England | British | 69200640003 | |||||
| TURNER, David Paul | Geschäftsführer | Admiral Way Doxford International Business SR3 3XP Park Sunderland Tyne & Wear | United Kingdom | British | 48937720001 | |||||
| CORPORATE NOMINEE SERVICES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Falcon House 24 North John Street L2 9RP Liverpool | 900001020001 |
Hat MERSEYRIDER LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental debenture | Erstellt am 07. Feb. 1997 Geliefert am 27. Feb. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as security trustee on behalf of the beneficiaries as identified in the debenture dated 3RD july 1996) under the terms of this supplemental debenture dated 7TH february 1997 or by the debenture dated 3RD july 1996 (as supplemented by a supplemental deed dated 19TH december 1996) | |
Kurze Angaben The company with full title guarantee charges in favour of the security trustee all its property, assets and undertaking on the terms set out in clause 4 of the debenture (as defined).. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 03. Juli 1996 Geliefert am 22. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company or by any other company named therein to the chargee under the facility agreement and/or the security documents as defined in the guarantee and debenture | |
Kurze Angaben F/H land and buildings comprising edge lane works and garage liverpool, f/h land and buildings carnegie road garage green lane liverpool f/h land and buildings garston bus depot speke road liverpool t/no MS156996 f/h land and buildings gilmoss garage east lancashire road gilmoss liverpool and all the other properties as detailed in part v of the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture as supplemented by a supplemental deed to the guarantee and debenture dated 26TH october 1994 and created by london bus company limited | Erstellt am 26. Okt. 1994 Geliefert am 11. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the charge) | |
Kurze Angaben Various properties as defined in the charge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 17. Dez. 1992 Geliefert am 06. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from mtl trust holdings limited to merseyside passenger transport authority ("the chargee") under the terms of a sale and purchase agreement, an agreement and a deed of covenant all dated 17TH december 1992 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this guarantee and debenture | |
Kurze Angaben (Please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MERSEYRIDER LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0