CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED

CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02720955
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    URBANCHAIN LIMITED11. Dez. 200311. Dez. 2003
    PREMIERE EMPLOYMENT GROUP LIMITED03. Jan. 199503. Jan. 1995
    PREMIERE EMPLOYMENT LIMITED17. Juli 199217. Juli 1992
    GREATUSUAL LIMITED08. Juni 199208. Juni 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von Jack Rainer Ullmann als Geschäftsführer am 12. März 2021

    1 SeitenTM01

    Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt.

    1 SeitenSOAS(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    1 SeitenDS01

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 027209550014 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 12 vollständig

    1 SeitenMR04

    Beendigung der Bestellung von Chris Martin Kenneally als Geschäftsführer am 16. März 2020

    1 SeitenTM01

    Erfüllung der Belastung 027209550015 vollständig

    1 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 15. Jan. 2020 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    7 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017

    7 SeitenAA

    Geänderte Konten für ein ruhendes Unternehmen erstellt bis 31. Dez. 2016

    7 SeitenAAMD

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    2 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 10. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    6 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2016 bis 31. Dez. 2016

    1 SeitenAA01

    Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse

    2 SeitenSH08

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2016 bis 30. Juni 2016

    1 SeitenAA01

    Jahresabschluss für Kleinstunternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    2 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 12. Mai 2016

    • Kapital: GBP 52,632
    SH01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2015 bis 31. Dez. 2015

    1 SeitenAA01

    Ernennung von Mr Chris Kenneally als Direktor am 17. Sept. 2015

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CONNOR, Alan
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Sekretär
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    British118003220001
    ULLMANN, Phillip Lionel
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritish46458480002
    BELCHEM, Gary
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    Sekretär
    17 Turkey Oak Close
    Upper Norwood
    SE19 2NZ London
    British66391670002
    GARRATT, Mark Jonathan
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    Sekretär
    21 Stradella Road
    Herne Hill
    SE24 9HN London
    British118003050001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Sekretär
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    British94546740001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Sekretär
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    British94546740001
    MILLER, David
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    Sekretär
    3 Worsdell Way
    SG4 0EB Hitchin
    Hertfordshire
    British59650030004
    TAYLOR, Michael John
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    Sekretär
    6 Garratts Lane
    SM7 2DZ Banstead
    Surrey
    British64380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BIDDULPH, David Paul
    34 Clough Fold
    Radcliffe
    M26 1GZ Manchester
    Geschäftsführer
    34 Clough Fold
    Radcliffe
    M26 1GZ Manchester
    UkBritish57327250001
    BLEASDALE, Kathleen Veronica
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish67650680001
    CARISS, John Stuart
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Cedars 3 Telegraph Cottage
    Warren Road
    KT2 7HU Kingston Upon Thames
    Surrey
    United KingdomBritish69554890001
    CHAPMAN, Clive Richard
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    Geschäftsführer
    Flat 1
    36 Oakley Street
    SW3 5NT London
    United KingdomBritish86129050001
    DURSTON, Robert
    13 Roundell Road
    BB18 6EB Barnoldswick
    Lancashire
    Geschäftsführer
    13 Roundell Road
    BB18 6EB Barnoldswick
    Lancashire
    British110017830001
    HALLIDAY, Steven Don
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Laneside Wallbank Road
    Bramhall
    SK7 3AP Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish61413670001
    KENNEALLY, Chris Martin
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    WalesBritish267876240001
    KIRKPATRICK, Steven William
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Northern IrelandNorthern Irish185295780002
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Geschäftsführer
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    British94546740001
    MARKS, Dorian Alan
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    Geschäftsführer
    The Old Stables
    Delph New Road
    OL3 5BA Dobcross
    Oldham
    British94546740001
    O'BRIEN, Fergal
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Irish78893160002
    O'BRIEN, Fergal
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Geschäftsführer
    79 Hermitage Road
    WA15 8BW Hale
    Cheshire
    Irish78893160002
    PERCIVAL, Lorraine Elizabeth
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    United KingdomBritish85413680001
    PILGRIM, Alan John Templer
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    44 Pepper Hill
    Great Amwell
    SG12 9RZ Ware
    Hertfordshire
    EnglandBritish11755290002
    PINDER, John Richard
    West Pelham
    Manor Park
    BR7 5QE Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    West Pelham
    Manor Park
    BR7 5QE Chislehurst
    Kent
    British78379030001
    ULLMANN, Jack Rainer
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritish11342820001
    ULLMANN, Marianne Flora
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Chevron House
    346 Long Lane
    UB10 9PF Hillingdon
    Middlesex
    EnglandBritish6228260001
    WILLIAMSON, Lynda
    277 Hardsough Lane
    Irwell Vale Ewood Bridge
    BL0 0QF Rossendale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    277 Hardsough Lane
    Irwell Vale Ewood Bridge
    BL0 0QF Rossendale
    Lancashire
    British39140490001
    WILLIAMSON, Mark
    94 Ringley Road
    Whitefield
    M45 7UV Manchester
    Geschäftsführer
    94 Ringley Road
    Whitefield
    M45 7UV Manchester
    British64862020001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Cordant Professional Staffing Limited
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    346
    England
    06. Apr. 2016
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    346
    England
    Nein
    RechtsformLimited Company
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEnglish
    RegistrierungsortUk Companies House
    Registrierungsnummer1397983
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.

    Hat CORDANT PROCUREMENT RECRUITMENT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 04. Juni 2015
    Geliefert am 12. Juni 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 3 of the debenture.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 19. März 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Juni 2015
    Geliefert am 12. Juni 2015
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 2 of the debenture.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 12. Juni 2015Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 02. Sept. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2011
    Geliefert am 28. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transaktionen
    • 28. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Sept. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 20. Mai 2011
    Geliefert am 27. Mai 2011
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Mai 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Sept. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Security accession deed to a debenture originally dated 14 june 2007 and
    Erstellt am 05. Aug. 2009
    Geliefert am 19. Aug. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties and from the chargors to rbs invoice finance limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, investments. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Aug. 2009Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Juni 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 05. Feb. 2007
    Geliefert am 16. Feb. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC (C/O the Royal Bank of Scotland PLC)
    Transaktionen
    • 16. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Aug. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 09. Dez. 2003
    Geliefert am 12. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company formerly known as premiere employment group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Jan. 2000
    Geliefert am 26. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transaktionen
    • 26. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit deed
    Erstellt am 30. Dez. 1999
    Geliefert am 15. Jan. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £25,041.60 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed
    Kurze Angaben
    The interest in the deposit account in which the initial deposit of £25,041.60 has been placed and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norscot Investments Limited
    Transaktionen
    • 15. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 18. Aug. 1999
    Geliefert am 25. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for the Securitybeneficiaries (As Defined)
    Transaktionen
    • 25. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Dez. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Aug. 1998
    Geliefert am 12. Aug. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 22. Dez. 1997
    Geliefert am 09. Jan. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Okt. 1993
    Geliefert am 08. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Rent deposit agreement
    Erstellt am 30. Okt. 1992
    Geliefert am 09. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 30/10/92
    Kurze Angaben
    £10,672.20.
    Berechtigte Personen
    • National and Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Jan. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Aug. 1992
    Geliefert am 24. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Davenham Trust PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0