ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02725154 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Bridge House, Outwood Lane Horsforth LS18 4UP Leeds |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| GOULDITAR NO. 226 LIMITED | 23. Juni 1992 | 23. Juni 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2007 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 2 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Nicholas Tetley Beazley am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Simon Philip Reiter am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mahboob Ali Merchant am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Fraser David Gregory am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mark Ellerby am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | Bupa House 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London | 107319700001 | |||||||
| BEAZLEY, Nicholas Tetley | Geschäftsführer | 15-19 Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House England | United Kingdom | British | 105797560001 | |||||
| ELLERBY, Mark | Geschäftsführer | Burton Grange Burton Leonard HG3 3SU Harrogate North Yorkshire | England | British | 40582650004 | |||||
| GREGORY, Fraser David | Geschäftsführer | 9 Nightingale Shott TW20 9SU Egham Berkshire | United Kingdom | British | 107664270001 | |||||
| MERCHANT, Mahboob Ali | Geschäftsführer | 28 Denham Road KT17 3AA Epsom Surrey | United Kingdom | British | 56732410001 | |||||
| REITER, Simon Philip | Geschäftsführer | Bloomsbury Way WC1A 2BA London Bupa House 15-19 England | United Kingdom | British | 135845570001 | |||||
| KING, Robert Frederick | Sekretär | 8 Prior Bolton Street Canonbury N1 2NX London | British | 10012650001 | ||||||
| MEENAGHAN, Evelyn Maria | Bevollmächtigter Sekretär | 48 Cedars Avenue E17 7QN London | British | 900001370001 | ||||||
| SLC REGISTRARS LIMITED | Sekretär | 42-46 High Street KT10 9QY Esher Surrey | 34893920001 | |||||||
| DALY, Geoffrey William Stuart | Geschäftsführer | Sixpenny Buckle Coldhouse Hill GU22 0QS Woking Surrey | United Kingdom | British | 19464860003 | |||||
| DAVIES, Julian Peter | Geschäftsführer | Timberlea, Warminster Road South Newton SP2 0QW Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 29367700001 | |||||
| DHANDSA, Narinder, Dr | Geschäftsführer | D102 Montevetro 100 Battersea Church Road Battersea SW11 3YL London | England | British | 115844000001 | |||||
| GRASSBY, Kevin Michael Peter | Geschäftsführer | 5 Campden Hill Court Campden Hill Road W8 7HX London | United Kingdom | British | 66022700002 | |||||
| KENT, Benjamin David Jemphrey | Geschäftsführer | Fernleigh Lodge Northchurch Common HP4 1LR Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 93897360003 | |||||
| SEATON, Stuart Neil | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 12 Priory Walk SW10 9SP London | United Kingdom | British | 900001360001 | |||||
| SINCLAIR BROWN, Frederick John | Geschäftsführer | Rudge House Itchel Lane Crondall GU10 5PR Farnham Surrey | United Kingdom | British | 8070730003 | |||||
| TAYLOR, Neil Robert | Geschäftsführer | Highfield Church Street HG5 8NR Goldsborough Knaresborough | United Kingdom | British | 62846800003 | |||||
| WALFORD, Arthur David | Geschäftsführer | 94 London Road HA7 4NS Stanmore Middlesex | United Kingdom | British | 6658190001 |
Hat ANS CONTRACT HEALTHCARE (HARTLEPOOL) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 09. Jan. 2004 Geliefert am 14. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest from time to time in and to the real property, the tangible moveable property, the accounts, the intellectual property, any goodwill and rights in relation to the uncalled capital of the company, the investments, the shares all dividends interest and other monies. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 2001 Geliefert am 11. Apr. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations of the company to the chargee or any of the other secured parties under the facilities or mezzanine loan facility | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge and assignment | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 19. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of charge all the agreement details of which are set out in the schedule and the benefit of the same.by way of assignment all moneys due or owing or from time to time becoming due to the company under the agreement.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 13. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Brierton lodge nursing home brierton lane hartlepool county of hartlepool t/n-CE132044. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 30. Apr. 1998 Geliefert am 07. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Dez. 1994 Geliefert am 28. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility agreement dated 23RD december 1994 and the deed (as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0