PILLAR RETAIL PARKS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePILLAR RETAIL PARKS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02725163
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PILLAR RETAIL PARKS LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich PILLAR RETAIL PARKS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PILLAR RETAIL PARKS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PARINV (QUEDGELEY) LIMITED12. Juli 199612. Juli 1996
    PILLAR (PRESTON) LIMITED11. Juni 199611. Juni 1996
    PARINV (QUEDGELEY) LIMITED21. Okt. 199221. Okt. 1992
    GOULDITAR NO. 230 LIMITED23. Juni 199223. Juni 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PILLAR RETAIL PARKS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für PILLAR RETAIL PARKS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 23. Juni 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Notification of Pillar Property Group Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    1 SeitenPSC02

    Beendigung der Bestellung von Philip John Martin als Geschäftsführer am 31. Okt. 2016

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Philip John Martin als Sekretär am 31. Okt. 2016

    1 SeitenTM02

    Ernennung von British Land Company Secretarial Limited als Sekretär am 31. Okt. 2016

    2 SeitenAP04

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2016

    13 SeitenAA

    legacy

    210 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    2 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital02. Aug. 2016

    Kapitalaufstellung am 02. Aug. 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Mr Charles John Middleton als Direktor am 13. Juli 2016

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Jonathan Charles Mcnuff als Direktor am 13. Juli 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2015

    14 SeitenAA

    legacy

    199 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Juni 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juni 2015

    Kapitalaufstellung am 23. Juni 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. März 2014

    15 SeitenAA

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT2

    legacy

    184 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE2

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 23. Juni 2014

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von PILLAR RETAIL PARKS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Sekretär
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer8992198
    187856670001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    MARTIN, Philip John
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    Sekretär
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    British35118050001
    MEENAGHAN, Evelyn Maria
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    Bevollmächtigter Sekretär
    48 Cedars Avenue
    E17 7QN London
    British900001370001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Geschäftsführer
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Geschäftsführer
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MARTIN, Philip John
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    United KingdomBritish35118050001
    MAXTED, Robert David
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    Geschäftsführer
    Vanhurst
    Thorncombe Street
    GU5 0ND Bramley
    Surrey
    British37177990001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Geschäftsführer
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    MOULD, Harold Raymond
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    Geschäftsführer
    40 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    EnglandBritish35576350006
    NEWNS, Christopher Paul
    Walden
    Beech Lane Jordans
    HP9 2SZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Walden
    Beech Lane Jordans
    HP9 2SZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish55765190002
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    SEATON, Stuart Neil
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    12 Priory Walk
    SW10 9SP London
    United KingdomBritish900001360001
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish73972350001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei PILLAR RETAIL PARKS LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Pillar Property Group Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06. Apr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortEngland & Wales
    Registrierungsnummer2570618
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat PILLAR RETAIL PARKS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A supplemental debenture between the chargor and the agent (as defined below) (the "prp supplemental debenture")
    Erstellt am 05. Nov. 2001
    Geliefert am 15. Nov. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Land lying to the west of coseley road bilston with f/h title no.WM586448 together with the mortgages and charges created by clause 2(a) of the prp supplemental debenture. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch(As Agent and Trustee for the Finance Parties (as Defined Below)
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplementary assignation of rents
    Erstellt am 25. Juni 2001
    Geliefert am 28. Juni 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of pillar retail parks limited and/or pillar kinnaird limited and/or any other obligor to the chargee as agent and trustee and/or to any other finance parties under or pursuant to the credit agreement (all terms as defined)
    Kurze Angaben
    Kinnaird park edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo- Und Vereinsbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 28. Juni 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture supplementing and amending the original debenture dated 16TH march 1998
    Erstellt am 16. Feb. 2001
    Geliefert am 07. März 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future liabilities of each obligor to each finance party under each finance document except for any obligation which, if it were so included would contravene section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    By way of a first legal mortgage the freehold land on the west side of cray avenue, st mary's cray, title number SGL34706. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft London Branch as Agent and Trustee for Thefinance Parties
    Transaktionen
    • 07. März 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Third party charge between the chargor, pillar parks limited and pillar retail parks limited and the facility agent
    Erstellt am 29. Sept. 2000
    Geliefert am 05. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (actual or contingent whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would contravene section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    F/H land on the northwest side of meadow lane nottingham k/a lady bay retail park t/no;-NT96348, property (f/h and l/h) k/a priory retail park colliers wood merton london SW129 and land and buildings on high street colliers wood merton london SW19 under t/no's;-SGL519078, SGL606267 SGL616963 SGL616769 and f/h land k/a kingsway retail park rochdale GM745712 together with all rental monies other monies and insurances in relation thereto and thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hvb Real Estate Capital Limited(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 05. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture supplementing and amended the original debenture dated 16TH march 2000
    Erstellt am 21. Juli 2000
    Geliefert am 31. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future liabilities of each obligor to each finance party under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would contravene section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    Land and buildings k/a 430 victoria road ruislip t/no;-AGL52910 and land and buildings on the south side of shakespeare road eastleigh t/no;-HP305281 together with additional property as defined in form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branchas Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transaktionen
    • 31. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 17TH july 2000 and
    Erstellt am 17. Juli 2000
    Geliefert am 28. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations monies and liabilities due by the company and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties on any account whatsoever including all obligations monies and liabilities due under or pursuant to the credit agreement dated 11TH march 1998
    Kurze Angaben
    The property known as feuhold interest kinnaird park, edinburgh. See ch microfiche or form 395 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaftas Agent and Trustee for Itself and the Other Finance Parties and the Banks Defined in the Credit Agreement ("the Agent")
    Transaktionen
    • 28. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 13. Juli 2000
    Geliefert am 21. Juli 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from pillar (fulham) limited (company no. 02850420) to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of the account of the company in the books of bank of scotland treasury services PLC bearing account no 353381 which account is blocked or designated as charged to the bank together with all interest and other amounts accruing on such sums.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 21. Juli 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 06. Apr. 2000
    Geliefert am 11. Apr. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined in the credit agreement) under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Two areas of f/h land adjacent to priory retail park colliers wood merton london SW19 and l/h land at colliers wood merton london SW19.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch(As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 20. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 10. Dez. 1999
    Geliefert am 17. Dez. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as defined in the credit agreement) under each finance document (as defined) and on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H and l/h property k/a priory retail park colliers wood merton london SW19 and land and buildings on high street colliers wood merton london SW19 t/nos: SGL519078 and SGL606267 .. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transaktionen
    • 17. Dez. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 28. Apr. 1999
    Geliefert am 07. Mai 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the each obligor to each finance party under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in this deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayeriche Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaftlondon Branch
    Transaktionen
    • 07. Mai 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 24. März 1999
    Geliefert am 13. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in this deed contravening section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    By way of a first legal mortgage interest in the property k/a 1 and 2 orpington retail park sevenoaks way orpington being part of t/n-SGL72896; by way of first fixed charge all plant and machinery book debts and other debts, goodwill and uncalled capital;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft(As Agent and Trustee for the Banks)
    Transaktionen
    • 13. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Jan. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 28. Okt. 1998
    Geliefert am 13. Nov. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    F/H property k/a kingsway retail park rochdale lancashire t/nos: GM745712 GM752127 and part t/no: GM451586.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypo-Und Vereinsbank Aktiengesellschaft (Formerly Known as Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft) as Agent and Trustee for the Finance Parties (as Defined) (the "Agent")
    Transaktionen
    • 13. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 01. Apr. 1998
    Geliefert am 03. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the company and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee (the agent) and/or the other finance parties (as defined in the credit agreement) under or pursuant to the credit agreement
    Kurze Angaben
    The company's right title & interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the leases of the subjects being units 1,2,3,4,5,6,7 & 8 and sub-stations at eastern industrial estate edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 6TH april 1998
    Erstellt am 30. März 1998
    Geliefert am 15. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations monies and liabilities due by the company and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties on any account whatsoever including all obligations monies and liabilities due under or pursuant to the credit agreement dated 11TH march 1998
    Kurze Angaben
    Eastern industrial estate newcraighall road edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of shares
    Erstellt am 16. März 1998
    Geliefert am 03. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the company and pillar (maidenhead) limited to the chargee under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Two ordinary shares of £1 each in parinv northern limited and all dividends paid or payable after the date of this mortgage on all or any of the shares all stocks shares securities rights moneys or property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Hypothekenbank (Actien-Gesellschaft)
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 16. März 1998
    Geliefert am 01. Apr. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Land lying to the south of stanley road cheadle hulme T.n GM391664 GM391674 and land lying to the east of earl road cheadle hulme t/n GM431729 and land and buildings on the east side of earl road cheadle hulme cheshire t/n GM559096. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft(Agent)
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. März 1999Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 12. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 16. März 1998
    Geliefert am 20. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee under or pursuant to the credit agreement, as said credit agreement may be properly and validly extended, amended, varied, supplemented, novated, restated, replaced or renewed from time to time and any finance document to as such in the credit agreement
    Kurze Angaben
    The company's right title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the leases of the subjects.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Agas Agent and Trustee for Itself and the Other Finance Parties (As Said Terms are Defined in Thecredit Agreement)
    Transaktionen
    • 20. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 16. März 1998
    Geliefert am 20. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due or to become due from the company, pillar kinnaird limited or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee as agent and trustee for itself and the other finance parties (as defined in the credit agreement) under the terms of the credit agreement
    Kurze Angaben
    The company's right title and interest in and to the rental income (as defined in the credit agreement) payable in respect of the lease dated 29TH october 1997 and 9TH january 1998 and the subjects at newcraighall road in the city of edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 20. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 17TH march 1998
    Erstellt am 11. März 1998
    Geliefert am 25. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations monies and liabilities including interest costs charges fees expenses and others due or that may become due by the company and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the agent and to any other finance party (as defined in the credit agreement)
    Kurze Angaben
    F/H kinnaird park edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag(As "Agent")
    Transaktionen
    • 25. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 17TH march 1998
    Erstellt am 11. März 1998
    Geliefert am 25. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All obligations monies and liabilities due or to become due from the company and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee and to any other finance party (as defined) on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Ground lying on the south side of newcraighall road formerly in the city of edinburgh. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag; As Agent and Trustee for Itself and the Otherfinance Parties (As Defined)
    Transaktionen
    • 25. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation of rents
    Erstellt am 08. Okt. 1997
    Geliefert am 15. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each "obligor") to the chargees under the terms of the credit agreement dated 29TH may 1997
    Kurze Angaben
    Various land in or about newcraighall road formerly the city of edinburgh disrtrict of lothian. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag(As Agent, Arranger and Counterparty for Itselfand the Other Finance Parties as Defined in Thecredit Agreement)
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 10 october 1997 and
    Erstellt am 08. Okt. 1997
    Geliefert am 15. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or any other obligor (as defined in the credit agreement) to the chargee as lender, arranger and agent and trustee for itself and for the other finance parties (as defined in the credit agreement, and their respective successors and assignees) on any account whatsoever and all monies due or to become due from each obligor to each finance party (as defined in the credit agreement) under or pursuant to a credit agreement dated 29TH may 1997 (as defined) as the same may be properly and validly extended, amended, varied, supplemented, novated, restated, replaced or renewed from time to time and each finance document (defined in the credit agreement) except for any obligation which if it were so included would result in the standard security contravening section 151 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    All and whole that area of ground lying on the south side of newcraighall road formerly in the city of edinburgh district of lothian region and now in the city of edinburgh council area; all and whole the irregularly shaped area of ground in the city parish of edinburgh and county of midlothian and all and whole that area of ground extending to six acres and fifty decimal or one-hundredth parts of an acre or thereby situated on the south side of newcraighall road which leads from edinburgh to musselburgh, for details of further property charged please refer to form M395. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. Juni 1997
    Geliefert am 11. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for the finance parties (as therein defined) on any account whatsoever and under each finance document (as defined)
    Kurze Angaben
    Subject to clause 17.10 (disposals) of the credit agreement each of: edinburgh fort retail park edinburgh and kinnaird park edinburgh. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken- Und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transaktionen
    • 11. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An assignation in security
    Erstellt am 25. Juni 1997
    Geliefert am 05. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or any other obligor as defined in the credit agreement dated 29 may 1997 and each finance document referred to as such in the gredit agreement to the chargee
    Kurze Angaben
    The companys whole rights and interest but not obligations or liabilities in terms of a purchase agreement between the company and nd properties inc dated 2ND and 5TH june 1997 as guaranteed by pillar property investments PLC as the said purchase agreement may be amended varied or novated from time to time.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag as Lender Arranger and Agent and Trustee for Itselfand for the Other Finance Parties (The Agent)
    Transaktionen
    • 05. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    An assignation of rents which was delivered and intimated on 25 june 1997 and
    Erstellt am 23. Juni 1997
    Geliefert am 05. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or pillar kinnaird limited and/or any other obligor under or pursuant to a credit agreement dated 29 may 1997 and any finance document referred to as such in the credit agreement to the chargee
    Kurze Angaben
    All right title and interest in the rental income in respect of the head lease of the subjects and the occupational sub-leases in respect of the interest as tenant under the head lease of the subjects (for definitions see paper apart). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag (As Agent Arranger and Counterparty for Itself Andthe Other Finance Parties as Defined in the Credit Agreement)
    Transaktionen
    • 05. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0