UKRD GROUP LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | UKRD GROUP LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02725453 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von UKRD GROUP LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich UKRD GROUP LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von UKRD GROUP LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| UK RADIO HOLDINGS LIMITED | 04. Nov. 1992 | 04. Nov. 1992 |
| PRINTRECORD LIMITED | 24. Juni 1992 | 24. Juni 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von UKRD GROUP LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für UKRD GROUP LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss der Tochtergesellschaft mit Prüfungsbefreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 12 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 46 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2020 bis 31. Dez. 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2019 | 38 Seiten | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 02. Okt. 2020
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 14. Sept. 2020
| 3 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
Zweite Einreichung einer Kapitalerklärung nach einer Aktienemission am 20. Aug. 2020
| 4 Seiten | RP04SH01 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Aug. 2020
| 4 Seiten | SH01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Laws Wenger als Geschäftsführer am 20. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Bauer Group Secretariat Ltd als Sekretär am 20. Aug. 2020 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Richard Preece als Geschäftsführer am 20. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Preece als Sekretär am 20. Aug. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 11 Seiten | MA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von UKRD GROUP LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAUER GROUP SECRETARIAT LTD | Sekretär | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England |
| 270106790001 | ||||||||||
| FORD, Deidre Ann | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | United Kingdom | British | 109666380002 | |||||||||
| KEENAN, Paul Anthony | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | England | British | 243390510001 | |||||||||
| VICKERY, Sarah Jane | Geschäftsführer | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House England | England | British | 119137220004 | |||||||||
| CLAYTON, Yvonne Lynn | Sekretär | South Bank 31a Woodland Avenue TR10 8PG Penryn Cornwall | British | 40640850001 | ||||||||||
| HUMM, Roger James | Sekretär | Dinghurst Road Churchill BS25 5PJ Winscombe Westfield Orchard Avon | British | 29914990003 | ||||||||||
| HYDE, Gerard Joseph | Sekretär | 74 South Audley Street W1Y 5FF London | British | 78298560002 | ||||||||||
| PREECE, Andrew | Sekretär | Carn Brea Studios Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Ukrd Group Limited Cornwall United Kingdom | 157611600001 | |||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| AARONSON, Glenn Hunter | Geschäftsführer | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | Netherlands | American | 129927520014 | |||||||||
| ANDERSON, Michael | Geschäftsführer | 40 Evans Street Bronte New South Wales 2024 Australia | Australian | 96506420001 | ||||||||||
| BENSON, Peter Michael | Geschäftsführer | Juli Garreta 22 Girona Catalonia 17002 Spain | Australian | 69167380004 | ||||||||||
| BICKMORE, Brian Lindsay | Geschäftsführer | 26a Lansell Road Toorak Melbourne 3142 Australia | Australia | Australian | 153909330001 | |||||||||
| BODDY, David James | Geschäftsführer | 7 The Sanctuary Parliament Square Westminster SW1P 3JS London | New Zealand | 30018020004 | ||||||||||
| BRUCE, David Kevin | Geschäftsführer | Rose Cottage Wanborough GU3 2JR Guildford Surrey | British | 37948150003 | ||||||||||
| DARCH, Jonathan Robert | Geschäftsführer | The Barn, Court Farm Station Road, Blagdon BS40 7TD Bristol Avon | England | British | 40673150002 | |||||||||
| EVERETT, Anthony David | Geschäftsführer | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall | England | British | 172501910001 | |||||||||
| FOO, Peter Edwin | Geschäftsführer | 460 Kangaroo Ground Warrandyte Road Kangaroo Ground Victoria 3097 Australia | Australian | 50668310001 | ||||||||||
| HANDLEY, Valerie Jayne | Geschäftsführer | Spring Cottage Stoney Bottom Grayshott GU26 6HN Hindhead Surrey | England | British | 44328220001 | |||||||||
| HASKELL, Mark John | Geschäftsführer | Manor Cottage Lower Netherton TQ12 4RL Newton Abbot Devon | British | 24095130004 | ||||||||||
| HASKELL, Mark John | Geschäftsführer | 1 Copperwood Close Ashburton TQ13 7JQ Newton Abbot Devon | British | 24095130003 | ||||||||||
| HEPBURN, John Keith | Geschäftsführer | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall | England | Canadian | 16344860001 | |||||||||
| HUMM, Roger James | Geschäftsführer | Dinghurst Road Churchill BS25 5PJ Winscombe Westfield Orchard Avon | England | British | 29914990003 | |||||||||
| HYDE, Gerard Joseph | Geschäftsführer | 74 South Audley Street W1Y 5FF London | British | 78298560002 | ||||||||||
| IBBOTSON, Peter Stamford | Geschäftsführer | Newnham Farm House OX10 8BW Wallingford Oxfordshire | British | 8069000001 | ||||||||||
| KITNEY, Stephen James | Geschäftsführer | Sunchyme15 Tongham Road Runfold GU10 1PH Farnham Surrey | British | 90188890001 | ||||||||||
| LAWLEY, Richard Henry John | Geschäftsführer | 3 Pine Bank GU26 6SR Hindhead Surrey | England | British | 83623820001 | |||||||||
| MCCGWIRE, Patrick Conor | Geschäftsführer | 76a Deodar Road SW15 2NJ London | British | 59628620001 | ||||||||||
| ORME, Simon Patrick | Geschäftsführer | 1 Aubrey Road W8 7JJ London | American | 39459500001 | ||||||||||
| PINCHAM, Roger James | Geschäftsführer | 7 The Postern Wood Street, Barbican EC2Y 8BJ London | United Kingdom | British | 16343790001 | |||||||||
| POWELL, Michael Leslie | Geschäftsführer | Nightingale Cottage Great Holt Old Lane Dockenfield GU10 4HQ Farnham Surrey | United Kingdom | British | 11273310001 | |||||||||
| PREECE, Andrew Richard | Geschäftsführer | Carn Brea Studios Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Ukrd Group Limited Cornwall United Kingdom | England | British | 158905700001 | |||||||||
| REDFARN, Stephen Charles | Geschäftsführer | Moray House PL20 6DF Yelverton Devon | United Kingdom | British | 75074990002 | |||||||||
| ROGERS, William James Gerald | Geschäftsführer | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall | England | British | 37957110009 | |||||||||
| SMALLWOOD, Trevor | Geschäftsführer | Barncoose Industrial Estate TR15 3RQ Redruth Carn Brea Studios Cornwall United Kingdom | United Kingdom | British | 1535550001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei UKRD GROUP LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Radio Limited | 31. März 2019 | Peterborough Business Park Lynch Wood PE2 6EA Peterborough Media House United Kingdom | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für UKRD GROUP LIMITED?
| Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
|---|---|---|
| 24. Juni 2017 | 31. März 2019 | Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt. |
Hat UKRD GROUP LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 01. Juni 2012 Geliefert am 07. Juni 2012 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deposit agreement | Erstellt am 06. Okt. 2008 Geliefert am 16. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben By way of first fixed charge all such rights to the repayment of the deposit as the depositor may have under the terms upon which the deposit was made. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 2006 Geliefert am 20. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over shares and memorandum of deposit | Erstellt am 02. Dez. 2002 Geliefert am 17. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and pirate to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All of the shares warrants coupons talons and/or intruments representing such shares and all cash securities dividends rights and other property all other property hereafter delivered to the security trustee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge | Erstellt am 09. Okt. 2002 Geliefert am 29. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £600,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All of its right title and interest in and to the shares (being all of the issued a ordinary shares and b ordinary shares of pirate fm limited) and all proceeds therefrom. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of deposit | Erstellt am 25. Sept. 2001 Geliefert am 04. Okt. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All deposits credited to account designation 10054572 with the bank and any deposit or account of any other currency. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Dez. 1999 Geliefert am 21. Dez. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage of shares | Erstellt am 30. Sept. 1994 Geliefert am 05. Okt. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company,previously known as UK radio holdings limited,to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 468,500 shares in the capital of cornwall independent radio limited with all dividends declared and all shares stocks securities rights or properties offered to shareholders. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 06. Sept. 1994 Geliefert am 22. Sept. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. Sept. 1992 Geliefert am 05. Okt. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 ref. M237C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0