THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED

THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02725522
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED?

    • (3650) /
    • (3663) /
    • (7499) /

    Wo befindet sich THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    DELOITTE LLP
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OFFERASSIST LIMITED24. Juni 199224. Juni 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis26. Sept. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Low Lane Horsforth Leeds West Yorkshire LS18 4ER am 16. Sept. 2010

    2 SeitenAD01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. Aug. 2010

    LRESSP

    Die Adresse der Registerinspektion wurde geändert

    2 SeitenAD02

    Jahresrückblick erstellt bis 24. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Juni 2010

    Kapitalaufstellung am 25. Juni 2010

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Anthony Thomas Oliver am 24. Juni 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Sept. 2009

    4 SeitenAA

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 27. Sept. 2008

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2007

    6 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2006

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Sept. 2005

    7 SeitenAA

    legacy

    8 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STILL, Richard Matthew
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    4 Southway
    Guiseley
    LS20 8HX Leeds
    West Yorkshire
    British71581460002
    AUSTIN, William Patrick John
    Red House
    The Common
    NG15 6QB Hucknall
    Nottingham
    Geschäftsführer
    Red House
    The Common
    NG15 6QB Hucknall
    Nottingham
    United KingdomBritish78656320001
    CHUBB, Deborah
    Draycott Mill Farm
    DE6 5GX Draycott In The Clay
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Draycott Mill Farm
    DE6 5GX Draycott In The Clay
    Derbyshire
    United KingdomBritish144604980001
    OLIVER, Anthony Thomas
    41 Desborough Crescent
    West Derby
    L12 7JT Liverpool
    Merseyside
    Geschäftsführer
    41 Desborough Crescent
    West Derby
    L12 7JT Liverpool
    Merseyside
    United KingdomBritish126525610001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    PARSONS, Keith Rowland
    19 Beaumont Close
    Keyworth
    NG12 5JJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Sekretär
    19 Beaumont Close
    Keyworth
    NG12 5JJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British3472170001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BLENKINSOP, Russell Charles Simon
    8 The Corner
    Lowdham
    NG14 7AE Nottingham
    Willow Cottage
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    8 The Corner
    Lowdham
    NG14 7AE Nottingham
    Willow Cottage
    Nottinghamshire
    EnglandBritish138056790001
    DANIELS, Colin
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Brooklands
    313 Batley Road
    WF2 0AP Wakefield
    West Yorkshire
    British1278190001
    HEALEY, Keith Stanley
    5 Smythson Drive
    Wollaton Village
    NG8 2NW Nottingham
    Geschäftsführer
    5 Smythson Drive
    Wollaton Village
    NG8 2NW Nottingham
    British89750880001
    JOHNSTON, Paul Robinson
    11 Birkdale Close
    Edwalton
    NG12 4FB Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    11 Birkdale Close
    Edwalton
    NG12 4FB Nottingham
    Nottinghamshire
    British18047430001
    JONES, John Graham
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lowick House
    41 Creskeld Lane Bramhope
    LS16 9EP Leeds
    West Yorkshire
    British35569170001
    MELLOR, David Glynn
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Fieldhead
    92 Victoria Road
    HX5 0QF Elland
    West Yorkshire
    EnglandBritish57198790001
    PARSONS, Keith Rowland
    19 Beaumont Close
    Keyworth
    NG12 5JJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    19 Beaumont Close
    Keyworth
    NG12 5JJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British3472170001
    WILSON, Richard
    Old Hall Farm Wyke Lane
    Farndon
    NG24 3SP Newark
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    Old Hall Farm Wyke Lane
    Farndon
    NG24 3SP Newark
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish48962380001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Hat THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Apr. 2002
    Geliefert am 10. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 21. Okt. 1994
    Geliefert am 01. Nov. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 30. Okt. 1992
    Geliefert am 10. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    As charge 1 (tc.M3)
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Senior Lenders and the Subordinated Lenders)
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A charge of patents
    Erstellt am 30. Okt. 1992
    Geliefert am 10. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    As charge 1 (tc M.3)
    Kurze Angaben
    All the inventions and patents listed in schedule 3 together with the full exclusive benefit (see form 395 and schedule attached).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC(As Security Trustee for the Senior Lenders and the Subordinated Lenders)
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trade marks mortgage
    Erstellt am 30. Okt. 1992
    Geliefert am 10. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due form bfm holdings limited to each of the senior facilities banks (as defined therein) and under the terms of the facilities agreement and all monies due or to become due from the company and bfm holdings or any other group company under the terms of the interest rate management arrangements and all monies due or to become due from the company and bfm holdings limited or any group company to the overdraft bank (as defined therein)under the terms of the overdraft facility and all monies due or to become due from bfm holdings limited to each of the subordinated lenders (as defined therein)under the terms of the subordinated loan agreement
    Kurze Angaben
    All the trade marks listed under its name in schedule 3 together with the goodwill of the business (see form 395 and schedule attached).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Senior Lenders and the Subordinated Lenders)
    Transaktionen
    • 10. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Jan. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat THE JUMPING BEAN COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. Aug. 2010Beginn der Liquidation
    01. Juni 2011Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Richard Frederick Day
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0