OPTRON HOLDING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameOPTRON HOLDING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02725981
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von OPTRON HOLDING LIMITED?

    • Großhandel mit elektronischen und Telekommunikationsgeräten und -teilen (46520) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich OPTRON HOLDING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O Mazars Llp Tower Brdige House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von OPTRON HOLDING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    AURIGA (EUROPE) LIMITED12. Feb. 201012. Feb. 2010
    AURIGA (EUROPE) PLC10. Feb. 201010. Feb. 2010

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von OPTRON HOLDING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2019

    Welche sind die letzten Einreichungen für OPTRON HOLDING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 SeitenLIQ13

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O Keens Shay Keens Mk Llp Sovereign Court 230 Upper Fifth Street Central Milton Keynes Bucks MK9 2HR United Kingdom zum Sovereign Court U230 Pper Fifth Street Central Milton Keynes Bucks MK9 2HR geändert

    2 SeitenAD02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ United Kingdom zum C/O Mazars Llp Tower Brdige House St Katharines Way London E1W 1DD am 24. Apr. 2020

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 01. Apr. 2020

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    8 SeitenLIQ01

    Beendigung der Bestellung von Keens Shay Keens (Nominees) Limited als Sekretär am 01. Apr. 2020

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Michael Christopher Bowers als Direktor am 10. Feb. 2020

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Kevin Gerald Hayden als Direktor am 10. Feb. 2020

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Joseph Edward Gallagher als Geschäftsführer am 10. Feb. 2020

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert Maxey Crowder als Geschäftsführer am 10. Feb. 2020

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2019

    14 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2019 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2018

    16 SeitenAA

    Notification of Optronics Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2017

    25 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8nd zum Davy Avenue Knowlhill Milton Keynes MK5 8HJ am 30. Okt. 2017

    1 SeitenAD01

    Notification of Optronics Limited as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    1 SeitenPSC02

    Bestätigungserklärung erstellt am 24. Juni 2017 mit Aktualisierungen

    8 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2016

    25 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name12. Sept. 2016

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 09. Sept. 2016

    RES15

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    1 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von OPTRON HOLDING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BOWERS, Michael Christopher
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    C/O Optron Holdings Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    C/O Optron Holdings Limited
    United Kingdom
    United KingdomAmerican257748550002
    HAYDEN, Kevin Gerald
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    C/O Optron Holdings Limited
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    C/O Optron Holdings Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish267145030001
    SENG, Kheng
    Tower Brdige House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    Geschäftsführer
    Tower Brdige House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    C/O Mazars Llp
    United KingdomSingaporean199936160001
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    British157947720001
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    British157947720001
    STONEHAM, Roy
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Sekretär
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    181763170001
    CFH COMPANY FORMATIONS LIMITED
    4 Cornwood House
    Weston Road
    GU31 4JF Petersfield
    Hampshire
    Sekretär
    4 Cornwood House
    Weston Road
    GU31 4JF Petersfield
    Hampshire
    28069290001
    KEENS SHAY KEENS (NOMINEES) LIMITED
    230 Upper Fifth Street
    MK9 2HR Central Milton Keynes
    Sovereign Court
    Bucks
    United Kingdom
    Sekretär
    230 Upper Fifth Street
    MK9 2HR Central Milton Keynes
    Sovereign Court
    Bucks
    United Kingdom
    RechtsformLIMITED
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageENGLAND & WALES
    189995630001
    REID & CO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    41052090008
    BISHOP, Andrew James
    19 Walton Road
    Walnut Tree
    MK7 7AG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    19 Walton Road
    Walnut Tree
    MK7 7AG Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish68652960002
    CROWDER, Robert Maxey
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    United StatesAmerican181743220001
    DOWNIE, Mike
    21 Leycester Road
    WA16 8QR Knutsford
    Cheshire
    Geschäftsführer
    21 Leycester Road
    WA16 8QR Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish88763870001
    EDWARDS, Phillip Llewellyn
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Geschäftsführer
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    WalesBritish191693810001
    GALLAGHER, Joseph Edward
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Knowlhill
    MK5 8HJ Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    United StatesAmerican160633500001
    GLADWELL, Ronald Thomas
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    United KingdomBritish29973390001
    GLADWELL, Ronald Thomas
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    United KingdomBritish29973390001
    GRILLO, Gianfranco
    Rustlings
    The Woodlands
    SL9 8DE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Rustlings
    The Woodlands
    SL9 8DE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandItalian69542290001
    GRILLO, Gianfranco
    Rustlings
    The Woodlands
    SL9 8DE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Rustlings
    The Woodlands
    SL9 8DE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandItalian69542290001
    HACKETT, Christopher
    76 Clare Gardens
    GU31 4UE Petersfield
    Hampshire
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    76 Clare Gardens
    GU31 4UE Petersfield
    Hampshire
    British900005630001
    HILL, Alison Jane
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Auriga Building
    Bucks
    Geschäftsführer
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Auriga Building
    Bucks
    British140191950001
    JARVIS PEARSON, Colin
    40 Tallis Lane
    Browns Wood
    MK7 8DZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    40 Tallis Lane
    Browns Wood
    MK7 8DZ Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British121672920001
    LIPSON, Graham Keith
    14 Bell Close
    Helmdon
    NN13 5UH Brackley
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    14 Bell Close
    Helmdon
    NN13 5UH Brackley
    Northamptonshire
    British41683080001
    LIPSON, Graham Keith
    14 Bell Close
    Helmdon
    NN13 5UH Brackley
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    14 Bell Close
    Helmdon
    NN13 5UH Brackley
    Northamptonshire
    British41683080001
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    EnglandBritish157947720001
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    EnglandBritish157947720001
    SENIOR, David Mark
    16 Southdown Drive
    SW20 8EZ London
    Geschäftsführer
    16 Southdown Drive
    SW20 8EZ London
    EnglandBritish98000850002
    SWANSON, Albert Louis
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Geschäftsführer
    Davy Avenue
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    UsaAmerican181742960001
    GLG ASSOCIATES LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    58606320001
    KEATS CONSULTANTS LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    41994070001
    REID & CO CORPORATE SERVICES LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    59541290001
    RTG CONSULTANTS LIMITED
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Martins Cottage
    Brook
    SO43 7HE Lyndhurst
    Hampshire
    44937120001
    TREVOR KIDD CONSULTANTS LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    77633710002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei OPTRON HOLDING LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Optronics Limited
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    Knowlhill
    MK5 8ND Milton Keynes
    Davy Avenue
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited
    RechtsgrundlageEngland & Wales
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat OPTRON HOLDING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Erstellt am 16. Okt. 2012
    Geliefert am 18. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts including associated rights relating thereto.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 21. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Erstellt am 16. Okt. 2012
    Geliefert am 18. Okt. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transaktionen
    • 18. Okt. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 02. Juli 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal assignment of contract monies
    Erstellt am 09. Aug. 2012
    Geliefert am 10. Aug. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Aug. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 05. Jan. 2012
    Geliefert am 07. Jan. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Jan. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 12. Aug. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Sept. 2003
    Geliefert am 10. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage and otherwise by way of fixed charge the land in davy avenue knowlhill milton keynes (to the full extent of the mortgagor's interest in the property or its proceeds of sale). By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of covenant
    Erstellt am 30. Sept. 2003
    Geliefert am 10. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1 together with all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    1.27 acres of land at knowlhill milton keynes.
    Berechtigte Personen
    • Commission for the New Towns
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Deed of legal charge
    Erstellt am 26. Sept. 2001
    Geliefert am 03. Okt. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee including but not limited to a loan of £1,300,000
    Kurze Angaben
    Land at davey avenue knowlhill milton keynes (site r) containing an area of one decimal point two seven acres or thereabouts and all fixtures and fittings fixed plant and machinery. By way of first floating charge all its undertaking and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 31. Aug. 2001
    Geliefert am 08. Sept. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the financing agreement (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited (The "Securityholder")
    Transaktionen
    • 08. Sept. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Assignment and charge
    Erstellt am 14. Aug. 2001
    Geliefert am 28. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee (the "secured party") pursuant to the terms of an advice of borrowing terms dated 27TH april 2001 on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the chargor's right in the building contract. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 14. Aug. 2001
    Geliefert am 18. Aug. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Jan. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Fixed charge over book debts
    Erstellt am 16. Sept. 1998
    Geliefert am 22. Sept. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the charged asets being all monies payable to the company and all other rights under a business finance agreement between the company and chargee together with all debts arising from the sale of goods the subject thereof together with any right title property or interest of the company in or to the goods to which a debt relatesand all related rights thereto and thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Nmb-Heller Limited
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 29. Nov. 1996
    Geliefert am 03. Dez. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge on all book and other debts and by way of floating charge on all proceeds of book debts present & future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alex. Lawrie Receivables Financing Limited
    Transaktionen
    • 03. Dez. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture deed
    Erstellt am 11. Sept. 1996
    Geliefert am 23. Sept. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Sept. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 08. Jan. 1996
    Geliefert am 15. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or fibrefab limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Okt. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 22. Sept. 1992
    Geliefert am 09. Okt. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    All right title and interest of the company ir or arising out of a factoring or invoice discounting deed dated 14/8/92 and any deed amending or replacing the same (the charged deeds) and all book debts and other debts the subject of the charged deeds as and when the same shall become due or owing to the company upon revesting in the company whether pursuant to the charged deeds or otherwise (for full details see form 395 tc ref: M277C).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Okt. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 11. Aug. 1992
    Geliefert am 19. Aug. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Aug. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat OPTRON HOLDING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Apr. 2020Beginn der Liquidation
    06. Feb. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Simon David Chandler
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Praktiker
    Tower Bridge House St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Guy Robert Thomas Hollander
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London
    Praktiker
    Tower Bridge House St Katharine S Way
    E1W 1DD London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0