BBM SIXTY-FIVE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBBM SIXTY-FIVE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02727698
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BBM SIXTY-FIVE LIMITED?

    • (9305) /

    Wo befindet sich BBM SIXTY-FIVE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BBM SIXTY-FIVE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    INSIDE RIGHT LIMITED06. Juli 199306. Juli 1993
    MERONBURG ESTATES LIMITED01. Juli 199201. Juli 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BBM SIXTY-FIVE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für BBM SIXTY-FIVE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 28. Feb. 2011

    18 Seiten2.35B

    Vorschlag des Verwalters

    38 Seiten2.17B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Nov. 2009

    16 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Nov. 2010

    17 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Mai 2010

    19 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 11 st Jamess Square Manchester M2 6DN am 28. Juni 2010

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 26. Mai 2009

    16 Seiten2.24B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    10 Seiten2.16B

    legacy

    1 Seiten288c

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed inside right LIMITED\certificate issued on 11/12/08
    2 SeitenCERTNM

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten225

    legacy

    5 Seiten363a

    Konzernabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2007

    36 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288c

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    3 Seiten363a

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Redes shares/cancel red 27/10/04
    RES13

    Beschlüsse

    Resolutions
    SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Aufhebung der Bezugsrechte

    RES11

    Beschlüsse

    Resolutions
    22 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Wer sind die Geschäftsführer von BBM SIXTY-FIVE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    DUNLOP, Gail Deborah
    45 The Avenue
    EN6 1ED Potters Bar
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    45 The Avenue
    EN6 1ED Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director2464520001
    DUNLOP, Michelle Deborah
    Egerton Drive
    Hale
    WA15 8EF Altrincham
    9
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Egerton Drive
    Hale
    WA15 8EF Altrincham
    9
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDesigner85378700003
    HEATH, Duncan Nigel
    55 Arlington Way
    Meir Park
    ST3 7WH Stoke On Trent
    Geschäftsführer
    55 Arlington Way
    Meir Park
    ST3 7WH Stoke On Trent
    EnglandBritishContracts Director65899960002
    MOUNTFORD, Steven
    195 Bellerton Lane
    ST6 8BF Stoke On Trent
    Geschäftsführer
    195 Bellerton Lane
    ST6 8BF Stoke On Trent
    United KingdomBritishInstallations Director75185410002
    PAGETT, Michael Dennis
    The Heyes
    Eaton Upon Tern
    TF9 2BX Market Drayton
    Shropshire
    Geschäftsführer
    The Heyes
    Eaton Upon Tern
    TF9 2BX Market Drayton
    Shropshire
    EnglandBritishChartered Accountant70944940002
    BRITTON, Carolanne Sheila
    Galton Croft
    Blythe Bridge
    ST11 9TQ Stoke-On-Trent
    5
    United Kingdom
    Sekretär
    Galton Croft
    Blythe Bridge
    ST11 9TQ Stoke-On-Trent
    5
    United Kingdom
    BritishAccounts Director/General Mana94422150002
    CHANDLER, Kim
    49 Deans Croft
    SG3 6BD Knebworth
    Hertfordshire
    Sekretär
    49 Deans Croft
    SG3 6BD Knebworth
    Hertfordshire
    BritishProduction Director43091760001
    DUFFY, Jeremy David Stuart
    Parkside Lodge
    Ivetsey Road
    ST19 9QP Wheaton Aston
    Staffordshire
    Sekretär
    Parkside Lodge
    Ivetsey Road
    ST19 9QP Wheaton Aston
    Staffordshire
    BritishAccountant85314100001
    GARDNER, Trena Margaret
    92 Lightwood Road
    Longton
    ST3 4JF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    92 Lightwood Road
    Longton
    ST3 4JF Stoke On Trent
    Staffordshire
    British29684130001
    MARTIN, Anthony Robert
    7 Woodlands Park
    SS9 3TX Leigh On Sea
    Essex
    Sekretär
    7 Woodlands Park
    SS9 3TX Leigh On Sea
    Essex
    British31173980001
    RATCLIFFE, Paul
    Cliffe Cottage Knowle Wall
    Beech
    ST4 8SE Stoke On Trent
    Staffordshire
    Sekretär
    Cliffe Cottage Knowle Wall
    Beech
    ST4 8SE Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director17355830001
    L & A SECRETARIAL LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Sekretär
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001450001
    BRITTON, Carolanne Sheila
    Galton Croft
    Blythe Bridge
    ST11 9TQ Stoke-On-Trent
    5
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Galton Croft
    Blythe Bridge
    ST11 9TQ Stoke-On-Trent
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccounts Director/General Mana94422150002
    DUFFY, Jeremy David Stuart
    Parkside Lodge
    Ivetsey Road
    ST19 9QP Wheaton Aston
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Parkside Lodge
    Ivetsey Road
    ST19 9QP Wheaton Aston
    Staffordshire
    BritishAccountant85314100001
    GODFREY, Paul Edmund
    Silver Birches Heath Road
    Whitmore Heath
    ST5 5HB Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Silver Birches Heath Road
    Whitmore Heath
    ST5 5HB Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    BritishSolicitor6712630001
    JACKSON, Mickhala Marcia
    7 Oak Drive
    Scholar Green
    ST7 3LY Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    7 Oak Drive
    Scholar Green
    ST7 3LY Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritishAccountant78133050003
    MARTIN, Anthony Robert
    7 Woodlands Park
    SS9 3TX Leigh On Sea
    Essex
    Geschäftsführer
    7 Woodlands Park
    SS9 3TX Leigh On Sea
    Essex
    BritishCompany Director (Retired)31173980001
    NAYLOR, Terence Arthur
    4 Inglewood Grove
    ST5 0DZ Newcastle
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    4 Inglewood Grove
    ST5 0DZ Newcastle
    Staffordshire
    BritishSales Director65900000003
    RATCLIFFE, Paul
    Cliffe Cottage Knowle Wall
    Beech
    ST4 8SE Stoke On Trent
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Cliffe Cottage Knowle Wall
    Beech
    ST4 8SE Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director17355830001
    SUMMERFIELD, Jacqueline Anne
    88a Hillcrest Rise
    LS16 7DL Leeds
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    88a Hillcrest Rise
    LS16 7DL Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishDesign Director126506080001
    L & A REGISTRARS LIMITED
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    31 Corsham Street
    N1 6DR London
    900001440001

    Hat BBM SIXTY-FIVE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    All asset debenture
    Erstellt am 05. Sept. 2006
    Geliefert am 06. Sept. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Berechtigte Personen
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transaktionen
    • 06. Sept. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Aug. 2005
    Geliefert am 02. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 2005
    Geliefert am 02. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H unit 2 rosevale road rosevale business park newcastle staffs t/n SF432224. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 01. Aug. 2005
    Geliefert am 02. Aug. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H unit 5 kelvin business centre 8 kelvin way crawley t/n WSX141300. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 29. Juni 2005
    Geliefert am 19. Juli 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A fixed charge over all book debts and other debts revenues and claims present future and contingent due or owing to or which may become due or owing and the proceeds of realisation of the same and the full benefit of all rights and remedies relating thereto.
    Berechtigte Personen
    • Aib Group (UK) PLC
    Transaktionen
    • 19. Juli 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 2005
    Geliefert am 03. Feb. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property k/a 5 kelvin business park centre, 8 kelvin way crawley west sussex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 02. Okt. 2000
    Geliefert am 10. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The freehold property known as unit 2 rosevale business park parkhouse industrial estate newcastle under lyme hmlr title number part of SF314314. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Jan. 1999
    Geliefert am 14. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land and buildings at woodhouse street maclagan street stoke on trent staffordshire t/n-SF234767.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 01. Jan. 1999
    Geliefert am 11. Jan. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Aug. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Floating charge
    Erstellt am 13. März 1995
    Geliefert am 22. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    And rights present and future. Undertaking and all property and assets.
    Berechtigte Personen
    • Paul Ratcliffe
    • Gail Deborah Dunlop
    Transaktionen
    • 22. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 21. Feb. 1994
    Geliefert am 23. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Mai 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BBM SIXTY-FIVE LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    27. Nov. 2008Beginn der Verwaltung
    28. Feb. 2011Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Andrew Gordon Stoneman
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Praktiker
    43-45 Portman Square
    W1H 6LY London
    Stephen Gerard Clancy
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    Praktiker
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0