LANDGUARD INTERNATIONAL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LANDGUARD INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 02729850 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LANDGUARD INTERNATIONAL LIMITED?
- Güterkraftverkehr (49410) / Verkehr und Lagerei
Wo befindet sich LANDGUARD INTERNATIONAL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Maritime Centre Port Of Liverpool L21 1LA Liverpool Merseyside |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LANDGUARD INTERNATIONAL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SUMMIT INTERNATIONAL TRANSPORT LIMITED | 20. Mai 1996 | 20. Mai 1996 |
| FANTASY FREIGHT LIMITED | 19. Aug. 1992 | 19. Aug. 1992 |
| WADSTOCK LIMITED | 09. Juli 1992 | 09. Juli 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LANDGUARD INTERNATIONAL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LANDGUARD INTERNATIONAL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Graeme Lloyd Charnock als Direktor am 30. Nov. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Barr als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Mark Whitworth am 19. Jan. 2011 | 3 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Whitworth als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2010 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Thomas Eardley Allison als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Baxter als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Carl Day als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2009 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Stephen Roy Baxter am 25. Nov. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 4 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LANDGUARD INTERNATIONAL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRISON GILL, Caroline Ruth | Sekretär | 113 Tarvin Road Littleton CH3 7DE Chester Woodleigh Cheshire | Other | 140064590001 | ||||||
| ALLISON, Thomas Eardley | Geschäftsführer | 23 Park Place FK7 9JR Stirling Rockdale Lodge Scotland Scotland | Scotland | British | 1037730004 | |||||
| CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd | Geschäftsführer | Holly Bank Drive HX3 8PA Halifax Woodcote West Yorkshire United Kingdom | England | British | 165341530001 | |||||
| WHITWORTH, Mark | Geschäftsführer | Culvert Lane Off Back Lane WN8 7XA Newburgh Springside Lancashire | England | British | 120679580002 | |||||
| BOWLEY, William John | Sekretär | 17 St Georges Road Formby L37 3HH Liverpool Merseyside | British | 4171240002 | ||||||
| HUNWICKE, Catherine Doris | Sekretär | 8 St Edmunds Road IP11 2DJ Felixstowe Suffolk | British | 71755820001 | ||||||
| HUNWICKE, Richard George | Sekretär | 8 St Edmunds Road IP11 2DJ Felixstowe Suffolk | British | 71460100001 | ||||||
| NOMINEE SECRETARIES LTD | Bevollmächtigter Sekretär | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006780001 | |||||||
| BARR, Alan Andrew | Geschäftsführer | 7 Wellington Terrace ML11 7QQ Lanark Lanarkshire | Scotland | British | 121452150001 | |||||
| BAXTER, Stephen Roy | Geschäftsführer | Springkell Avenue Pollokshields G41 4EH Glasgow 94 United Kingdom | Scotland | British | 86622660005 | |||||
| DAY, Carl Peter John | Geschäftsführer | 5 Meadow Crescent Purdis Farm IP3 8GD Ipswich Suffolk | England | British | 98935260001 | |||||
| FINDLAY, Alastair Ian | Geschäftsführer | High Billinge House Utkinton CW6 0LA Tarporley Cheshire | United Kingdom | British | 30045540003 | |||||
| GREEN, David Simon | Geschäftsführer | 16a Inverleith Row EH3 5LS Edinburgh | British | 42038120003 | ||||||
| HUNT, Peter John | Geschäftsführer | 9 Spire Chase CO10 1PZ Sudbury Suffolk | British | 85764400001 | ||||||
| HUNWICKE, Catherine Doris | Geschäftsführer | 8 St Edmunds Road IP11 2DJ Felixstowe Suffolk | British | 71755820001 | ||||||
| HUNWICKE, Richard George | Geschäftsführer | 8 St Edmunds Road IP11 2DJ Felixstowe Suffolk | British | 71460100001 | ||||||
| RUTHERFORD, Brian | Geschäftsführer | 19 Norway Crescent Valleyside Dovercourt CO12 4JT Harwich Essex | British | 2390500001 | ||||||
| SCOTT, Peter Anthony | Geschäftsführer | 6 Bowling Green Way Bamford OL11 5QQ Rochdale Lancashire | British | 1674500002 | ||||||
| WHARTON, Kenneth John | Geschäftsführer | Cornercroft 7 Glendyke Road L18 6JR Liverpool Merseyside | British | 9964160002 | ||||||
| NOMINEE DIRECTORS LTD | Bevollmächtigter Geschäftsführer | 197-199 City Road EC1V 1JN London | 900001340001 |
Hat LANDGUARD INTERNATIONAL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security deed of accession | Erstellt am 28. Feb. 2007 Geliefert am 13. März 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 30. März 2006 Geliefert am 06. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee (whether for its own account or as security trustee for the secured parties) or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 25. Sept. 1999 Geliefert am 09. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 09. Aug. 1996 Geliefert am 12. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge on all book debts the subject of an agreement for the factoring or discounting of book debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0