CIBC WORLD MARKETS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCIBC WORLD MARKETS LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02733036
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    • Banken (64191) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O INTERPATH LTD
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CIBC WORLD MARKETS PLC28. Apr. 199928. Apr. 1999
    CIBC WOOD GUNDY PLC24. Nov. 199524. Nov. 1995
    CIBC BANK PLC02. Nov. 199202. Nov. 1992
    STOCKCAPITAL PUBLIC LIMITED COMPANY21. Juli 199221. Juli 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Okt. 2021
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am31. Juli 2022
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2020

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis27. Okt. 2021
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung10. Nov. 2021
    Letzte Bestätigungsbescheinigung
    Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis27. Okt. 2020
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Feb. 2025

    21 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Feb. 2024

    23 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Feb. 2023

    24 SeitenLIQ03

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    104 SeitenLIQ10

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fleet Place London EC4M 7QS zum 10 Fleet Place London EC4M 7RB am 04. Juli 2022

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Feb. 2022

    12 SeitenLIQ03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 15 Canada Square London E14 5GL zum 10 Fleet Place London EC4M 7QS am 14. Dez. 2021

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    42 Seiten600

    Rücktritt eines Liquidators

    3 SeitenLIQ06

    Zweite Einreichung für die Ernennung von Mr Wayne Lee zum Geschäftsführer

    6 SeitenRP04AP01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    7 SeitenLIQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 150 Cheapside London EC2V 6ET zum 15 Canada Square London E14 5GL am 18. Feb. 2021

    2 SeitenAD01

    Beendigung der Bestellung von Carla Craig als Sekretär am 04. Feb. 2021

    2 SeitenTM02

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 04. Feb. 2021

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Marshall Charles Bailey als Geschäftsführer am 31. Dez. 2020

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2020

    117 SeitenAA

    Erfüllung der Belastung 14 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 13 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 9 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 2 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 3 vollständig

    2 SeitenMR04

    Bestätigungserklärung erstellt am 27. Okt. 2020 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Wer sind die Geschäftsführer von CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ATKINSON, Paul David
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    Geschäftsführer
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    EnglandBritish193722190001
    CLIMO, Donald Christopher Bryce
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    Geschäftsführer
    Fleet Place
    EC4M 7RB London
    10
    CanadaCanadian241500930001
    FOREMAN-PURVES, Meghan Alice
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomBritish,Australian260945620002
    LEE, Wayne
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomCanadian250441360001
    AUSTIN, David Richard
    5 Widford Hill
    Widford
    SG12 8SW Ware
    Hertfordshire
    Sekretär
    5 Widford Hill
    Widford
    SG12 8SW Ware
    Hertfordshire
    British56913080001
    BASHFORTH, Jonathan Howie
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Sekretär
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    164968080001
    CRAIG, Carla
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Sekretär
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    256435170001
    HOURIGAN, Louise Frances
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Sekretär
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    203782990001
    PURVES, Meghan
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Sekretär
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    214607900001
    SCOTT, Angus George James
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Sekretär
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    British74173430002
    SORRELL, David John
    12 Ruskin Road
    DA17 5BB Belvedere
    Kent
    Sekretär
    12 Ruskin Road
    DA17 5BB Belvedere
    Kent
    British7749400001
    TANNA, Shashi
    16 Southfield Way
    AL4 9JJ St Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    16 Southfield Way
    AL4 9JJ St Albans
    Hertfordshire
    Uk1515730001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, David Richard
    5 Widford Hill
    Widford
    SG12 8SW Ware
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    5 Widford Hill
    Widford
    SG12 8SW Ware
    Hertfordshire
    British56913080001
    BAILEY, Marshall Charles
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomBritish187892510002
    BUCKLEY, David
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomBritish214028790001
    COHEN, Graham John
    48 Melody Road
    Wandsworth
    SW18 2QF London
    Geschäftsführer
    48 Melody Road
    Wandsworth
    SW18 2QF London
    UkAustralian42403580001
    CORNFORD, Michael
    Hunsdonbury
    Hunsdon
    SG12 8PW Ware
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Hunsdonbury
    Hunsdon
    SG12 8PW Ware
    Hertfordshire
    British43733590001
    CRADDOCK, Geoffrey James
    Stepping Stone Lane
    CT 06830 Greenwich
    11
    Connecticut
    Usa
    Geschäftsführer
    Stepping Stone Lane
    CT 06830 Greenwich
    11
    Connecticut
    Usa
    Dual Uk/Us128677580001
    DE GIORGIO-MILLER, Joseph
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    EnglandBritish104947380002
    DENHAM, Gillian Helen
    42 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PE London
    Geschäftsführer
    42 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PE London
    Canadian45518860001
    DENHAM, Gillian Helen
    42 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PE London
    Geschäftsführer
    42 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PE London
    Canadian45518860001
    DLUGAN, Dennis
    21 Overlea Blvd
    Unit 1703
    M4H 1P2 Toronto
    Ontaria
    Canada
    Geschäftsführer
    21 Overlea Blvd
    Unit 1703
    M4H 1P2 Toronto
    Ontaria
    Canada
    Canadian86374670001
    DODIG, Edward
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    United KingdomCanadian163882730001
    DORAN, John
    2270 Saxony Court
    FOREIGN Mississauga
    Ontario L5h 4b5
    Canada
    Geschäftsführer
    2270 Saxony Court
    FOREIGN Mississauga
    Ontario L5h 4b5
    Canada
    Canadian18251240001
    ELLEN, Simon Tudor
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    Geschäftsführer
    Sbj Ltd
    100 Whitechapel Road
    E1 1JG London
    United KingdomBritish111926600001
    FERGUSON, Daniel Stanley
    Four Winds Old Avenue
    KT13 0QB Weybridge
    Surrey
    Geschäftsführer
    Four Winds Old Avenue
    KT13 0QB Weybridge
    Surrey
    Canadian17148400002
    GERBER, Chuck
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    UsaUsa152590660001
    HAYES, Derek Cumberland
    287 Erskine Avenue
    Toronto
    M4P 1Z6 Ontario
    Canada
    Geschäftsführer
    287 Erskine Avenue
    Toronto
    M4P 1Z6 Ontario
    Canada
    Canadian45821740001
    HOURIGAN, Louise Frances
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    United KingdomBritish191119100001
    HUGHES, Simon Philip Griffith
    52 Ringmer Avenue
    SW6 5LW London
    Geschäftsführer
    52 Ringmer Avenue
    SW6 5LW London
    United KingdomBritish100548100001
    INSKIP, Cliff
    Ballards Mead Ballards Lane
    Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    Geschäftsführer
    Ballards Mead Ballards Lane
    Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    Canadian31785020001
    KELLY, Tom
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    Geschäftsführer
    Cheapside
    EC2V 6ET London
    150
    England
    IrelandIrish165532010001
    KENYON, Andrew Graham
    Suite 503
    50 Old Mill Road
    Oakville
    L6j 7w1
    Canada
    Geschäftsführer
    Suite 503
    50 Old Mill Road
    Oakville
    L6j 7w1
    Canada
    Canadian70849700002
    KILGOUR, Peter Kenneth
    78 Thorncrest Road
    Toronto
    Ontario
    M9a 1s9
    Canada
    Geschäftsführer
    78 Thorncrest Road
    Toronto
    Ontario
    M9a 1s9
    Canada
    Canadian122850930001

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für CIBC WORLD MARKETS LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    27. Okt. 2016Das Unternehmen weiß oder hat Grund zu der Annahme, dass es keine registrierungspflichtige Person oder registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen gibt.

    Hat CIBC WORLD MARKETS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Registered definitive note (the "note") executed by cibc world markets PLC (the "company") and r+v lebensversicherung ag (the "noteholder"),pursuant to which the company with full title guarantee has assigned by way of security in favour of the noteholder
    Erstellt am 01. Okt. 1999
    Geliefert am 19. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the company's rights,title and interest in and to the underlying asset (as defined in the note) (including all rights in respect thereof or relating thereto (whether or not against third parties)) as security for all the monies and other liabilities payable or owing by the company under the note,
    Kurze Angaben
    All rights,title and interest in and to the underlying asset,as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • R + V Lebensversicherung Ag
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Dez. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Registered definitive note (the "note") executed by cibc world markets PLC (the "company") and r+v lebensversicherung ag (the "noteholder"),pursuant to which the company with full title guarantee has assigned by way of security in favour of the noteholder
    Erstellt am 01. Okt. 1999
    Geliefert am 19. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the company's rights,title and interest in and to the underlying asset (as defined in the note) (including all rights in respect thereof or relating thereto (whether or not against third parties)) as security for all the monies and other liabilities payable or owing by the company under the note,
    Kurze Angaben
    All rights,title and interest in and to the underlying asset (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • R + V Lebensversicherung Ag
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Dez. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered definitive note (the "note")
    Erstellt am 22. Sept. 1999
    Geliefert am 13. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the note
    Kurze Angaben
    First fixed security in favour of the noteholder all the company's right title and interest in and to the underlying assets (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • R & V Lebensversicherung Ag
    Transaktionen
    • 13. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Feb. 2011Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 31. Dez. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over securities
    Erstellt am 30. Sept. 1998
    Geliefert am 08. Okt. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee (the bank) arising out of transactions between the bank and the company in connection with the cgo and all monies due under the charge
    Kurze Angaben
    All eligible stock held by or on behalf of or for the account of the company in the cgo and all and any property rights or interests of the company in or rights of the company to eligible stock in the cgo. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Okt. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Juli 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge and assignment
    Erstellt am 31. Juli 1998
    Geliefert am 13. Aug. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement or under the structured notes (as defined in the charge)
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the principal protected notes and in and to the guaranty. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Alternative Management Company S.A.(On Behalf of Alternative Leadership Fund Innovation)
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Registered definitive note representing DEM15,000,000 12.4 per cent. Secured amortising note due 2015 (the note) executed by the company and deutscher ring versicherungen (the noteholder)
    Erstellt am 13. März 1998
    Geliefert am 25. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All the moneys and other liabilities payable or owing by the company under the note
    Kurze Angaben
    All the company's rights title and interest in and to the swap transaction including the benefit of the security therefor over the underlying assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutscher Ring Versicherungen
    Transaktionen
    • 25. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust deed
    Erstellt am 06. Feb. 1998
    Geliefert am 25. Feb. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The dem 50,000,000 floating rate secured notes due 2005 pursuant to which the company with full title guarantee has in the trust deed assigned by way of security in favour of the trustee (I) all the company's rights,title and interest in and to the swap transaction (as defined in the trust deed) (including the benefit of the security therefore over the underlying assets (as defined in the trust deed) and (ii) all the company's rights ,title and interest in and to the custody agreement (as defined in the trust deed) and the obligations of the custodian (as define in the trust deed) represented thereby as security for all the moneys and other liabilities payable or owing by the company under the trust deed
    Kurze Angaben
    All its rights title and interest in and to the swap transaction (as defined) the custody agreement (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc Mellon Trust Company(As Trustee)
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    A registered definitive note (the "note")
    Erstellt am 01. Dez. 1997
    Geliefert am 08. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the note (as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's rights, title and interest in and to the swap transaction (as defined) (including the benefit of the security therfor over the underlying assets (as defined in the schedule)).
    Berechtigte Personen
    • R+V Lebensverischerung Ag
    Transaktionen
    • 08. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Declaration of pledge of securities and claims to guarantor by the pledgor accepted by cedel bank on behalf of the guarantor
    Erstellt am 25. Nov. 1997
    Geliefert am 04. Dez. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A.and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A.banque generale du luxembourg S.A.banque internationale a luxembourg S.A.credit commercial de france kredietbank N.V.kredietbank S.A.luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time (the rules)
    Kurze Angaben
    All present and future securities, bonds, notes, certificates of deposit, instruments or rights representing property rights or claims (including a right not represented by a writing) as well as other debentures which may be pledged in the same form as securities according to luxembourg law ("securities"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Guarantor; Being a Syndicate of Banks Whose Lead Bank is Citibank N.A. Brussels Branch
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Declaration of pledge of securities and claims to guarantor by the pledgor accepted by cedel bank on behalf of the guarantor
    Erstellt am 25. Nov. 1997
    Geliefert am 04. Dez. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All present and future obligations of the pledgor to the guarantor (a syndicate of banks whose lead bank is citibank N.A.and whose members as at the date of this certificate include banque bruxelles lambert S.A.banque generale du luxembourg S.A.banque internationale a luxembourg S.A.credit commercial de france kredietbank N.V.kredietbank S.A.luxemburgeoise union bank of switzerland and whose composition may periodically change) arising from its guarantee of the pledgor's borrowings of securities arranged under the cedel securities lending and borrowing rules and regulations of march 1997 as amended from time to time 9THE rules)
    Kurze Angaben
    All present and future securities, bonds, notes, certificates of deposit, instruments or rights representing property rights or claims (including a right not represented by a writing) as well as other debentures which may be pledged in the same form as securities according to luxembourg law ("securities"). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Guarantor; Being a Syndicate of Banks Whose Lead Bank is Citibank N.A. Brussels Branch
    Transaktionen
    • 04. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    A registered definitive note (the "note")
    Erstellt am 07. Nov. 1997
    Geliefert am 25. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "note"
    Kurze Angaben
    All rights title and interest in and to the swap transaction (as defined) including the benefit of the security therefor over the underlying assets (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • R+V Lebensversicherung Ag
    Transaktionen
    • 25. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Registered definitive note
    Erstellt am 29. Okt. 1997
    Geliefert am 17. Nov. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and other liabilities due or to become due from the company to the chargee under the note
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the swap transaction (as defined in the schedule to form 395) including the benefit of the security therefor over the underlying assets (as defined in the schedule) please refer to form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • R+V Lebensversicherung Ag
    Transaktionen
    • 17. Nov. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Sept. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Cibc share charge
    Erstellt am 08. Okt. 1997
    Geliefert am 22. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from dudley waste services limited to the chargee under or pursuant to the secured documents
    Kurze Angaben
    As a continuing security the charged shares by way of first legal mortgage and a first fixed charge and by way of first fixed charge the charged accrued share assets meaning all rights,monies,benefits and other property which may at any time accrue or be offered or arise by way of conversion,redemption,bonus,preference,option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Cibc share charge
    Erstellt am 08. Okt. 1997
    Geliefert am 22. Okt. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from wolverhampton waste services limited to the chargee under or pursuant to the secured documents
    Kurze Angaben
    As a continuing security the charged shares by way of first legal mortgage and a first fixed charge and by way of first fixed charge the charged accrued share assets meaning all rights,monies,benefits and other property which may at any time accrue or be offered or arise by way of conversion,redemption,bonus,preference,option or otherwise in respect of any of the shares or in substitution or exchange for any of the shares.
    Berechtigte Personen
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Dez. 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Collateral agreement
    Erstellt am 19. März 1996
    Geliefert am 22. März 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in whatever form that relates to the company's use of the euroclear system
    Kurze Angaben
    All collateral including cash securities and clearance accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transaktionen
    • 22. März 1996Registrierung einer Belastung (395)

    Hat CIBC WORLD MARKETS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Feb. 2021Beginn der Liquidation
    04. Feb. 2021Erklärung der Zahlungsfähigkeit geleistet am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Howard Smith
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praktiker
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praktiker
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0