ZOFFANY HOTELS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameZOFFANY HOTELS LIMITED
    UnternehmensstatusLiquidation
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02734955
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ZOFFANY HOTELS LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich ZOFFANY HOTELS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    C/O BDO LLP
    5 Temple Square Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ZOFFANY HOTELS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    MANAGEMENT SERVICES INTERNATIONAL LIMITED02. Apr. 199302. Apr. 1993
    EMELF LIMITED28. Juli 199228. Juli 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ZOFFANY HOTELS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am31. Dez. 2013
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Sept. 2014
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ZOFFANY HOTELS LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis17. Juli 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung31. Juli 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für ZOFFANY HOTELS LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für ZOFFANY HOTELS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2024

    32 SeitenLIQ03
    YD2832VP

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2023

    29 SeitenLIQ03
    YC1QW076

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    17 SeitenLIQ10
    YBHR09MB

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600
    YBGXRB7M

    Beendigung der Bestellung von James Stephen Brent als Geschäftsführer am 04. Aug. 2022

    1 SeitenTM01
    AB9U6TR6

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2022

    29 SeitenLIQ03
    YB3DNJ8B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Two Snowhill Birmingham B4 6GA zum 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH am 11. Okt. 2021

    2 SeitenAD01
    YAEN8IUW

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600
    YA4Z3QUZ

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2021

    28 SeitenLIQ03
    YA3HBILA

    Tod eines Liquidators

    3 SeitenLIQ09
    Y9K16RUI

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2020

    29 SeitenLIQ03
    A9451SND

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2019

    27 SeitenLIQ03
    A84QZWCH

    Insolvenzmeldung

    INSOLVENCY:Sec of State cert release for Shay Bannon
    3 SeitenLIQ MISC
    A79BB3EO

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2018

    24 SeitenLIQ03
    A75C555C

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600
    A74C1REG

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    6 SeitenLIQ10
    A74C1REP

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 SeitenLIQ MISC
    A6I84XOA

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600
    A6E0GKF7

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    18 SeitenLIQ10
    A6E388UH

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2017

    28 Seiten4.68
    A65RA1EQ

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:s/s cert. Release of liquidator
    1 SeitenLIQ MISC
    A5KP7FE9

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600
    A5FMILR7

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40
    A5FMILRF

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 05. März 2016

    24 Seiten4.68
    A57A8OC3

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 125 Colmore Row Birmingham B3 3SD zum Two Snowhill Birmingham B4 6GA am 03. Jan. 2016

    2 SeitenAD01
    A4MLDHMJ

    Wer sind die Geschäftsführer von ZOFFANY HOTELS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WELBOURN, Philip Matthew
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    Geschäftsführer
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    United KingdomBritishCompany Director135168350001
    AKKERON HOTELS GROUP LIMITED
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer07455285
    185890430001
    BOOTE, Robert Edward
    61 Efford Way
    Pennington
    SO41 8DA Lymington
    Hampshire
    Sekretär
    61 Efford Way
    Pennington
    SO41 8DA Lymington
    Hampshire
    British5533200001
    CAVEN, Niall
    Abbey Wells House
    Woolton Hill
    RG20 9UW Newbury
    Berkshire
    Sekretär
    Abbey Wells House
    Woolton Hill
    RG20 9UW Newbury
    Berkshire
    British35829160002
    LEWIS, David Richard
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Sekretär
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    BritishFinance Director5754090003
    EMCO (NOMINEES) LIMITED
    10th Floor
    One America Square Crosswall
    EC3N 2PR London
    Sekretär
    10th Floor
    One America Square Crosswall
    EC3N 2PR London
    84871930001
    BRENT, James Stephen
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    Geschäftsführer
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    5 Temple Square
    EnglandBritishNone146907760002
    CAVEN, Niall
    Abbey Wells House
    Woolton Hill
    RG20 9UW Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Abbey Wells House
    Woolton Hill
    RG20 9UW Newbury
    Berkshire
    BritishAccountant35829160002
    COLLINS, Peter Edward
    The Keep 10 Monastery Avenue
    CT16 1AB Dover
    Kent
    Geschäftsführer
    The Keep 10 Monastery Avenue
    CT16 1AB Dover
    Kent
    BritishManagement Consultant66360160001
    COLLINS, Robin Evan
    Old House
    Lyndhurst Road
    BH24 4HU Burley
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Old House
    Lyndhurst Road
    BH24 4HU Burley
    Hampshire
    EnglandBritishHotelier5533210001
    CRAWLEY, Nicholas Davd Townsend
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    Geschäftsführer
    Richmond Hill
    TW10 6RP Richmond Upon Thames
    Richmond Gate Hotel
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director146568590001
    CRAWLEY, Nicholas David Townsend
    Harris Business Park, Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4JJ Bromsgrove
    Hanbury Court
    Worcestershire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Harris Business Park, Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4JJ Bromsgrove
    Hanbury Court
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandEnglishCompany Director96980780001
    CROFT, Christopher Rendell
    32 Vardens Road
    SW11 1RH London
    Geschäftsführer
    32 Vardens Road
    SW11 1RH London
    BritishSolicitor3372940001
    EDWARDS, John Richard Martin
    Phyllis Court Club Marlow Road
    RG9 2HT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Phyllis Court Club Marlow Road
    RG9 2HT Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishConsultant56126440001
    FIELD, Robin Anthony
    52 Cole Park Road
    TW1 1HS Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    52 Cole Park Road
    TW1 1HS Twickenham
    Middlesex
    EnglandBritishMerchant3430350002
    GREIG, Philip John
    43 Marryat Road
    SW19 5BW London
    Geschäftsführer
    43 Marryat Road
    SW19 5BW London
    EnglandBritishSolicitor2490730001
    KOCH, Richard John
    3 Richmond Bridge Moorings
    Willoughby Road
    TW1 2QG Twickenham
    London
    Geschäftsführer
    3 Richmond Bridge Moorings
    Willoughby Road
    TW1 2QG Twickenham
    London
    BritishCompany Director16022920002
    KOCH, Richard John
    4 Ennismore Mews
    Knightsbridge
    SW7 1AN London
    Geschäftsführer
    4 Ennismore Mews
    Knightsbridge
    SW7 1AN London
    BritishCompany Director16022920001
    LEWIS, David Richard
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Wildwood House Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director5754090003
    MURPHY, John Matthew
    57 Noel Road
    N1 8HE London
    Geschäftsführer
    57 Noel Road
    N1 8HE London
    EnglandBritishCompany Director67032160002
    MURRAY, Alan John
    Harris Business Park, Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4JJ Bromsgrove
    Hanbury Court
    Worcestershire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Harris Business Park, Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4JJ Bromsgrove
    Hanbury Court
    Worcestershire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director104826920002
    SONLEY, Nicholas Peter
    The Dell Wood Lane
    South Heath
    HP16 0RB Great Missenden
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Dell Wood Lane
    South Heath
    HP16 0RB Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishHotel Consultant38471250001

    Hat ZOFFANY HOTELS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage
    Erstellt am 12. Nov. 2012
    Geliefert am 15. Nov. 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 29 knyveton road bournemouth dorset together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Nov. 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 06. Jan. 2011
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the properties,second fixed charge all present and future interest of the company in or over f/h and l/h property,all present and future rights licences guarantees rents deposits contracts covenants and warranties see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Robin Evan Collins
    Transaktionen
    • 06. Jan. 2011Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Aug. 2013Teilweise Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H roebuck hotel baldock street ware hertfordshire t/no'HD134422 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H rutland square hotel rutland square standard hill nottingham 4 standard hill nottingham and the looms friar lane nottingham t/no;s NT173285,NT220787,NT19852 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H arno's court bath road brislinton and lying to the south of bath road brislington t/no'AV29095 AV81899 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H royal cambridge hotel trumpington street cambridge together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Teilweise erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 15. Aug. 2013Teilweise Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed to secure own liabilities
    Erstellt am 22. Dez. 2010
    Geliefert am 29. Dez. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    L/H land 27 and 29 knyveton road bournemouth and the f/h land being 31 and 33 knyveton road bournemouth t/no:DT197452( l/h ) DT61921 (f/h) together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 11. Juli 2013Teilweise Erfüllung einer Belastung (MR04)
    • 15. Aug. 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Okt. 2002
    Geliefert am 16. Okt. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold property known as 27 and 29 knyveton road,bournemouth and the f/hold property known as 31-33 knyveton road,bournemouth; t/nos DT197452 and DT61921. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 16. Okt. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the leasehold property situate and known as arno's court and land lying to the south side of bath road brislington t/n's AV29095 and AV81899. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the freehold property situate and known as canons hotel baldock street ware t/n HD134422. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the leasehold property situate and known as the royal cambridge hotel 6-12 scroope terrace cambridge. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the freehold property situate and known as the goddard arms hotel and 43 & 44 cricklade street swindon t/n WT84391. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Okt. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the freehold property situate and known as rutland square hotel rutland square standard hill nottingham t/n's NT173285, NT19853 and NT220787. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the leasehold property situate and known as unit 35 kingfisher court hambridge road newbury t/n BK281829. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Juni 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Aug. 2002
    Geliefert am 09. Aug. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the leasehold property situate and known as 27 and 29 knyventon road bournemouth t/n's DT197452 and DT61921. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Nov. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Sept. 2000
    Geliefert am 07. Okt. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a arno's court hotel bath road brislington bristol t/n's AV29095 and AV81899. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Okt. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Jan. 2000
    Geliefert am 01. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a westcliff hotel parade westcliff on sea essex t/no EX245219. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Okt. 1999
    Geliefert am 12. Okt. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Quueens moat house hotel knyveton road bournemouth dorset t/nos DT197452 and DT61921. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Okt. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 14. Juni 1999
    Geliefert am 18. Juni 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The l/h property k/a 35 kingfisher court newbury berkshire t/n BK281829. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 16. März 1999
    Geliefert am 02. Apr. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £200,000 plus vat (if applicable) and interest at the rate of 2% above the base rate for the time being of national westminster bank PLC in respect of the period from the due date, 16 september 1999, until the date of actual payment, plus all costs and expenses incurred by the chargee or any receiver appointed by the chargee in enforcing the security constituted by the legal charge
    Kurze Angaben
    F/H the county hotel highfield lane portswood southampton hampshire SO17 1AQ t/n-HP190825 and the proceeds of the disposal of the same and all rights title and interests therein.
    Berechtigte Personen
    • County Hotels Limited
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 1999
    Geliefert am 19. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The county hotel,baldock st,ware,hertfordshire; t/no hd 134422; the goodwill of business and benefit of all licences; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 16. März 1999
    Geliefert am 19. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The county hotel,highfield,portwood,southampton,hampshire; t/no hp 190825; the goodwill of business and benefits of all licences; see form 395. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Aug. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat ZOFFANY HOTELS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    07. März 2014Beginn der Verwaltung
    06. März 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    James Joseph Bannon
    Bdo Llp 125 Colmore Row
    B3 3SD Brimingham
    Praktiker
    Bdo Llp 125 Colmore Row
    B3 3SD Brimingham
    2
    DatumTyp
    06. März 2015Beginn der Liquidation
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Francis Graham Newton
    6th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    6th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Antony David Nygate
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Lee Causer
    Bdo Llp Two Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp Two Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Praktiker
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Christopher Kim Rayment
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    Vorgeschlagener Liquidator
    Bdo Llp
    125 Colmore Row
    B3 3SD Birmingham
    James Joseph Bannon
    Bdo Llp 125 Colmore Row
    B3 3SD Brimingham
    Vorgeschlagener Liquidator
    Bdo Llp 125 Colmore Row
    B3 3SD Brimingham
    Ian James Gould
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0