EUROBELL CPE LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEUROBELL CPE LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 02742145
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EUROBELL CPE LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich EUROBELL CPE LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Media House
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Hampshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EUROBELL CPE LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EUROBELL COMMUNICATIONS LIMITED 30. Apr. 199330. Apr. 1993
    EUROBELL (HOLDINGS) LIMITED21. Aug. 199221. Aug. 1992

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EUROBELL CPE LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für EUROBELL CPE LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    legacy

    97 SeitenPARENT_ACC

    legacy

    1 SeitenAGREEMENT1

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Aug. 2013

    Kapitalaufstellung am 27. Aug. 2013

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    legacy

    3 SeitenGUARANTEE1

    Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013

    2 SeitenCH01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Christine Tillbrook als Geschäftsführer am 31. Dez. 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers als Direktor am 31. Dez. 2012

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    4 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Joanne Christine Tillbrook als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Robert Mario Mackenzie als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 21. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    3 SeitenAR01

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 160 Great Portland Street London W1W 5QA am 04. Apr. 2011

    1 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von EUROBELL CPE LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Sekretär
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    151025070001
    GALE, Robert Charles
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant96956740001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor140137570002
    BALDERSON, Denise Anne
    6 Rosewood Court
    35 Orchard Road
    BR1 2TT Bromley
    Kent
    Sekretär
    6 Rosewood Court
    35 Orchard Road
    BR1 2TT Bromley
    Kent
    BritishAccountant82293840001
    BLANKFIELD, Andrew Morris
    14 Hall Place Gardens
    AL1 3SP St. Albans
    Hertfordshire
    Sekretär
    14 Hall Place Gardens
    AL1 3SP St. Albans
    Hertfordshire
    British81192720001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Sekretär
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    MARKHAM, Gail Carolyn
    The Sycamores
    36 Alvaston Street
    DE24 0NX Alvaston
    Derby
    Sekretär
    The Sycamores
    36 Alvaston Street
    DE24 0NX Alvaston
    Derby
    British44160570001
    RICHARDS, Allan
    12 Thistle Grove
    SW10 9RZ London
    Sekretär
    12 Thistle Grove
    SW10 9RZ London
    BritishGroup Legal Director55171600002
    RICHARDS, Allan
    3 Stewarts Grove
    SW3 6PD London
    Sekretär
    3 Stewarts Grove
    SW3 6PD London
    BritishCompany Secretary55171600001
    WILLIAMS, Glenn Bernard Douglas
    12 Lowry Close
    College Town
    GU47 0FJ Sandhurst
    Berkshire
    Sekretär
    12 Lowry Close
    College Town
    GU47 0FJ Sandhurst
    Berkshire
    British63412650001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Bevollmächtigter Sekretär
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Sekretär
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BARNES, Richard Nigel
    42 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    Geschäftsführer
    42 Victoria Avenue
    KT6 5DW Surbiton
    Surrey
    BritishAccountant5240090001
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Geschäftsführer
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-AmericanManaging Director52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Geschäftsführer
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    BritishSolicitor73000530008
    CORNISH, Alan Stewart
    Aspens 42 Oxenden Wood Road
    BR6 6HP Orpington
    Kent
    Geschäftsführer
    Aspens 42 Oxenden Wood Road
    BR6 6HP Orpington
    Kent
    BritishDirector2757380001
    FREEDMAN, Philip Zachary
    98 Highgate Hill
    N6 5HE London
    Geschäftsführer
    98 Highgate Hill
    N6 5HE London
    AmericanFinance Director73535900001
    HOFMANN, Klaus
    Meineckestrasse 46
    D40474 Duesseldorf
    Germany
    Geschäftsführer
    Meineckestrasse 46
    D40474 Duesseldorf
    Germany
    GermanEvp69180580001
    HOOLE, Peter David
    The Small House
    High St Sherington
    MK16 9NB Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    The Small House
    High St Sherington
    MK16 9NB Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director13747930001
    LAQUA, Markus Josef
    23 Hatchlands
    RH12 5JX Horsham
    West Sussex
    Geschäftsführer
    23 Hatchlands
    RH12 5JX Horsham
    West Sussex
    GermanCompany Director43624140002
    LINKE, Rainer
    Berliner Ring 22
    53175 Bonn
    Northrine Westfalia
    Germany
    Geschäftsführer
    Berliner Ring 22
    53175 Bonn
    Northrine Westfalia
    Germany
    GermanLegal Advisor46999490001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Great Portland Street
    W1W 5QA London
    160
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor47785600002
    MARKHAM, Gail Carolyn
    The Stable Old Mint House
    Upper Cratton
    RH2 0TY Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Stable Old Mint House
    Upper Cratton
    RH2 0TY Reigate
    Surrey
    BritishCompany Director44160570002
    RICHARDS, Allan
    3 Stewarts Grove
    SW3 6PD London
    Geschäftsführer
    3 Stewarts Grove
    SW3 6PD London
    BritishSolicitor55171600001
    RIDLEY, Malcolm James
    Moor Lodge
    Horsham Road Holmwood
    RH5 4NA Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Moor Lodge
    Horsham Road Holmwood
    RH5 4NA Dorking
    Surrey
    EnglandBritishAccountant7557430001
    ROBINSON, Alan Stuart Macdonald
    The Stable, Old Mint House
    Upper Gatton
    RH2 0TY Reigate
    Geschäftsführer
    The Stable, Old Mint House
    Upper Gatton
    RH2 0TY Reigate
    BritishManaging Director94679630001
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    BritishFinance Director79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Geschäftsführer
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    BritishDirector8281170001
    THOMAS, David
    Middle Barn Lower Barns Farm
    Wall
    NE6 4DR Hexham
    Northumberland
    Geschäftsführer
    Middle Barn Lower Barns Farm
    Wall
    NE6 4DR Hexham
    Northumberland
    BritishManaging Director35030200001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritishSolicitor164134250001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Bevollmächtigter Geschäftsführer
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Geschäftsführer
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    Hat EUROBELL CPE LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Composite debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 08. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 08. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Confirmation deed
    Erstellt am 15. Apr. 2010
    Geliefert am 04. Mai 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transaktionen
    • 04. Mai 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 06. Sept. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 19. Jan. 2010
    Geliefert am 22. Jan. 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 22. Jan. 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 28. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 03. März 2006
    Geliefert am 10. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 10. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2010Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 24. Mai 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Composite debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2004
    Geliefert am 23. Dez. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 28. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of the company in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 28. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    New composite guarantee and debenture
    Erstellt am 14. Juli 2004
    Geliefert am 22. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of tcn in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC in Its Capacity as New Security Trustee for the New Beneficiaries
    Transaktionen
    • 22. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A supplemental deed made between (1) eurobell (holdings) limited, (2) telewest communications networks limited, (3) cibc worlds markets PLC and (4) telewest communications PLC pursuant to which, inter alia the company accedes to a guarantee and debenture dated 16 march 2001 and
    Erstellt am 15. Feb. 2002
    Geliefert am 21. Feb. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any of the chargors to the security trustee and any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All its right, title and/or interest in all stocks and shares whatsoever whether marketable or otherwise and all other interests (including but not limited to loan capital) including all allotments, rights, benefits and advantages whatsoever at any time accruing. The loan stock, all amounts payable, the intercompany loan. By way of floating charge all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, other than any property or assets from time to time charged by way of fixed charge or assignment above.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Cibc World Markets PLC (In Its Capacity as Security Trustee for Thebeneficiaries)
    Transaktionen
    • 21. Feb. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 1996
    Geliefert am 03. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Meespierson N.V.
    Transaktionen
    • 03. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of confirmation and variation
    Erstellt am 13. Feb. 1996
    Geliefert am 16. Feb. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    And varying the terms of a debenture dated 22ND december 1995
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Meespierson N.V.
    Transaktionen
    • 16. Feb. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Aug. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Dez. 1995
    Geliefert am 05. Jan. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any "security documents" (as defined therein)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Meespierson N.V.
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 10. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0