EUROBELL CPE LIMITED
Überblick
Unternehmensname | EUROBELL CPE LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 02742145 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von EUROBELL CPE LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich EUROBELL CPE LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Media House Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Hampshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von EUROBELL CPE LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
EUROBELL COMMUNICATIONS LIMITED | 30. Apr. 1993 | 30. Apr. 1993 |
EUROBELL (HOLDINGS) LIMITED | 21. Aug. 1992 | 21. Aug. 1992 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EUROBELL CPE LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für EUROBELL CPE LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
legacy | 97 Seiten | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | AGREEMENT1 | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 Seiten | GUARANTEE1 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Caroline Bernadette Elizabeth Withers am 14. März 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Christine Tillbrook als Geschäftsführer am 31. Dez. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Caroline Bernadette Elizabeth Withers als Direktor am 31. Dez. 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Christine Tillbrook als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Mario Mackenzie als Geschäftsführer am 16. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Joanne Christine Tillbrook als Direktor am 16. Sept. 2011 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 21. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 160 Great Portland Street London W1W 5QA am 04. Apr. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von EUROBELL CPE LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAMES, Gillian Elizabeth | Sekretär | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | 151025070001 | |||||||
GALE, Robert Charles | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | England | British | Accountant | 96956740001 | ||||
WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | Solicitor | 140137570002 | ||||
BALDERSON, Denise Anne | Sekretär | 6 Rosewood Court 35 Orchard Road BR1 2TT Bromley Kent | British | Accountant | 82293840001 | |||||
BLANKFIELD, Andrew Morris | Sekretär | 14 Hall Place Gardens AL1 3SP St. Albans Hertfordshire | British | 81192720001 | ||||||
BURNS, Clive | Sekretär | The Cottage Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood AL4 8RX Wheathampstead Hertfordshire | British | 71073800001 | ||||||
MARKHAM, Gail Carolyn | Sekretär | The Sycamores 36 Alvaston Street DE24 0NX Alvaston Derby | British | 44160570001 | ||||||
RICHARDS, Allan | Sekretär | 12 Thistle Grove SW10 9RZ London | British | Group Legal Director | 55171600002 | |||||
RICHARDS, Allan | Sekretär | 3 Stewarts Grove SW3 6PD London | British | Company Secretary | 55171600001 | |||||
WILLIAMS, Glenn Bernard Douglas | Sekretär | 12 Lowry Close College Town GU47 0FJ Sandhurst Berkshire | British | 63412650001 | ||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Bevollmächtigter Sekretär | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 | |||||||
BARNES, Richard Nigel | Geschäftsführer | 42 Victoria Avenue KT6 5DW Surbiton Surrey | British | Accountant | 5240090001 | |||||
BURDICK, Charles James | Geschäftsführer | 9 Ormonde Place SW1W 8HX London | British-American | Managing Director | 52311710004 | |||||
COOK, Stephen Sands | Geschäftsführer | 24a Redcliffe Square SW10 9JY London | British | Solicitor | 73000530008 | |||||
CORNISH, Alan Stewart | Geschäftsführer | Aspens 42 Oxenden Wood Road BR6 6HP Orpington Kent | British | Director | 2757380001 | |||||
FREEDMAN, Philip Zachary | Geschäftsführer | 98 Highgate Hill N6 5HE London | American | Finance Director | 73535900001 | |||||
HOFMANN, Klaus | Geschäftsführer | Meineckestrasse 46 D40474 Duesseldorf Germany | German | Evp | 69180580001 | |||||
HOOLE, Peter David | Geschäftsführer | The Small House High St Sherington MK16 9NB Newport Pagnell Buckinghamshire | England | British | Company Director | 13747930001 | ||||
LAQUA, Markus Josef | Geschäftsführer | 23 Hatchlands RH12 5JX Horsham West Sussex | German | Company Director | 43624140002 | |||||
LINKE, Rainer | Geschäftsführer | Berliner Ring 22 53175 Bonn Northrine Westfalia Germany | German | Legal Advisor | 46999490001 | |||||
MACKENZIE, Robert Mario | Geschäftsführer | Great Portland Street W1W 5QA London 160 London United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 47785600002 | ||||
MARKHAM, Gail Carolyn | Geschäftsführer | The Stable Old Mint House Upper Cratton RH2 0TY Reigate Surrey | British | Company Director | 44160570002 | |||||
RICHARDS, Allan | Geschäftsführer | 3 Stewarts Grove SW3 6PD London | British | Solicitor | 55171600001 | |||||
RIDLEY, Malcolm James | Geschäftsführer | Moor Lodge Horsham Road Holmwood RH5 4NA Dorking Surrey | England | British | Accountant | 7557430001 | ||||
ROBINSON, Alan Stuart Macdonald | Geschäftsführer | The Stable, Old Mint House Upper Gatton RH2 0TY Reigate | British | Managing Director | 94679630001 | |||||
SMITH, Neil Reynolds | Geschäftsführer | Brettwood Green Lane Churt GU10 2PA Farnham Surrey | British | Finance Director | 79956240002 | |||||
STENHAM, Anthony William Paul | Geschäftsführer | 4 The Grove Highgate N6 6JU London | British | Director | 8281170001 | |||||
THOMAS, David | Geschäftsführer | Middle Barn Lower Barns Farm Wall NE6 4DR Hexham Northumberland | British | Managing Director | 35030200001 | |||||
TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | Solicitor | 164134250001 | ||||
TILLBROOK, Joanne Christine | Geschäftsführer | Bartley Wood Business Park RG27 9UP Hook Media House Hampshire | United Kingdom | British | Solicitor | 164134250001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Bevollmächtigter Geschäftsführer | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107430002 | |||||||
VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED | Geschäftsführer | 160 Great Portland Street W1W 5QA London | 101107380002 |
Hat EUROBELL CPE LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Composite debenture | Erstellt am 29. Juni 2010 Geliefert am 08. Juli 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Confirmation deed | Erstellt am 15. Apr. 2010 Geliefert am 04. Mai 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 19. Jan. 2010 Geliefert am 22. Jan. 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 03. März 2006 Geliefert am 10. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite debenture | Erstellt am 21. Dez. 2004 Geliefert am 23. Dez. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
New composite guarantee and debenture | Erstellt am 14. Juli 2004 Geliefert am 28. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of the company in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
New composite guarantee and debenture | Erstellt am 14. Juli 2004 Geliefert am 22. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben A first equitable charge over the stocks, shares and any other interests of tcn in front row television LTD, any tcn entity or any joint venture. A first floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A supplemental deed made between (1) eurobell (holdings) limited, (2) telewest communications networks limited, (3) cibc worlds markets PLC and (4) telewest communications PLC pursuant to which, inter alia the company accedes to a guarantee and debenture dated 16 march 2001 and | Erstellt am 15. Feb. 2002 Geliefert am 21. Feb. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any of the chargors to the security trustee and any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All its right, title and/or interest in all stocks and shares whatsoever whether marketable or otherwise and all other interests (including but not limited to loan capital) including all allotments, rights, benefits and advantages whatsoever at any time accruing. The loan stock, all amounts payable, the intercompany loan. By way of floating charge all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, other than any property or assets from time to time charged by way of fixed charge or assignment above.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 26. Juli 1996 Geliefert am 03. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of confirmation and variation | Erstellt am 13. Feb. 1996 Geliefert am 16. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag And varying the terms of a debenture dated 22ND december 1995 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. Dez. 1995 Geliefert am 05. Jan. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any "security documents" (as defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0